ENGLISH SEAFOODS LIMITED

ENGLISH SEAFOODS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàENGLISH SEAFOODS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02353338
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ENGLISH SEAFOODS LIMITED?

    • Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi (10200) / Industrie manifatturiere
    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova ENGLISH SEAFOODS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ENGLISH SEAFOODS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PINEGAIN LIMITED28 feb 198928 feb 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di ENGLISH SEAFOODS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per ENGLISH SEAFOODS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 lug 2021

    6 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    42 pagine600

    Dimissioni di un liquidatore

    3 pagineLIQ06

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Kpmg Llp 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH a 1 st. Peters Square Manchester M2 3AE in data 07 mag 2021

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Ross House Wickham Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3SW a 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH in data 15 ago 2020

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 10 lug 2020

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 30 mar 2020

    • Capitale: GBP 2
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduce capital redemption reserve 18/03/2020
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Jenny Nancy Loncaster come amministratore in data 25 set 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Timothy Mark Busby come amministratore in data 12 set 2019

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2019 al 31 mar 2020

    1 pagineAA01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Wilkin Chapman Llp New Oxford House Town Hall Square Grimsby North East Lincolnshire DN31 1HE a Karro Food Group Hugden Way, Norton Grove Industrial Estate Norton Malton North Yorkshire YO17 9HG

    1 pagineAD02

    Nomina di Mr Michael Kamiel Jan Alfons Kestemont come amministratore in data 04 lug 2019

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Wilkin Chapman Company Secretarial Services Limited come segretario in data 04 lug 2019

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del segretario cambiati per Wilkin Chapman Company Secretarial Services Limited il 02 gen 2017

    1 pagineCH04

    Chi sono gli amministratori di ENGLISH SEAFOODS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KESTEMONT, Michael Kamiel Jan Alfons
    St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    1
    Amministratore
    St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    1
    United KingdomBelgian231792890001
    CHEESEMAN, David Benjamin
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    Segretario
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    British1031110002
    WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Segretario
    Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02249348
    75197930001
    BERRY, Peter Sidney
    18 St Georges Place
    The Mount
    YO2 2DR York
    North Yorkshire
    Amministratore
    18 St Georges Place
    The Mount
    YO2 2DR York
    North Yorkshire
    British48690810001
    BRITTON, Christopher Paul
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    Amministratore
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    United KingdomBritish127835580001
    BUSBY, Timothy Mark
    Ross House
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    Ross House
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    North East Lincolnshire
    EnglandEnglish169852920001
    CHEESEMAN, David Benjamin
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    Amministratore
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    EnglandBritish1031110002
    DEE, Frank Rigby
    4 West View
    LS29 9JG Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    4 West View
    LS29 9JG Ilkley
    West Yorkshire
    British780440002
    DEN HOLLANDER, Leendert Pieter
    Ross House
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    Ross House
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    North East Lincolnshire
    EnglandDutch166335910001
    DOWDS, Robert Joseph
    Clifton Lea 26 Clifton Road
    LS29 8TU Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Clifton Lea 26 Clifton Road
    LS29 8TU Ilkley
    West Yorkshire
    British4094070001
    EVANS, Thomas Jeffrey
    Tudor Lodge
    308 Beverley Road Anlaby
    HU10 7BG Hull
    Amministratore
    Tudor Lodge
    308 Beverley Road Anlaby
    HU10 7BG Hull
    EnglandBritish2183390002
    GRIFFITHS, Wynne Philip Morgan
    Hawerby Hall
    DN36 5PX Hawerby Cum Beesby
    Lincolnshire
    Amministratore
    Hawerby Hall
    DN36 5PX Hawerby Cum Beesby
    Lincolnshire
    United KingdomBritish58713750002
    HARKJAER, Per
    Oakridge House
    6 Montrose Gardens Oxshott
    KT22 0UU Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Oakridge House
    6 Montrose Gardens Oxshott
    KT22 0UU Leatherhead
    Surrey
    EnglandDanish127032620001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Amministratore
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritish84487230001
    LOFTS, Malcolm Herbert
    Ross House
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    Ross House
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    North East Lincolnshire
    EnglandBritish177239110001
    LONCASTER, Jenny Nancy
    Ross House
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    Ross House
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    North East Lincolnshire
    EnglandBritish205633180001
    MARR, Andrew Leslie
    62 North Bar Without
    HU17 7AB Beverley
    East Yorkshire
    Amministratore
    62 North Bar Without
    HU17 7AB Beverley
    East Yorkshire
    United KingdomBritish2893450001
    PARKER, Michael
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    Amministratore
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    United KingdomBritish2785890001
    RAINES, Gerald Hector
    19 Marlborough Way
    Country Park
    DN35 0TR Cleethorpes
    South Humberside
    Amministratore
    19 Marlborough Way
    Country Park
    DN35 0TR Cleethorpes
    South Humberside
    British44675880002
    VICKERS, David
    89 Northfield
    Swanland
    HU14 3RE Hull
    Amministratore
    89 Northfield
    Swanland
    HU14 3RE Hull
    British2183410001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ENGLISH SEAFOODS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    England
    06 apr 2016
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03751665
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    ENGLISH SEAFOODS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 23 ott 2008
    Consegnato il 01 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties
    Transazioni
    • 01 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Share pledge
    Creato il 22 ott 2008
    Acquisito il 24 giu 2011
    Consegnato il 11 lug 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    (1) ordinary share in merson and gerry limited company registered in scotland with registration number SC025368.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 11 lug 2011Registrazione di un'acquisizione (MG06)
    • 19 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Share pledge
    Creato il 22 ott 2008
    Consegnato il 05 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Its whole right, title, interest and benefit in and to the charged assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Security Agent for Each of the Secured Parties (The Security Agent)
    Transazioni
    • 05 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 21 mar 2007
    Consegnato il 31 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale the Security Agent
    Transazioni
    • 31 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 mar 2006
    Consegnato il 25 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties (The 'Security Agent')
    Transazioni
    • 25 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 dic 2005
    Consegnato il 17 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All material premises being f/h interest in land to the east of havelock street, kingston upon hull, land on the west side of gillett street and land and buildings on the south west side of gillett street, t/no's HS288261, HS169179, HS169178, HS288266 and HS270470; f/h interest in land and buildings on the south side of the scarborough street, kingston upon hull, t/no HS241523; f/h interest in land and buildings on the north east side of wassand street, kingston upon hull, t/no HS185727, together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale (The Security Agent)
    Transazioni
    • 17 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security accession deed
    Creato il 30 giu 2004
    Consegnato il 10 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    With full title guarantee, both present and future by way of first legal mortgage the property specified in schedule 1 to the accession deed, together with all buildings and fixtures and all the subsidiary shares and investments specified in schedule 2 to the accession deed;.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The Securityagent)
    Transazioni
    • 10 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage deed
    Creato il 12 ago 2003
    Consegnato il 14 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a or being 95-97 wassand street hull HU3 4AL t/n HS185727. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage deed
    Creato il 10 giu 2003
    Consegnato il 12 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a or being land on the south side of scarborough street and liverpool street hessle road hull HU3 4UU t/n HS241523 city of kingston upon hull. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage deed
    Creato il 10 giu 2003
    Consegnato il 12 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as or being pinegain house gillet street/havelock st hull HU3 4JG title numbers HS169179,HS169178,HS288266 and HS270470. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 02 mag 2003
    Consegnato il 15 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture deed
    Creato il 02 mag 2003
    Consegnato il 14 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 apr 2000
    Consegnato il 11 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as premises on the west side of gillett street, hull.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 apr 2000
    Consegnato il 11 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as land and buildings on the south west side of gillett street hull title number HS270470.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 apr 2000
    Consegnato il 11 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as land to the east of havelock street hull title number HS169179.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 apr 2000
    Consegnato il 11 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as land to the east of havelock street hull title number HS169178.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 apr 2000
    Consegnato il 11 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as land and buildings on the south side of scarborough street hull title number HS241523.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 apr 2000
    Consegnato il 11 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as land to the east of havelock street hull title number HS169178.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 apr 2000
    Consegnato il 11 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property being land on the corner of west dock street and gillett street, hull.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 apr 2000
    Consegnato il 08 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as land and buildings on the south side of scarborough street hull title number HS241523.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 08 nov 1996
    Consegnato il 18 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 apr 1989
    Consegnato il 28 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See doc for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Natwest Investment Bank Limited
    Transazioni
    • 28 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 20 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 14 apr 1989
    Consegnato il 26 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or marr frozen foods limited to the chargee on any account whatever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 apr 1989
    Consegnato il 20 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Stock in trade work-in-progress.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 20 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 20 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 apr 1989
    Consegnato il 19 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Andrew Marr International Limited
    Transazioni
    • 19 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 20 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ENGLISH SEAFOODS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    10 lug 2020Inizio della liquidazione
    13 gen 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nicholas James Timpson
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Praticante
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Mark Jeremy Orton
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Praticante
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0