H & H FINE WINES LIMITED

H & H FINE WINES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàH & H FINE WINES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02353346
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di H & H FINE WINES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova H & H FINE WINES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 328/9 Metalbox Factory 30 Great Guildford Street
    SE1 0HS London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di H & H FINE WINES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HECTOR AND HONOREZ WINES LIMITED28 feb 198928 feb 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di H & H FINE WINES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per H & H FINE WINES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Woolyard 54 Bermondsey Street London SE1 3UD a Unit 328/9 Metalbox Factory 30 Great Guildford Street London SE1 0HS in data 05 dic 2019

    1 pagineAD01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2018

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2017

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Jonathan David Worsley come amministratore in data 25 gen 2018

    2 pagineAP01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mar 2017 al 30 set 2017

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    4 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Samantha Jayne Tuson Taylor il 09 nov 2016

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 18 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 giu 2016

    Stato del capitale al 27 giu 2016

    • Capitale: GBP 40,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2015

    3 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio annuale redatto al 18 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 nov 2015

    Stato del capitale al 05 nov 2015

    • Capitale: GBP 40,000
    SH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 lug 2014

    Stato del capitale al 07 lug 2014

    • Capitale: GBP 40,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2013

    4 pagineAA

    Nomina di Mr Simon Christopher Johnson come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Samantha Jayne Tuson Taylor come segretario

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di Andrew Lavery come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Lavery come segretario

    2 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di H & H FINE WINES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GHYSEN, Samantha Jayne
    54 Bermondsey Street
    SE1 3UD London
    Woolyard
    Segretario
    54 Bermondsey Street
    SE1 3UD London
    Woolyard
    British183540480002
    DE HAAN, Peter Charles
    30 Great Guildford Street
    SE1 0HS London
    Unit 328/9 Metalbox Factory
    England
    Amministratore
    30 Great Guildford Street
    SE1 0HS London
    Unit 328/9 Metalbox Factory
    England
    United KingdomBritish32531270009
    JOHNSON, Simon Christopher
    30 Great Guildford Street
    SE1 0HS London
    Unit 328/9 Metalbox Factory
    England
    Amministratore
    30 Great Guildford Street
    SE1 0HS London
    Unit 328/9 Metalbox Factory
    England
    EnglandBritish110558260001
    WORSLEY, Jonathan David
    30 Great Guildford Street
    SE1 0HS London
    Unit 328/9 Metalbox Factory
    England
    Amministratore
    30 Great Guildford Street
    SE1 0HS London
    Unit 328/9 Metalbox Factory
    England
    EnglandBritish113877690002
    HONOREZ, Christian Pierre
    29 Hollow Lane
    Ramsey
    PE17 1DE Huntingdon
    Cambridgeshire
    Segretario
    29 Hollow Lane
    Ramsey
    PE17 1DE Huntingdon
    Cambridgeshire
    French11694180001
    LAVERY, Andrew Charles
    54 Bermondsey Street
    SE1 3UD London
    Woolyard
    Segretario
    54 Bermondsey Street
    SE1 3UD London
    Woolyard
    British82900930001
    RANDALL, John David
    29 Gresham Avenue
    CT9 5EH Margate
    Kent
    Segretario
    29 Gresham Avenue
    CT9 5EH Margate
    Kent
    British57217680001
    TAYLOR, David
    30 Cardinals Walk
    TW12 2TS Hampton
    Middlesex
    Segretario
    30 Cardinals Walk
    TW12 2TS Hampton
    Middlesex
    British1283940001
    BOWEN, Ian
    14 Thornhill Road
    UB10 8SF Uxbridge
    Middlesex
    Amministratore
    14 Thornhill Road
    UB10 8SF Uxbridge
    Middlesex
    British101474900001
    HEYWOOD-LONSDALE, Tom
    Stow Cottage
    Mount Farm
    OX7 6NP Churchill
    Oxfordshire
    Amministratore
    Stow Cottage
    Mount Farm
    OX7 6NP Churchill
    Oxfordshire
    British83072980001
    HONOREZ, Christian Pierre
    29 Hollow Lane
    Ramsey
    PE17 1DE Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    29 Hollow Lane
    Ramsey
    PE17 1DE Huntingdon
    Cambridgeshire
    French11694180001
    LAVERY, Andrew Charles
    54 Bermondsey Street
    SE1 3UD London
    Woolyard
    Amministratore
    54 Bermondsey Street
    SE1 3UD London
    Woolyard
    EnglandBritish82900930001
    RANDALL, John David
    29 Gresham Avenue
    CT9 5EH Margate
    Kent
    Amministratore
    29 Gresham Avenue
    CT9 5EH Margate
    Kent
    British57217680001
    SCICLUNA, Hector Anthony
    7 Woodcock Close
    Impington
    CB4 4LD Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    7 Woodcock Close
    Impington
    CB4 4LD Cambridge
    Cambridgeshire
    Australian67664660001
    WALKER, Simon
    34 Bassingham Road
    SW18 3AG London
    Amministratore
    34 Bassingham Road
    SW18 3AG London
    British67487470001

    Chi sono le persone con controllo significativo di H & H FINE WINES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bancroft Wines Limited
    54 Bermondsey Street
    SE1 3UD London
    Woolyard
    United Kingdom
    06 apr 2016
    54 Bermondsey Street
    SE1 3UD London
    Woolyard
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneRegister Of Companies In England And Wales
    Numero di registrazione03829460
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    H & H FINE WINES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 05 feb 2001
    Consegnato il 07 feb 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 11 ago 1999
    Consegnato il 28 ago 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a 18 edison road st. Ives. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Single debenture
    Creato il 26 ott 1993
    Consegnato il 29 ott 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 29 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 25 set 1990
    Consegnato il 02 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 23 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 05 feb 1990
    Consegnato il 08 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 feb 1990Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0