SIMPSON INDUSTRIES NO.2 LIMITED

SIMPSON INDUSTRIES NO.2 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSIMPSON INDUSTRIES NO.2 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02353406
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SIMPSON INDUSTRIES NO.2 LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova SIMPSON INDUSTRIES NO.2 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o BEVERLEY JANE MARSH, VANTIS BUSINESS RECOVERY SERVICES
    VANTIS BUSINESS RECOVERY SERVICES
    104-106 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SIMPSON INDUSTRIES NO.2 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SIMPSON INDUSTRIES LIMITED28 giu 199128 giu 1991
    MAXSYS LIMITED07 gen 199107 gen 1991
    DAYSHARP LIMITED28 feb 198928 feb 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di SIMPSON INDUSTRIES NO.2 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al01 ott 2005

    Quali sono le ultime deposizioni per SIMPSON INDUSTRIES NO.2 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    3 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 gen 2012

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 lug 2011

    5 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:- replacement of liquidator
    9 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 gen 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 lug 2010

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 gen 2010

    5 pagine4.68

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 28 apr 2009

    2 pagine3.6

    legacy

    1 pagine405(2)

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    6 pagine4.20

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 16 gen 2009

    LRESEX

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    legacy

    1 pagine287

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 08 mag 2009

    2 pagine3.6

    Relazione del commissario giudiziario amministrativo

    27 pagine3.10

    Stato patrimoniale in amministrazione controllata a seguito della relazione ai creditori

    5 pagine3.3

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine405(1)

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    7 pagine395

    legacy

    7 pagine363s

    Chi sono gli amministratori di SIMPSON INDUSTRIES NO.2 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SIMPSON, John Michael
    57 Albert Road
    B63 4SW Halesowen
    West Midlands
    Amministratore
    57 Albert Road
    B63 4SW Halesowen
    West Midlands
    British69804950001
    SIMPSON, John Alfred
    Field Cottage Farm Uffmoor Lane
    Romsley
    B62 0NW Halesowen
    West Midlands
    Amministratore
    Field Cottage Farm Uffmoor Lane
    Romsley
    B62 0NW Halesowen
    West Midlands
    British13770250001
    CHAMPANERIA, Narendra Kumar
    12 Foxlands Drive
    B72 1YZ Sutton Coldfield
    Segretario
    12 Foxlands Drive
    B72 1YZ Sutton Coldfield
    British73506110002
    CLEMENT, Norman Howard
    84 Ashenhurst Road
    DY1 2HN Dudley
    West Midlands
    Segretario
    84 Ashenhurst Road
    DY1 2HN Dudley
    West Midlands
    British36402170001
    CLEMENT, Norman Howard
    84 Ashenhurst Road
    DY1 2HN Dudley
    West Midlands
    Amministratore
    84 Ashenhurst Road
    DY1 2HN Dudley
    West Midlands
    British36402170001
    EALES, Darryl Charles
    7 Sycamore Drive
    Hollywood
    B47 5QX Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    7 Sycamore Drive
    Hollywood
    B47 5QX Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritish2886080001
    EALES, Darryl
    6 Redwood Close
    Hollywood
    B47 5QD Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    6 Redwood Close
    Hollywood
    B47 5QD Birmingham
    West Midlands
    British33214220002

    SIMPSON INDUSTRIES NO.2 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 23 gen 2007
    Consegnato il 09 feb 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    56/58 hainge road, tividale, warley, west midlands, sandwell t/no WM168255 and the plant, machinery and fixtures and fittings. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • West Register (Investments) Limited
    Transazioni
    • 09 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 06 ott 2006
    Consegnato il 12 ott 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    56/58 hainge road tividale warley west midlands t/nos WM168255 and WM1963. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • West Register (Investments) Limited
    • West Register (Investments) Limited
    Transazioni
    • 12 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 18 ott 1996
    Consegnato il 26 ott 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    56/58 hainge road tividale warley west midlands. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 26 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 12 apr 1995
    Consegnato il 02 mag 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the north side of rocks lane barrow gurney woodspring avon t/no: av 213285. fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of novation
    Creato il 13 mag 1992
    Consegnato il 26 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of theother companies named therein to the chargees on any account whatsoever under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Assets and undertakings of the company see form 395 ref M529C.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Development Capital Limited
    • County Natwest Limited
    Transazioni
    • 26 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 mar 1992
    Consegnato il 17 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Development Capital Limited
    Transazioni
    • 17 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 ago 1991
    Consegnato il 15 ago 1991
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mag 2007Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
    • 12 mag 2007Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
      • Numero di pratica 1

    SIMPSON INDUSTRIES NO.2 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    13 ago 1991Data dello strumento
    Ricevitore amministrativo nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Tomislav Lukic
    Ernst & Young
    One Colmore Row
    B3 2DB Birmingham
    Praticante
    Ernst & Young
    One Colmore Row
    B3 2DB Birmingham
    Ian Best
    Ernst & Young Llp
    One Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Praticante
    Ernst & Young Llp
    One Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    2
    DataTipo
    21 ago 2012Data di scioglimento
    16 gen 2009Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jonathan Mark Birch
    104/106 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    Praticante
    104/106 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    Beverley Jane Marsh
    104/106 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    Praticante
    104/106 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    Gerald Clifford Smith
    Frp Advisory Llp 104-106 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    Praticante
    Frp Advisory Llp 104-106 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0