VIRGIN ACTIVE MANAGEMENT LIMITED

VIRGIN ACTIVE MANAGEMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVIRGIN ACTIVE MANAGEMENT LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02353684
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di VIRGIN ACTIVE MANAGEMENT LIMITED?

    • Gestione di impianti sportivi (93110) / Attività artistiche, sportive e di divertimento
    • Attività di società sportive (93120) / Attività artistiche, sportive e di divertimento
    • Altre attività di divertimento e di svago n.c.a. (93290) / Attività artistiche, sportive e di divertimento

    Dove si trova VIRGIN ACTIVE MANAGEMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3 & 4 Blake House Schooner Court
    Crossways Business Park
    DA2 6QQ Dartford
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VIRGIN ACTIVE MANAGEMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HOLMES PLACE MANAGEMENT LIMITED21 gen 199821 gen 1998
    HOLMES PLACE FACILITIES LIMITED 01 mar 198901 mar 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di VIRGIN ACTIVE MANAGEMENT LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 dic 2024
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2022

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per VIRGIN ACTIVE MANAGEMENT LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al20 mar 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma03 apr 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al20 mar 2024
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per VIRGIN ACTIVE MANAGEMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Cessazione della carica di Thomas Bernabe Galvan come amministratore in data 31 dic 2024

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 29 dic 2023 al 31 mar 2024

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 mar 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2022

    19 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 dic 2022 al 29 dic 2022

    1 pagineAA01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 dic 2023 al 31 mar 2024

    1 pagineAA01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2022 al 30 dic 2022

    1 pagineAA01

    Indirizzo della sede legale modificato da Minerva House 5 Montague Close London SE1 9BB England a 3 & 4 Blake House Schooner Court Crossways Business Park Dartford DA2 6QQ in data 30 mar 2023

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Mark Rogers come amministratore in data 09 gen 2023

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 gen 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2021

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 gen 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Fusion Lifestyle 4 Bickels Yard 151-153 Bermondsey St London SE1 3HA Great Britain a Minerva House 5 Montague Close London SE1 9BB

    1 pagineAD02

    Cessazione della carica di Ronald Peter Kay come amministratore in data 12 nov 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Anthony Cawley come amministratore in data 01 ott 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Thomas Bernabe Galvan come amministratore in data 01 ott 2021

    2 pagineAP01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2020

    20 pagineAA

    Cessazione della carica di Ivan James Latimer Parkinson come amministratore in data 30 mar 2021

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 gen 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Minerva House 5 Montague Close London SE1 9BB

    1 pagineAD04

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ivan James Latimer Parkinson il 31 dic 2020

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Norma Elizabeth Mcgregor come segretario in data 07 set 2020

    1 pagineTM02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ronald Peter Kay il 31 dic 2020

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 4 Bickels Yard 151-153 Bermondsey Street London SE1 3HA a Minerva House 5 Montague Close London SE1 9BB in data 20 ott 2020

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di VIRGIN ACTIVE MANAGEMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CAWLEY, Anthony
    Schooner Court
    Crossways Business Park
    DA2 6QQ Dartford
    3 & 4 Blake House
    England
    Amministratore
    Schooner Court
    Crossways Business Park
    DA2 6QQ Dartford
    3 & 4 Blake House
    England
    EnglandBritishOperations Director288204430001
    ROGERS, Mark
    Schooner Court
    Crossways Business Park
    DA2 6QQ Dartford
    3 & 4 Blake House
    England
    Amministratore
    Schooner Court
    Crossways Business Park
    DA2 6QQ Dartford
    3 & 4 Blake House
    England
    EnglandBritishCommunities And Partnerships Director306548090001
    ARCHIBALD, James Hugh Culver
    Active House
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    Active House
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    180577880001
    AYLMER, Ashley John
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes, Buckinghamshire
    Active House
    England
    England
    Segretario
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes, Buckinghamshire
    Active House
    England
    England
    BritishGroup Legal Director113915040002
    BINGHAM, Frances
    157 Abbeville Road
    SW4 9JJ London
    Segretario
    157 Abbeville Road
    SW4 9JJ London
    British62480960003
    MCGREGOR, Norma Elizabeth
    5 Montague Close
    SE1 9BB London
    Minerva House
    England
    Segretario
    5 Montague Close
    SE1 9BB London
    Minerva House
    England
    266349350001
    NEOH, Christopher
    20 Observatory Road
    East Sheen
    SW14 7QD London
    Segretario
    20 Observatory Road
    East Sheen
    SW14 7QD London
    British42703230001
    PETERSEN, Stuart Graham
    Stonemere Oatlands Drive
    KT13 9H5 Weybridge
    Surrey
    Segretario
    Stonemere Oatlands Drive
    KT13 9H5 Weybridge
    Surrey
    British18227280001
    JD SECRETARIAT LIMITED
    1 Lumley Street
    Mayfair
    W1Y 2NB London
    Segretario nominato
    1 Lumley Street
    Mayfair
    W1Y 2NB London
    900001180001
    JD SECRETARIAT LIMITED
    1 Lumley Street
    Mayfair
    W1K 6TT London
    Segretario
    1 Lumley Street
    Mayfair
    W1K 6TT London
    59292030001
    ALKIN, Lawrence Michael
    Flat E101, Montevetro Building
    100 Battersea Church Road
    SW11 3YL London
    Amministratore
    Flat E101, Montevetro Building
    100 Battersea Church Road
    SW11 3YL London
    United KingdomBritishDirector104119320001
    BUCKNALL, Matthew William
    Active House
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Active House
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director162066820001
    BURKE, Michael Ian
    24 Talbot Road
    Highgate
    N6 4QR London
    Amministratore
    24 Talbot Road
    Highgate
    N6 4QR London
    BritishChief Executive58500900003
    BURROWS, Nicholas Alan
    Oriel House
    Doddinghurst Road Doddinghurst
    CM15 0QJ Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Oriel House
    Doddinghurst Road Doddinghurst
    CM15 0QJ Brentwood
    Essex
    EnglandBritishHuman Resources Director108145620001
    CONNOLLY, Kevin Brian
    The Old Tea Shop
    Church Street
    CV37 8EJ Welford On Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    The Old Tea Shop
    Church Street
    CV37 8EJ Welford On Avon
    Warwickshire
    IrishFinance Director54542950002
    COTTON, Lesley Anne
    Bankside Cottage
    Shoreham Road
    TN14 5RP Otford
    Kent
    Amministratore
    Bankside Cottage
    Shoreham Road
    TN14 5RP Otford
    Kent
    EnglandBritishHuman Resources Director110996340001
    FIELD, Norman Mark
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    England
    South AfricaSouth AfricanManaging Director155532110001
    FISHER, Allan Brian Henry, Mr.
    52 Northgate
    Prince Albert Road
    NW8 7EH London
    Amministratore
    52 Northgate
    Prince Albert Road
    NW8 7EH London
    EnglandBritishDirector26461710001
    FISHER, Jonathan Marc
    52 North Gate
    Prince Albert Road
    NW8 7EH London
    Amministratore
    52 North Gate
    Prince Albert Road
    NW8 7EH London
    EnglandBritishManaging Director41510560001
    GALVAN, Thomas Bernabe
    Schooner Court
    Crossways Business Park
    DA2 6QQ Dartford
    3 & 4 Blake House
    England
    Amministratore
    Schooner Court
    Crossways Business Park
    DA2 6QQ Dartford
    3 & 4 Blake House
    England
    EnglandBritishFinance Director205927780001
    GINSBERG, Lee Dale
    The Ridings
    30 Hurstwood
    SL5 9SP South Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    The Ridings
    30 Hurstwood
    SL5 9SP South Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant37261660001
    GORDON, Simon
    Active House
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Active House
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director162037020001
    KAY, Ronald Peter
    5 Montague Close
    SE1 9BB London
    Minerva House
    England
    Amministratore
    5 Montague Close
    SE1 9BB London
    Minerva House
    England
    EnglandBritishChief Exec82155470002
    MCLAUGHLAN, Roger
    67 Lakes Lane
    HP9 2JZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    67 Lakes Lane
    HP9 2JZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishHuman Resources Director66713260001
    MEDLIN, Sharron Jane
    44 Forest View Road
    E17 4EL London
    Amministratore
    44 Forest View Road
    E17 4EL London
    BritishArea Director66451620001
    MERRICK, Matthew Graham
    Active House
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Active House
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    EnglandBritishUk Finance Director176934130001
    MOSSERI, Henry Samuel Robert Victor
    Cumbroc
    Camp End Road St Georges Hill
    KT13 0NR Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Cumbroc
    Camp End Road St Georges Hill
    KT13 0NR Weybridge
    Surrey
    EnglandBritishDirector79426840001
    NEOH, Christopher
    20 Observatory Road
    East Sheen
    SW14 7QD London
    Amministratore
    20 Observatory Road
    East Sheen
    SW14 7QD London
    BritishAccountant42703230001
    PARKINSON, Ivan James Latimer
    5 Montague Close
    SE1 9BB London
    Minerva House
    England
    Amministratore
    5 Montague Close
    SE1 9BB London
    Minerva House
    England
    EnglandBritishAccountant189484350001
    PETERSEN, Stuart Graham
    Stonemere Oatlands Drive
    KT13 9H5 Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Stonemere Oatlands Drive
    KT13 9H5 Weybridge
    Surrey
    BritishCompany Secretary18227280001
    SAUNDERS, Andrew
    19 Ensor Mews
    SW7 3BT London
    Amministratore
    19 Ensor Mews
    SW7 3BT London
    BritishOsteopath48388260001
    WOOLF, Paul Antony
    Active House
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Active House
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector160679880001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per VIRGIN ACTIVE MANAGEMENT LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    08 gen 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    VIRGIN ACTIVE MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 18 mag 2012
    Consegnato il 25 mag 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 25 mag 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 18 lug 2011
    Consegnato il 25 lug 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (Security Trustee)
    Transazioni
    • 25 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 12 ago 2010
    Consegnato il 19 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The “Security Trustee”)
    Transazioni
    • 19 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 24 lug 2007
    Consegnato il 25 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of admission
    Creato il 06 set 2005
    Consegnato il 19 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or ot become due from the further company to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC: Capital Markets (The Trustee) as Agent and Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 19 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of admission and amendment
    Creato il 10 giu 2005
    Consegnato il 27 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by the further company to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Beneficiaries (The Trustees)
    Transazioni
    • 27 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of admission and amendment
    Creato il 10 giu 2005
    Consegnato il 27 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any one or more of the existing companies and hphl to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sums standing to the credit of any accounts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 27 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of amendment to a composite guarantee and debenture dated 21ST october 1999
    Creato il 05 ago 2002
    Consegnato il 16 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys and liabilities due or to become due from the company or any other company to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Including 100 aldersgate st,london EC1 (l/hold); unit 1,1-11 howie st,battersea,london SW11 4AS (l/hold); hohn trundle court,barbican,london EC2Y 8DJ (l/hold); see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC: Capital Markets as Trustee and Agent for Each of the Beneficiaries
    Transazioni
    • 16 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 21 ott 1999
    Consegnato il 10 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys and liabilities whether present or future actual or contingent (including further advances made after the date of the debenture by any beneficiary which were at the date of the debenture or at any time thereafter might be due owing or incurred by any of the charging companies to any beneficiary pursuant to the finance documents (all defined therein)
    Brevi particolari
    The properties k/a 100 aldersgate street, london EC1 l/h, unit 1, 1-11 howie street, battersea, london SW11 4AS l/h, john trundle court, barbican, london EC2Y 8DJ l/h, 1ST floor, 314 regents park road, london N3 2JX l/H. For details of further properties charged please refer to form 395.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC Capital Markets
    Transazioni
    • 10 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 09 feb 1998
    Consegnato il 23 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 23 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0