OKEFIND LIMITED
Panoramica
Nome della società | OKEFIND LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02353867 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di OKEFIND LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova OKEFIND LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 5 New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Feltham Middlesex England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di OKEFIND LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2022 |
Quali sono le ultime deposizioni per OKEFIND LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022 | 8 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher David Bouttle il 03 lug 2023 | 2 pagine | CH01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 4 New Square Bedfont Lakes Feltham Middlesex TW14 8HA United Kingdom a 5 New Square Bedfont Lakes Feltham Middlesex TW14 8HA in data 31 lug 2023 | 1 pagine | AD01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021 | 6 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Benjamin Harmstorf come amministratore in data 01 set 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 6 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 7 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Paul Henry Donaldson come segretario in data 13 ott 2020 | 1 pagine | TM02 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 6 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 7 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Benjamin Harmstorf il 07 ago 2017 | 2 pagine | CH01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 7 pagine | AA | ||
Cessazione di The Nuance Group (Uk) Ltd come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 1 pagine | PSC07 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Notifica di The Nuance Group (Uk) Ltd come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||
Cessazione della carica di Ekaterina Herzig come amministratore in data 13 gen 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Chi sono gli amministratori di OKEFIND LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUTTLE, Christopher David | Amministratore | Bedfont Lakes TW14 8HA Feltham 5 New Square Middlesex England | England | British | Company Director | 138452200003 | ||||
DONALDSON, Paul Henry | Segretario | Mortimers Cottage Romsey Road SO51 6AF Ower 2 Hampshire United Kingdom | British | Financial Controller | 135855520001 | |||||
EGGLETON, Jeanette | Segretario | Ridgeway Ashurst Drive Boxhill KT20 7LW Tadworth Surrey | British | 51206780001 | ||||||
MACKENZIE, Amanda Jane | Segretario | 1 Rochester Road PO4 9BA Southsea Hampshire | British | 58628610001 | ||||||
PRIDEAUX, Robert David | Segretario | Staddles Romsey Road SO51 6EB Wellow Hampshire | British | 258430004 | ||||||
TRITSCHLER, Annette Elizabeth | Segretario | Fordingbridge SP6 2QH Fordingbridge Rippleside Hampshire | British | Financial Controller | 128807210001 | |||||
WALKER, Edward Ian Charles | Segretario | 8 Upper Barn Copse SO50 8DD Fair Oak Hampshire | British | 97715830001 | ||||||
WINSOR, Richard Andrew | Segretario | 107 Imperial Apartments South Western House Canute Road SO14 3AL Southampton Hampshire | British | 34882920001 | ||||||
ANSON-ESPARZA, Alexander Angel | Amministratore | Oriana Way Nursling SO16 0YU Southampton Unit 42 Nursling Industrial Estate Hampshire | Switzerland | British | Commercial Director | 176584050001 | ||||
BERNASCONI, Carlo | Amministratore | Hornstrasse 30 Obererlinsbach 5016 So Switzerland | Switzerland | Swiss | Chief Executive Officer | 98358100001 | ||||
BRAUN, Markus | Amministratore | Steinacherstrasse 15 8308 Illnau FOREIGN Switzerland | Swiss | Cheif Financial Officer | 52080210001 | |||||
COLLYER, Anthony David | Amministratore | Camel Farm Cottage Queen Camel BA22 7NB Yeovil Somerset | British | Financial Director | 49685240001 | |||||
DAFFLON, Rene | Amministratore | Rainstrasse 5 8103 Unterengstringen Switzerland | Swiss | President | 59582140001 | |||||
GIROTTO, Nicolas Daniel | Amministratore | Oriana Way Nursling SO16 0YU Southampton Unit 42 Nursling Industrial Estate Hampshire | Italy | French | Finance Director | 176584570001 | ||||
HARMSTORF, Benjamin | Amministratore | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Feltham 4 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | German | Chief Financial Officer | 302117920001 | ||||
HERZIG, Ekaterina | Amministratore | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Feltham 4 Middlesex United Kingdom | Switzerland | Swiss | Rs&D Operations Director | 184205440001 | ||||
KELLER, Ruedi | Amministratore | Grabenwies 79 ZH 8484 Weisslingen Switzerland | Swiss | Controller | 51975540001 | |||||
LIPSITH, Harvey Brian | Amministratore | Heronsmore 4 Martello Road Canford Cliffs BH13 7DH Poole Dorset | British | Chairman | 425860001 | |||||
PENNYCOOK, Richard | Amministratore | Sherington Place Church End MK16 9PA Sherington Bucks | British | Financial Director | 112734470001 | |||||
RUDOLF, Andreas Juergen, Dr | Amministratore | Oriana Way Nursling SO16 0YU Southampton Unit 42 Nursling Industrial Estate Hampshire | Switzerland | Swiss | Cfo | 209827280001 | ||||
SLAYMAKER, Peter Alan | Amministratore | The Laurels Clifton Road BH14 9PP Poole Dorset | British | Director | 63164360001 | |||||
STEGEMANN, Christian Heinrich | Amministratore | Bachtlenstrasse 1 Niederglatt Zh 8172 Switzerland | Switzerland | Swiss | Director Finance | 98358190001 | ||||
WHITEHOUSE, Paul Stewart | Amministratore | 47 Benner Lane GU24 9JR Woking Surrey | England | British | Retail Operations Director | 105735180001 | ||||
WINSOR, Richard Andrew | Amministratore | 107 Imperial Apartments South Western House Canute Road SO14 3AL Southampton Hampshire | British | Finance Director | 34882920001 | |||||
WOOD, Christopher Peter | Amministratore | Via Ronco Nuovo 8 Comano Ti 6949 Switzerland | Switzerland | British | Chief Financial Officer | 100237260001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di OKEFIND LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Nuance Group (Uk) Ltd | 06 apr 2016 | New Square Feltham TW14 8HA Feltham 4 Middlesex England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
The Nuance Group (Uk) Limited | 06 apr 2016 | Nursling Industrial Estate, Oriana Way Nursling SO16 0YU Southampton Unit 42 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
OKEFIND LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and debenture | Creato il 19 ott 1990 Consegnato il 08 nov 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therin to the chargee as defined in the deed | |
Brevi particolari See doc m 184 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 15 mag 1989 Consegnato il 31 mag 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therin to the chargee chemical bank as agent for the benefit of the banks as defined. | |
Brevi particolari Please see mort. Doc. 395 - M323 - for further details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 15 mag 1989 Consegnato il 17 mag 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Sterling pounds 80,454,287 & all monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the guarantee and debenture dated 15/5/89 and on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0