TALKLAND INTERNATIONAL LIMITED

TALKLAND INTERNATIONAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTALKLAND INTERNATIONAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02354106
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TALKLAND INTERNATIONAL LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova TALKLAND INTERNATIONAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TALKLAND INTERNATIONAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GAINGIFT LIMITED01 mar 198901 mar 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di TALKLAND INTERNATIONAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per TALKLAND INTERNATIONAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Notifica di Vodafone International Operations Limited come persona con controllo significativo il 21 dic 2021

    2 paginePSC02

    Cessazione di General Mobile Corporation Limited come persona con controllo significativo il 21 dic 2021

    1 paginePSC07

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 24 feb 2021

    • Capitale: GBP 0.10
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account cancelled 22/02/2021
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 gen 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jonathan Paul Mitchell il 16 dic 2020

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020

    9 pagineAA

    Cessazione della carica di Malcolm Finn come amministratore in data 21 ago 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Andrew Thurston Raggett come amministratore in data 21 ago 2020

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 gen 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 gen 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    9 pagineAA

    Nomina di Dr Malcolm Finn come amministratore in data 21 mar 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Simon Bailey come amministratore in data 21 mar 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul George Stephenson come amministratore in data 21 mar 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Jonathan Paul Mitchell come amministratore in data 21 mar 2018

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di TALKLAND INTERNATIONAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione2357692
    75473330004
    MITCHELL, Jonathan Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish243284220002
    RAGGETT, Andrew Thurston
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish200324290001
    GASPER, Suzanne Lynette Philomena
    118 Harrowdene Gardens
    TW11 0DL Teddington
    Middlesex
    Segretario
    118 Harrowdene Gardens
    TW11 0DL Teddington
    Middlesex
    British49781290001
    HOWIE, Philip Robert Sutherland
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Segretario
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British77939460004
    LAVER, John Michael
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    Segretario
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    British8207040001
    SCOTT, Stephen Roy
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    Segretario
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    British25660590003
    WRIGHT, Garth Howard
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Segretario
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British111162790001
    ALEXANDER, Stephen
    Bentley Way
    HA7 3RR Stanmore
    11
    Middlesex
    Amministratore
    Bentley Way
    HA7 3RR Stanmore
    11
    Middlesex
    British7302800001
    BAILEY, Simon
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish207070340001
    BARR, Robert Nicolas
    Lindfield Faringdon Road
    OX14 1BD Abingdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    Lindfield Faringdon Road
    OX14 1BD Abingdon
    Oxfordshire
    UkBritish41968920003
    BRAVO, Alain
    114 Avenue Mozart
    FOREIGN 75016 Paris
    France
    Amministratore
    114 Avenue Mozart
    FOREIGN 75016 Paris
    France
    French27050320001
    BRUNAIS, Alain
    47 Chemin De L'Ariel
    Louveciennes 78430
    France
    Amministratore
    47 Chemin De L'Ariel
    Louveciennes 78430
    France
    French34216290001
    DE GEUS, Jan
    11 Redford Road
    SL4 5ST Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    11 Redford Road
    SL4 5ST Windsor
    Berkshire
    Dutch105464980002
    EDWARDS, Peter David
    Hockets
    Oriental Road
    SL5 7AZ Sunninghill
    Berkshire
    Amministratore
    Hockets
    Oriental Road
    SL5 7AZ Sunninghill
    Berkshire
    British1908570001
    ENGSTROM, Jan Erik
    Kungsholms Hamnplan 7
    S-11220 Stockholm
    Sweden
    Amministratore
    Kungsholms Hamnplan 7
    S-11220 Stockholm
    Sweden
    Swedish33577650001
    FINN, Malcolm, Dr
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish140676680001
    GENT, Christopher Charles, Sir
    Bockhampton Manor
    RG17 7LS Lambourn
    Berkshire
    Amministratore
    Bockhampton Manor
    RG17 7LS Lambourn
    Berkshire
    British50867930003
    GLOTIN, Philippe-Marie-Yves
    15 Avenue Raymond Poincare
    75116 Paris
    France
    Amministratore
    15 Avenue Raymond Poincare
    75116 Paris
    France
    French32504600001
    HENNING, David
    Chapel Cottage
    Ashford Hill
    RG19 8BG Thatcham
    Berkshire
    Amministratore
    Chapel Cottage
    Ashford Hill
    RG19 8BG Thatcham
    Berkshire
    British71530430001
    HYDON, Kenneth John
    The Maples Crowsley Road
    Shiplake
    RG9 3LD Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Maples Crowsley Road
    Shiplake
    RG9 3LD Henley On Thames
    Oxfordshire
    EnglandBritish10018190001
    JOBARD, Francois Marc
    21 Rue Des 2 Cousins
    Le Chesnay 78150
    France
    Amministratore
    21 Rue Des 2 Cousins
    Le Chesnay 78150
    France
    French41020930001
    LALANDE, Richard Henri Yves
    12 Rue De Voville
    Paris 75015
    Amministratore
    12 Rue De Voville
    Paris 75015
    French9005780001
    LEVINE, Eric Anthony
    Apartment 3f
    1088 Park Avenue
    New York 10128
    Usa
    Amministratore
    Apartment 3f
    1088 Park Avenue
    New York 10128
    Usa
    British38853690001
    LITTLE, Peter
    Europe House
    Church Street
    TW7 Old Isleworth
    Middlesex
    Amministratore
    Europe House
    Church Street
    TW7 Old Isleworth
    Middlesex
    British25364510001
    NOBLET, Marc Marie Bruno
    10 Rue Lafayette
    Versailles 78000
    France
    Amministratore
    10 Rue Lafayette
    Versailles 78000
    France
    French39159970001
    PEETT, Edward John
    Low Wood Green Lane
    Pangbourne
    RG8 7BG Reading
    Amministratore
    Low Wood Green Lane
    Pangbourne
    RG8 7BG Reading
    British63206310001
    PITT, Michael John
    Lansdown 97 St Peters Avenue
    Caversham
    RG4 7DP Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Lansdown 97 St Peters Avenue
    Caversham
    RG4 7DP Reading
    Berkshire
    British97210810001
    REES, Peter Wynford Innes, Lord
    39 Headfort Place
    SW1X 7DE London
    Amministratore
    39 Headfort Place
    SW1X 7DE London
    British9234550001
    STEPHENSON, Paul George
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish93511470001
    VILLANEAU, Michel Jean Charles
    22 Rue D'Angivillers
    Versailles 78000
    France
    Amministratore
    22 Rue D'Angivillers
    Versailles 78000
    France
    French17857770001
    WARD, Charles Patrick
    Glebe House
    RG8 8ES Tidmarsh
    Berkshire
    Amministratore
    Glebe House
    RG8 8ES Tidmarsh
    Berkshire
    British78935940001
    WHENT, Gerald Arthur, Sir
    Raffin Stud
    West Soley Chilton Foliat
    RG17 0TN Hungerford
    Berkshire
    Amministratore
    Raffin Stud
    West Soley Chilton Foliat
    RG17 0TN Hungerford
    Berkshire
    British72227530001
    WRIGHT, Neil Andrew
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish155640160001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TALKLAND INTERNATIONAL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    21 dic 2021
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2797438
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2585763
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    TALKLAND INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 02 giu 1994
    Consegnato il 08 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of guarantee and debenture.
    Creato il 18 mar 1994
    Consegnato il 30 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Vodaphone Group PLC,
    Transazioni
    • 30 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of guarantee and debenture
    Creato il 17 mar 1994
    Consegnato il 22 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement of even date
    Brevi particolari
    By way of a floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Compagnie Generale Des Eaux Sa
    Transazioni
    • 22 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 dic 1993
    Consegnato il 04 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement of even date
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Compagnie Generale Des Eaux S.A.
    Transazioni
    • 04 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of guarantee and debenture
    Creato il 14 feb 1992
    Consegnato il 18 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or talkland international (UK) limited to the chargee under the terms of a facility agreement or a deed of priority both dated 14TH february and this charge
    Brevi particolari
    Floating charge over see form 395 and continuation sheets relevant to this charge.. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Compagnie Generale Des Eaux S.A.
    Transazioni
    • 18 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of debenture
    Creato il 02 apr 1991
    Consegnato il 22 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See schedule attached 395 for details.
    Persone aventi diritto
    • Gamlestadon PLC
    Transazioni
    • 22 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 22 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 feb 1990
    Consegnato il 15 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H, 11 lorne road title no sgl 447282 with all fixtures (other than trade) goodwill floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Gamlestaden PLC
    Transazioni
    • 15 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 22 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0