IAM MANAGEMENT SERVICES LIMITED

IAM MANAGEMENT SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàIAM MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02354326
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di IAM MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova IAM MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    6 Graphite Square
    Vauxhall Walk
    SE11 5EE London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di IAM MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LAW 141 LIMITED02 mar 198902 mar 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di IAM MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per IAM MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per IAM MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 set 2013

    Stato del capitale al 26 set 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Cessazione della carica di Jennifer Hewell come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di Andrew Young come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Jennifer Hewell il 01 mag 2010

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Mark Ian Cooke come segretario

    1 pagineAP03

    Nomina di Mr Andrew Roger Young come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Peter Hill come segretario

    1 pagineTM02

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2009

    6 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2008

    6 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2007

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    2 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di IAM MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COOKE, Mark Ian
    6 Graphite Square
    Vauxhall Walk
    SE11 5EE London
    Segretario
    6 Graphite Square
    Vauxhall Walk
    SE11 5EE London
    153925480001
    HOLLAND, David Alan
    The Chestnuts
    Long Green, Wortham
    IP22 1RD Diss
    Norfolk
    Amministratore
    The Chestnuts
    Long Green, Wortham
    IP22 1RD Diss
    Norfolk
    EnglandBritish97792830001
    HAYHURST, Christine Ann
    5 Gorselands Close
    Ash Vale
    GU12 5EF Aldershot
    Hampshire
    Segretario
    5 Gorselands Close
    Ash Vale
    GU12 5EF Aldershot
    Hampshire
    British18516810001
    HEWELL, Jennifer
    3 Jubilee Terrace
    Laverton
    BA2 7QZ Bath
    Segretario
    3 Jubilee Terrace
    Laverton
    BA2 7QZ Bath
    British122167890001
    HILL, Peter William
    Hill House
    27 Meadowford
    CB11 3QL Saffron Walden
    Essex
    Segretario
    Hill House
    27 Meadowford
    CB11 3QL Saffron Walden
    Essex
    British120923930001
    ROBINSON, Graham, Professor
    The Sidings 19 Station Road
    Woodley
    SK6 1HN Stockport
    Cheshire
    Segretario
    The Sidings 19 Station Road
    Woodley
    SK6 1HN Stockport
    Cheshire
    British55841760002
    ROBINSON, Graham, Professor
    The Sidings 19 Station Road
    Woodley
    SK6 1HN Stockport
    Cheshire
    Segretario
    The Sidings 19 Station Road
    Woodley
    SK6 1HN Stockport
    Cheshire
    British55841760002
    SEGARAN, Andrew
    17 Burrell Close
    Shirley
    CR0 7QL Croydon
    Surrey
    Segretario
    17 Burrell Close
    Shirley
    CR0 7QL Croydon
    Surrey
    British73648480001
    SLEIGHTHOLME, Peter Joseph
    78 Beaumont Road
    Petts Wood
    BR5 1JQ Orpington
    Kent
    Segretario
    78 Beaumont Road
    Petts Wood
    BR5 1JQ Orpington
    Kent
    British38282490001
    WOODGATE, David Roger
    255 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road Maida Vale
    W9 1LZ London
    Segretario
    255 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road Maida Vale
    W9 1LZ London
    British77477340001
    YOUNG, Andrew Roger
    6 Graphite Square
    Vauxhall Walk
    SE11 5EE London
    Segretario
    6 Graphite Square
    Vauxhall Walk
    SE11 5EE London
    148121130001
    CORNHILL SECRETARIES LIMITED
    St Paul's House
    Warwick Lane
    EC4M 7BP London
    Segretario nominato
    St Paul's House
    Warwick Lane
    EC4M 7BP London
    900023430001
    BAYLIS, Anthony John
    Riber House
    Buswell Close
    NN7 4QE Weedon
    Northampton
    Amministratore
    Riber House
    Buswell Close
    NN7 4QE Weedon
    Northampton
    GbrBritish33587290003
    BESWICK, Moira Lorreen
    5 Bromley Road
    Broken Cross
    SK10 3LN Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    5 Bromley Road
    Broken Cross
    SK10 3LN Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritish19490420001
    BRISCOE, Graham Owen
    56 Manor Road
    BS23 2SX Weston Super Mare
    Avon
    Amministratore
    56 Manor Road
    BS23 2SX Weston Super Mare
    Avon
    EnglandBritish17350840001
    DOUGLAS, Bruce Hamilton
    29 Cattle End
    Silverstone
    NN12 8UX Towcester
    Northamptonshire
    Amministratore
    29 Cattle End
    Silverstone
    NN12 8UX Towcester
    Northamptonshire
    EnglandBritish62987860002
    FITZPATRICK, Peter
    39 Parkgrove Loan
    EH4 7QX Edinburgh
    Amministratore
    39 Parkgrove Loan
    EH4 7QX Edinburgh
    British85877300001
    GALBRAITH, Charles Mckerral
    72 Redford Ave
    EH13 0BW Edinburgh
    Amministratore
    72 Redford Ave
    EH13 0BW Edinburgh
    British59879760001
    HAYHURST, Christine Ann
    5 Gorselands Close
    Ash Vale
    GU12 5EF Aldershot
    Hampshire
    Amministratore
    5 Gorselands Close
    Ash Vale
    GU12 5EF Aldershot
    Hampshire
    British18516810001
    HAYWARD, Christopher Michael
    Heath House
    Rickmansworth Road
    WD3 5SG Chorleywood
    Hertfordshire
    Amministratore
    Heath House
    Rickmansworth Road
    WD3 5SG Chorleywood
    Hertfordshire
    United KingdomBritish54418570006
    HEWELL, Jennifer Ann
    6 Graphite Square
    Vauxhall Walk
    SE11 5EE London
    Amministratore
    6 Graphite Square
    Vauxhall Walk
    SE11 5EE London
    United KingdomBritish122167890002
    HOLLAND, Keith Frank
    1 Haybarn Drive
    RH12 5JF Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    1 Haybarn Drive
    RH12 5JF Horsham
    West Sussex
    British56606440001
    LAVENDER, Anthony Robert
    196 Upper Street
    Islington
    N1 1RQ London
    Amministratore
    196 Upper Street
    Islington
    N1 1RQ London
    British19538040001
    MACKIE, Ewen Thomas
    The Moss
    30 Dalziel Drive
    G41 4PU Pollockshields
    Glasgow
    Amministratore
    The Moss
    30 Dalziel Drive
    G41 4PU Pollockshields
    Glasgow
    ScotlandBritish253200002
    PENIN, Henri Patrick
    East Standon Lodge Stane Street
    Ockley
    RH5 5LX Dorking
    Surrey
    Amministratore
    East Standon Lodge Stane Street
    Ockley
    RH5 5LX Dorking
    Surrey
    French15845860001
    ROBINSON, Graham, Professor
    The Sidings 19 Station Road
    Woodley
    SK6 1HN Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    The Sidings 19 Station Road
    Woodley
    SK6 1HN Stockport
    Cheshire
    British55841760002
    ROSS, Duncan
    Green Mice Cottage
    Catterick Village
    DL10 7LU Richmond
    Yorkshire
    Amministratore
    Green Mice Cottage
    Catterick Village
    DL10 7LU Richmond
    Yorkshire
    British85877400001
    SEWELL-RUTTER, Colin Peter
    The Old Clergy House Church Platt
    Cuckfield
    RH17 5LA Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    The Old Clergy House Church Platt
    Cuckfield
    RH17 5LA Haywards Heath
    West Sussex
    EnglandBritish34709800003
    STERNDALE BENNETT, Barry Monkhouse
    White Windows
    SP11 6PB Longparish
    Hampshire
    Amministratore
    White Windows
    SP11 6PB Longparish
    Hampshire
    British91277390001
    TURNER, Michael
    12 Leyden Grove
    Clovenfords
    TD1 3NF Galashiels
    Selkirkshire
    Amministratore
    12 Leyden Grove
    Clovenfords
    TD1 3NF Galashiels
    Selkirkshire
    ScotlandBritish33587310001
    WAGSTAFFE, James
    7 Hunters Meadow
    Grange Court Cross Lanes
    LL13 0TQ Bangor Is Y Coed
    Clwyd
    Amministratore
    7 Hunters Meadow
    Grange Court Cross Lanes
    LL13 0TQ Bangor Is Y Coed
    Clwyd
    British37199860001
    WOODGATE, David Roger
    255 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road Maida Vale
    W9 1LZ London
    Amministratore
    255 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road Maida Vale
    W9 1LZ London
    EnglandBritish77477340001
    YOUNG, George Arthur Edward
    15 St Marys
    KT13 9QG Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    15 St Marys
    KT13 9QG Weybridge
    Surrey
    British8114220001

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0