PROVIDENT ENTERPRISES LIMITED

PROVIDENT ENTERPRISES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPROVIDENT ENTERPRISES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02355554
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PROVIDENT ENTERPRISES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PROVIDENT ENTERPRISES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Norflex House
    Allington Way
    DL1 4DY Darlington
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di PROVIDENT ENTERPRISES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per PROVIDENT ENTERPRISES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 27 nov 2012

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2012

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2011

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di Christopher Muir come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Richard Stephen Laker come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2010

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Henderson il 30 apr 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr David Henderson il 30 apr 2010

    1 pagineCH03

    Nomina di Mr Christopher Muir come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Philip Moorhouse come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 apr 2009

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 apr 2008

    3 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di PROVIDENT ENTERPRISES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HENDERSON, David
    Norflex House
    Allington Way
    DL1 4DY Darlington
    Segretario
    Norflex House
    Allington Way
    DL1 4DY Darlington
    British2240270003
    HENDERSON, David
    Norflex House
    Allington Way
    DL1 4DY Darlington
    Amministratore
    Norflex House
    Allington Way
    DL1 4DY Darlington
    EnglandBritishCompany Secretary2240270003
    LAKER, Richard Stephen
    Norflex House
    Allington Way
    DL1 4DY Darlington
    Amministratore
    Norflex House
    Allington Way
    DL1 4DY Darlington
    United KingdomBritishDirector160256950001
    IRETON, Anthony Philip
    4 Chequers Close
    MK43 0RF Lower Shelton
    Bedfordshire
    Segretario
    4 Chequers Close
    MK43 0RF Lower Shelton
    Bedfordshire
    BritishVehicle Rental26235630002
    THORPE, Elizabeth Anne
    2 Oakwood
    DH7 0NP Lanchester
    County Durham
    Segretario
    2 Oakwood
    DH7 0NP Lanchester
    County Durham
    British102907000001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    APPLEGARTH, David Christopher John
    31 Topcliff
    St Peters Riverside
    SR6 0QD Sunderland
    Amministratore
    31 Topcliff
    St Peters Riverside
    SR6 0QD Sunderland
    ScotlandBritishSolicitor81952520001
    IRETON, Anthony Philip
    4 Chequers Close
    MK43 0RF Lower Shelton
    Bedfordshire
    Amministratore
    4 Chequers Close
    MK43 0RF Lower Shelton
    Bedfordshire
    BritishVehicle Rental26235630002
    IRETON, Carol Ann
    Leasefield
    Halwill Junction
    EX21 5XU Beaworthy
    Devon
    Amministratore
    Leasefield
    Halwill Junction
    EX21 5XU Beaworthy
    Devon
    BritishManager90225810001
    IRETON, Diane Jane
    31 Milverton Green
    LU3 3XP Luton
    Bedfordshire
    Amministratore
    31 Milverton Green
    LU3 3XP Luton
    Bedfordshire
    BritishAccounts Supervisor20384380001
    IRETON, Peter Sydney
    Leasefield
    Halwill Junction
    EX21 5XU Beaworthy
    Devon
    Amministratore
    Leasefield
    Halwill Junction
    EX21 5XU Beaworthy
    Devon
    BritishVehicle Rental90226380001
    IRETON, Robert Peter
    153 The Causeway
    Bassingbourn Cum Kneesworth
    SG8 5JD Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    153 The Causeway
    Bassingbourn Cum Kneesworth
    SG8 5JD Royston
    Hertfordshire
    BritishDepot/Rental Manager93133760001
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Amministratore
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritishChartered Accountant4971910001
    METCALFE, Richard
    6 Dawber Delph
    Appley Bridge
    WN6 9LN Wigan
    Amministratore
    6 Dawber Delph
    Appley Bridge
    WN6 9LN Wigan
    EnglandBritishDirector60901930002
    MOORHOUSE, Philip James
    1 Elmtree Grove,
    Elmfield Road
    NE3 4BG Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    1 Elmtree Grove,
    Elmfield Road
    NE3 4BG Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishDirector10786230004
    MUIR, Christopher James Russell
    Norflex House
    Allington Way
    DL1 4DY Darlington
    Amministratore
    Norflex House
    Allington Way
    DL1 4DY Darlington
    EnglandBritishDirector167397320001
    MURRAY, Gerard Thomas
    34 King Edward Road
    NE30 2RP Tynemouth
    Tyne & Wear
    Amministratore
    34 King Edward Road
    NE30 2RP Tynemouth
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishFinance Director87695440002
    PALLESCHI, Dominic
    2 Holdernesse
    Wynyard Woods
    TS22 5RY Billingham
    Amministratore
    2 Holdernesse
    Wynyard Woods
    TS22 5RY Billingham
    EnglandBritishChartered Accountant96240680002

    PROVIDENT ENTERPRISES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage deed
    Creato il 21 nov 2002
    Consegnato il 26 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a or being 2 duke street luton beds LU2 ojh (aka woburn house 1-2 duke street) t/n BD221758. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 26 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplementary schedule
    Creato il 13 nov 2002
    Consegnato il 14 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the right, title and interest in the sub-hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Ireland Business Finance Limited
    Transazioni
    • 14 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 30 ago 2002
    Consegnato il 31 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All goods which are now or hereafter become the subject matter of a hiring agreement or a hire purchase agreement together with the benefit of all contracts for the sub hire or sub hire purchase of the goods. All securities guarantees and inddemnities and all proceeds of sale, insurance claims replacements and debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • United Dominions Trust Limited
    Transazioni
    • 31 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment and charge
    Creato il 11 apr 2002
    Consegnato il 12 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All subcontracts entered into by the company with third parties in respect of vehicles supplied by or on behalf of the chargee by way of lease hire lease purchase hire purchase or other form of hire. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Man Transcom Limited
    Transazioni
    • 12 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Asset sub-hire agreement
    Creato il 19 mar 2002
    Consegnato il 20 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the company's rights title and interest in sub-hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Ireland Business Finance Limited
    Transazioni
    • 20 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over sub-lease and sub lease rentals
    Creato il 31 dic 2001
    Consegnato il 17 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Mercedes benz actros 2540LS reg no. Y936 jgs, mercedes benz actros 2450LS reg no. Y937 jgs and any shares or accessories belonging thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Associates Commercial Corporation Limited
    Transazioni
    • 17 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 ago 2001
    Consegnato il 31 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the north east and south west sides of burr st,luton known as woburn house,2 duke st,luton; bd 210290. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 31 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over sub-lease and sub-lease rentals
    Creato il 14 mag 2001
    Consegnato il 16 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the agreement or this mortgage
    Brevi particolari
    Mercedes benz actros 2540LS registration numbers Y962 jgs,Y963 jgs and Y964 jgs and any spares or accessories belonging thereto the proceeds of sale thereof any insurance policies relating thereto (and the proceeds of any claim thereunder) any maintenance contracts of such goods guarantees manual licences certificates records and other documents relating thereto.
    Persone aventi diritto
    • Associates Commercial Corporation Limited
    Transazioni
    • 16 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over sub-lease and sub-lease rentals
    Creato il 02 apr 2001
    Consegnato il 04 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the agreement or this mortgage
    Brevi particolari
    Mercedes benz actros,reg/nos X416 nbh,X417 nbh,X418 nbh and any spares or accessories thereon.
    Persone aventi diritto
    • Associates Commercial Corporation LTD
    Transazioni
    • 04 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over sub-lease and sub-lease rentals
    Creato il 02 apr 2001
    Consegnato il 04 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the agreement or this mortgage
    Brevi particolari
    Mercedes benz actros reg/nos Y935 jgs,Y931 jgs,Y932 jgs,Y933 jgs,Y934 jgs and any spares or accessories thereon.
    Persone aventi diritto
    • Associates Commercial Corporation LTD
    Transazioni
    • 04 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture over contract hire and leasing agreements
    Creato il 21 dic 2000
    Consegnato il 08 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Charge over the benefit of related sub hire contracts.
    Persone aventi diritto
    • Hitachi Credit (UK) PLC
    Transazioni
    • 08 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Master agreement
    Creato il 23 set 1997
    Consegnato il 26 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the company's right titke and interest in and to the sub-hire agreements described in supplemntary schedules from time o time pursuant to the master agreement and in all ancillary contracts relating thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royscot Leasing Limited
    • Royscot Commercial Leasing
    • Royscot Trust PLC
    • Royscot Industrial Leasing Limited
    • Royscot Spa Leasing
    Transazioni
    • 26 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 18 gen 1995
    Consegnato il 01 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the plant machinery chattels or other equipment as listed in the schedule on the form 395 including sierra diesel reg. No. G524 gvv and 7.5 ton tipper reg. No. B824 vbw. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 01 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First fixed charge
    Creato il 18 lug 1994
    Consegnato il 19 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the credit agreements (as defined therein)
    Brevi particolari
    (I) all sub-lease agreements entered into by the company with customers of the company relating to goods owned by the company (the credit agreements) (ii) the full benefit of the monies payable under the sub-lease agreements (iii) the benefit of all guarantees and indemnities taken by the company in connection with the sub-lease agreements and (iv) the benefit of all insurances effected by the company pursuant to the terms of the sub-lease agreements in respect of the goods comprised therein. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mercedes-Benz Finance Limited
    Transazioni
    • 19 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 22 nov 1993
    Consegnato il 25 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 10 giu 1992
    Consegnato il 18 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed equitable charge on all book debts subject to an agreement (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Metropolitan Factors Limited
    Transazioni
    • 18 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 18 dic 1991
    Consegnato il 23 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a leasing agreement of even date
    Brevi particolari
    All hiring agreements relating to the vehicles described on the form 395.
    Persone aventi diritto
    • Greyhound Financial Services Limited
    Transazioni
    • 23 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0