FITZGEORGE DECEMBER (5) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | FITZGEORGE DECEMBER (5) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02359377 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di FITZGEORGE DECEMBER (5) LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova FITZGEORGE DECEMBER (5) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | All Seasons Church Road Cookham SL6 9PG Maidenhead Berkshire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di FITZGEORGE DECEMBER (5) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| DRESDNER KLEINWORT WASSERSTEIN LEASING DECEMBER (5)LIMITED | 30 apr 2001 | 30 apr 2001 |
| KLEINWORT BENSON LEASING DECEMBER (5) LTD. | 22 dic 1995 | 22 dic 1995 |
| S.G.WARBURG & CO. (LEASING) (NUMBER 8) LTD. | 14 mag 1990 | 14 mag 1990 |
| PALLAS LEASING (NUMBER 61) LTD | 10 mar 1989 | 10 mar 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di FITZGEORGE DECEMBER (5) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 apr 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per FITZGEORGE DECEMBER (5) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2020 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2019 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 30 apr 2018, non revisionato | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2018 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 30 apr 2017, non revisionato | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2016 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da All Seasons Church Road Cookham Maidenhead Berkshire SL6 9PG England a All Seasons Church Road Cookham Maidenhead Berkshire SL6 9PG in data 09 mar 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da The Courtlands 8 Plymouth Drive Barnt Green Worcestershire B45 8JB a All Seasons Church Road Cookham Maidenhead Berkshire SL6 9PG in data 09 mar 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2015 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Portavo Management Limited come amministratore in data 14 gen 2016 | 2 pagine | AP02 | ||||||||||
Nomina di Mr Frederick Derek Tughan come amministratore in data 09 dic 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ronald Ernest Woods come amministratore in data 09 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jill Louise Robinson come amministratore in data 09 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jill Louise Robinson come segretario in data 09 dic 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 apr 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mar 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 apr 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di FITZGEORGE DECEMBER (5) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUGHAN, Frederick David | Amministratore | Church Road Cookham SL6 9PG Maidenhead All Seasons Berkshire England | Northern Ireland | British | 203412740001 | |||||||||
| PORTAVO MANAGEMENT LIMITED | Amministratore | Hill Street BT1 2LB Belfast 38 Northern Ireland |
| 204342110001 | ||||||||||
| AMEY, Michelle | Segretario | 4 Holme Road RM11 3QS Hornchurch Essex | British | 57746950002 | ||||||||||
| CLIFTON, Roger Cheston | Segretario | 8 Sandy Close GU22 8BQ Woking Surrey | British | 8089410002 | ||||||||||
| DIXON, Susan Elizabeth | Segretario | Flat 1 29-31 Dingley Place EC1 8BR London | British | 90007990001 | ||||||||||
| LAYCOCK, Rufus | Segretario | Burghley Avenue KT3 4SW New Malden 33 Surrey | British | 7584610001 | ||||||||||
| LONGCROFT, Peter Leonard | Segretario | 4 Lakeside Close Reydon IP18 6YA Southwold Suffolk | British | 32431030003 | ||||||||||
| MARSHALL, Ian Bruce | Segretario | Hungershall Lodge Hungershall Park TN4 8ND Tunbridge Wells Kent | British | 752600001 | ||||||||||
| MARSHALL, Ian Bruce | Segretario | Hungershall Lodge Hungershall Park TN4 8ND Tunbridge Wells Kent | British | 752600001 | ||||||||||
| MORRISON, Audrey | Segretario | 20 Bliss Avenue SG17 5SF Shefford Bedfordshire | British | 44972470001 | ||||||||||
| ROBINSON, Jill Louise | Segretario | 81 Old Gansha Road BT19 7HA Bangor Down N Ireland | British | 114372460001 | ||||||||||
| YOUNG, Lorraine Elizabeth | Segretario | 3 Vaughan Avenue TN10 4EB Tonbridge Kent | British | 45988970001 | ||||||||||
| AIKEN, Neil Gordon | Amministratore | The Birches 14 Stradbroke Drive IG7 5QX Chigwell Essex | United Kingdom | British | 43380390001 | |||||||||
| BARKER, Nicholas David | Amministratore | Benhall Place Low Street, Benhall IP17 1JF Saxmundham Suffolk | United Kingdom | British | 41800250004 | |||||||||
| BEEVER, David Milton Maxwell | Amministratore | Warren Farm House South Drive GU25 4JS Wentworth Surrey | United Kingdom | British | 35274610001 | |||||||||
| CHARLTON, John Michael | Amministratore | Dunstone 5 Broomfield Ride KT22 0LR Oxshott Surrey | England | British | 73081460001 | |||||||||
| DEDMAN, John Arnold | Amministratore | Heather Court Broomhall Road GU21 4AP Woking Surrey | British | 102358040001 | ||||||||||
| FOSSE, Finn Erik | Amministratore | 5 Orchard Lane SW20 0SE London | Norwegian | 118721520001 | ||||||||||
| HARDWICK, Michael Robert | Amministratore | The Laurels 9 Patmore Lane Burwood Park KT12 5DX Walton On Thames Surrey | British | 71971030001 | ||||||||||
| INNES, Michael Ernest Ashley | Amministratore | Woodlands 4 Winchelsey Rise CR2 7BN South Croydon Surrey | British | 41782380001 | ||||||||||
| LAYCOCK, Rufus | Amministratore | Burghley Avenue KT3 4SW New Malden 33 Surrey | United Kingdom | British | 7584610001 | |||||||||
| LEATHES, Simon William De Mussenden | Amministratore | 19 Lauriston Road Wimbledon SW19 4TJ London | British | 9808160001 | ||||||||||
| MARSHALL, Kenneth Richard Paul | Amministratore | Holford House North Chailey BN8 4DT Lewes East Sussex | British | 4863570001 | ||||||||||
| MYALL, Paul Geoffrey | Amministratore | 10 Latimer Road Wimbledon SW19 1EP London | New Zealander/British | 41747120001 | ||||||||||
| O'HAIRE, Cormac Patrick Thomas | Amministratore | 1 Windermere Road Ealing W5 4TJ London | Irish | 56976610001 | ||||||||||
| RANDALL, Colin | Amministratore | 3 Raglan Court CR2 6NT South Croydon Surrey | British | 76844920001 | ||||||||||
| RANDALL, Colin | Amministratore | 3 Raglan Court CR2 6NT South Croydon Surrey | British | 76844920001 | ||||||||||
| READ, Philip David | Amministratore | 35 Elwill Way BR3 3AB Beckenham Kent | United Kingdom | British | 81624400001 | |||||||||
| ROBINSON, Jill Louise | Amministratore | 81 Old Gansha Road BT19 7HA Bangor Down N Ireland | Northern Ireland | British | 114372460001 | |||||||||
| STEWART-ROBERTS, Andrew Kerr | Amministratore | 48 Grove Lane Camberwell SE5 8ST London | British | 456970001 | ||||||||||
| TUGHAN, Frederick David | Amministratore | Portavo House 176 Warren Road BT21 0PJ Donaghadee Co Down | Northern Ireland | British | 203412740001 | |||||||||
| WHITING, Kevin John | Amministratore | 30 Gloucester Circus Greenwich SE10 8RY London | British | 43709920002 | ||||||||||
| WOODS, Ronald Ernest | Amministratore | 8 Plymouth Drive B45 8JB Barnt Green The Courtlands Worcestershire | United Kingdom | British | 149388120001 | |||||||||
| WOODS, Ronald Ernest | Amministratore | All Seasons House Sterlings Field SL6 9PG Cookham Dean Berks | United Kingdom | British | 149388120001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di FITZGEORGE DECEMBER (5) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almira Holdings Ltd | 06 apr 2016 | Rosemary Street BT1 1QD Belfast 20 Northern Ireland | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
| |||||||
FITZGEORGE DECEMBER (5) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Security assignment made between the company formerly known as dresdner kleinwort wasserstein leasing december (5) limited and lombard north central PLC | Creato il 29 giu 2001 Consegnato il 10 lug 2001 | In corso | Importo garantito All obligations whether actual,contingent,present and/or future obligations and liabilities of the assignors, to the chargee pursuant to the loan agreement and to this assignment | |
Brevi particolari All of the right title benefit and interest of the assignor whatsoever present and future in the assigned rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security assignment of put option made between the company formerly known as kleinwort wasserstein leasing december (5) limited and lombard north central PLC | Creato il 29 giu 2001 Consegnato il 10 lug 2001 | In corso | Importo garantito All obligations whether actual,contingent,present and/or future obligations and liabilities of the assignors,to the chargee under or pursuant to the loan agreement and to the assignment | |
Brevi particolari Right title and interest in the option agreement dated 29 june 2001 in relation to lease agreements entered into with south west water limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0