AMEY DATEL TECHNOLOGY LIMITED

AMEY DATEL TECHNOLOGY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAMEY DATEL TECHNOLOGY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02361176
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AMEY DATEL TECHNOLOGY LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova AMEY DATEL TECHNOLOGY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AMEY DATEL TECHNOLOGY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DATEL TECHNOLOGY LIMITED25 mag 198925 mag 1989
    GRAMHIT LIMITED15 mar 198915 mar 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di AMEY DATEL TECHNOLOGY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per AMEY DATEL TECHNOLOGY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 giu 2012

    Stato del capitale al 21 giu 2012

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    8 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Melvyn Ewell il 30 nov 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Sherard Secretariat Services Limited il 01 ott 2009

    2 pagineCH04

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    10 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    10 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine190

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    10 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    4 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    10 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di AMEY DATEL TECHNOLOGY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione5615519
    109588620001
    EWELL, Melvyn
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector61515760002
    NELSON, Andrew Latham
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector36191090003
    HUI, Carol
    Old Barn
    Petworth Road Witley
    GU8 5QW Godalming
    Surrey
    Segretario
    Old Barn
    Petworth Road Witley
    GU8 5QW Godalming
    Surrey
    British72371980001
    LAWTON, Graham
    25 Alder Grove
    FY6 8EJ Poulton Le Fylde
    Lancashire
    Segretario
    25 Alder Grove
    FY6 8EJ Poulton Le Fylde
    Lancashire
    British2382160001
    PUGH, Graham John
    The Windmill Mill Lane
    Wrea Green
    PR4 2WP Preston
    Lancashire
    Segretario
    The Windmill Mill Lane
    Wrea Green
    PR4 2WP Preston
    Lancashire
    British24512450001
    PUGH, Jean Christina
    The Windmill
    Mill Lane
    Preston
    Lancs
    Segretario
    The Windmill
    Mill Lane
    Preston
    Lancs
    British34968400001
    SMITH, Michael John
    63 Fields Road
    Haslingden
    BB4 6QA Rossendale
    Lancashire
    Segretario
    63 Fields Road
    Haslingden
    BB4 6QA Rossendale
    Lancashire
    British61711420001
    TETLOW, John Richard
    Whittaker Court, Gawsworth New Hall
    Church Lane, Gawsworth
    SK11 9RQ Macclesfield
    Cheshire
    Segretario
    Whittaker Court, Gawsworth New Hall
    Church Lane, Gawsworth
    SK11 9RQ Macclesfield
    Cheshire
    BritishCompany Secretary68445840001
    ADAMS, Richard Hawthorn
    Bramley Cottage Coppice Hill
    Chalford
    GL6 8DZ Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    Bramley Cottage Coppice Hill
    Chalford
    GL6 8DZ Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritishCivil Servant56940900001
    BATCHELOR, Graeme Warwick
    2 Brookway
    Wrea Green
    PR4 2NU Preston
    Lancashire
    Amministratore
    2 Brookway
    Wrea Green
    PR4 2NU Preston
    Lancashire
    BritishManager58892340002
    BRADBURY, Richard George
    Beech Cottage Beech Lane
    WA6 6LP Norley
    Cheshire
    Amministratore
    Beech Cottage Beech Lane
    WA6 6LP Norley
    Cheshire
    BritishGroup Commercial Director42234330002
    ENTWISTLE, Richard William
    Crossways Crays Pond
    RG8 7QE Goring Heath
    Oxfordshire
    Amministratore
    Crossways Crays Pond
    RG8 7QE Goring Heath
    Oxfordshire
    BritishDirector50174710001
    ENTWISTLE, Richard William
    Crossways Crays Pond
    RG8 7QE Goring Heath
    Oxfordshire
    Amministratore
    Crossways Crays Pond
    RG8 7QE Goring Heath
    Oxfordshire
    BritishDirector50174710001
    FARRER, Andrew Peter
    21 Upper Westby Avenue
    Lytham St Annes
    FY8 5NH Lancashire
    Amministratore
    21 Upper Westby Avenue
    Lytham St Annes
    FY8 5NH Lancashire
    BritishTechnical Director56447940002
    HARRIS, Howard Daniel
    The Oaks Station Road
    Singleton
    FY6 8LG Poulton Le Fylde
    Lancashire
    Amministratore
    The Oaks Station Road
    Singleton
    FY6 8LG Poulton Le Fylde
    Lancashire
    BritishCommercial Director44607740001
    HARRIS, Howard Daniel
    The Oaks Station Road
    Singleton
    FY6 8LG Poulton Le Fylde
    Lancashire
    Amministratore
    The Oaks Station Road
    Singleton
    FY6 8LG Poulton Le Fylde
    Lancashire
    BritishTechnical Director44607740001
    KAYSER, Michael Arthur
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    Amministratore
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director141893610001
    LEO, Jose
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    SpanishGroup Finance Director93348510004
    MILLER, David John
    1 Asmara Road
    NW2 3SS London
    Amministratore
    1 Asmara Road
    NW2 3SS London
    United KingdomBritishChartered Accountant152304230002
    MOGG, Charles Michael
    Ladywood Stray
    Church Road, Wilmcote
    CV37 9XD Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Ladywood Stray
    Church Road, Wilmcote
    CV37 9XD Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    BritishCivil Engineer And Company Dir87961010001
    MORRIS, Keith Peter
    10 Laverton Road
    FY8 1EW Lytham St Annes
    Lancashire
    Amministratore
    10 Laverton Road
    FY8 1EW Lytham St Annes
    Lancashire
    BritishCommercial Director43135960001
    MURAD, Simon William
    The Rookeries
    Roundabout Copse
    RH20 2RB West Chiltington
    West Sussex
    Amministratore
    The Rookeries
    Roundabout Copse
    RH20 2RB West Chiltington
    West Sussex
    United KingdomBritishDirector75114990001
    PEAT, Stephen Hedley
    25 Canynge Square
    Clifton
    BS8 3LB Bristol
    Avon
    Amministratore
    25 Canynge Square
    Clifton
    BS8 3LB Bristol
    Avon
    BritishDirector70137370001
    POWERS, Glenn Patrick
    23 Sefton Drive
    M28 2NG Worsley
    Manchester
    Amministratore
    23 Sefton Drive
    M28 2NG Worsley
    Manchester
    BritishCompany Director72486520001
    PUGH, Graham John
    The Windmill Mill Lane
    Wrea Green
    PR4 2WP Preston
    Lancashire
    Amministratore
    The Windmill Mill Lane
    Wrea Green
    PR4 2WP Preston
    Lancashire
    BritishManaging Director24512450001
    REEVES, William Thomas
    3 The Coppins
    Wildwood
    ST17 4QB Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    3 The Coppins
    Wildwood
    ST17 4QB Stafford
    Staffordshire
    BritishCompany Director93316550001
    ROBINSON, John Hamilton
    Bull Rush House 8 Kennett Place
    Chilton Foliat
    RG17 0TB Hungerford
    Berkshire
    Amministratore
    Bull Rush House 8 Kennett Place
    Chilton Foliat
    RG17 0TB Hungerford
    Berkshire
    AmericanEngineer69410760003
    ROWAN, Darren
    37 Leach Lane
    FY8 3AN Lytham St Annes
    Lancashire
    Amministratore
    37 Leach Lane
    FY8 3AN Lytham St Annes
    Lancashire
    BritishManager59425480001
    SIMPSON, Alan Keith
    4 Riversleigh Avenue
    FY8 5QZ Lytham St Annes
    Lancashire
    Amministratore
    4 Riversleigh Avenue
    FY8 5QZ Lytham St Annes
    Lancashire
    BritishDirector34652910001
    STAPLES, Brian Lynn
    Pendle House
    Castle Hill Prestbury
    SK10 4AR Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    Pendle House
    Castle Hill Prestbury
    SK10 4AR Macclesfield
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector55479560003
    SWEENEY, John Trevor
    6 Scarlet Oaks
    Portsmouth Road
    GU15 1RD Camberley
    Surrey
    Amministratore
    6 Scarlet Oaks
    Portsmouth Road
    GU15 1RD Camberley
    Surrey
    BritishChartered Accountant70137390001
    WILLIAMSON, Stephen
    120 Warbreck Hill Road
    FY2 0TR Blackpool
    Lancashire
    Amministratore
    120 Warbreck Hill Road
    FY2 0TR Blackpool
    Lancashire
    BritishTechnical Director36188290001

    AMEY DATEL TECHNOLOGY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating security document
    Creato il 14 mar 2003
    Consegnato il 26 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee on Behalf of the Finance Parties
    Transazioni
    • 26 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 giu 1998
    Consegnato il 23 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a land and buildings on the north side of watery lane preston t/n's LA481137 and LA323274. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 giu 1998
    Consegnato il 17 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 23 dic 1993
    Consegnato il 07 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a land and buildings on the north side of watery lane preston lancs t/no LA481137 and la 323274 and the proceeds of sale thereof with the assigns the goodwill of the business full benefit of all licences together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 18 gen 1991
    Consegnato il 25 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H the semi-detached office and showroom and appurttenances at 323 clifton drive south lytham st annes lancashire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 05 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 16 nov 1990
    Consegnato il 22 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 05 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 mar 1990
    Consegnato il 28 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 28 mar 1990Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0