DISTRICT ENERGY LIMITED

DISTRICT ENERGY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDISTRICT ENERGY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02362017
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DISTRICT ENERGY LIMITED?

    • Produzione di energia elettrica (35110) / Fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata

    Dove si trova DISTRICT ENERGY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    6th Floor, Radcliffe House
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DISTRICT ENERGY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BRITISH ENERGY MERCHANT GENERATION LIMITED19 mar 199919 mar 1999
    BRITISH ENERGY INVESTMENT (NO.4) LIMITED26 feb 199926 feb 1999
    NE GENERATION LIMITED16 feb 199416 feb 1994
    NUCLEAR ELECTRIC (1990) LTD.06 apr 199006 apr 1990
    SIGNKIT LIMITED16 mar 198916 mar 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di DISTRICT ENERGY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per DISTRICT ENERGY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di Mr Andrew Robert Koss come amministratore in data 03 ago 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nauman Ahmad come amministratore in data 03 ago 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Sam Kieron Wither come amministratore in data 30 nov 2019

    1 pagineTM01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough TS90 8WS

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough TS90 8WS

    1 pagineAD02

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    17 pagineAA

    Cessazione della carica di Paul David Tomlinson come amministratore in data 30 set 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough Cleveland TS90 8WS England a 6th Floor, Radcliffe House Blenheim Court Solihull B91 2AA in data 18 apr 2019

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Stephen Christopher Hands come segretario in data 01 apr 2019

    2 pagineAP03

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Uk Power Reserve Ltd Radcliffe House Blenheim Court Warwick Road Solihull West Midlands B91 2AA a Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough Cleveland TS90 8WS in data 18 apr 2019

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Andrew Joseph Mountford come segretario in data 01 apr 2019

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 mar 2018

    17 pagineAA

    Nomina di Mr Paul David Tomlinson come amministratore in data 12 feb 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Sriram Narayanan come amministratore in data 12 feb 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jonathan Peter Addis come amministratore in data 31 gen 2019

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 023620170007 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 023620170008 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Stephen Christopher Hands come amministratore in data 31 mag 2018

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di DISTRICT ENERGY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HANDS, Stephen Christopher
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    6th Floor, Radcliffe House
    England
    Segretario
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    6th Floor, Radcliffe House
    England
    257684290001
    HANDS, Stephen Christopher
    Wilton International
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    Amministratore
    Wilton International
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    EnglandBritish205116300001
    KOSS, Andrew Robert
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    6th Floor, Radcliffe House
    England
    Amministratore
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    6th Floor, Radcliffe House
    England
    EnglandEnglish157160710002
    ALLEN, Anthony
    7 Conway Road
    Hucclecote
    GL3 3PD Gloucester
    Segretario
    7 Conway Road
    Hucclecote
    GL3 3PD Gloucester
    British43845510001
    ARMOUR, Robert Malcolm
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Segretario
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    British50003350005
    ARMOUR, Robert Malcolm
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Segretario
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    British50003350005
    GRANT, Paul Robert
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    England
    Segretario
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    England
    170448160001
    LAWRIE, Karen Nicola
    Bishops Frome
    WR6 5AS Worcester
    Boscombe House
    Worcestershire
    Segretario
    Bishops Frome
    WR6 5AS Worcester
    Boscombe House
    Worcestershire
    British138732390001
    MELVILLE, John Rex
    Haileywood
    3 Birchen Lane
    RH16 1RY Haywards Heath
    West Sussex
    Segretario
    Haileywood
    3 Birchen Lane
    RH16 1RY Haywards Heath
    West Sussex
    British12057640001
    MOUNTFORD, Andrew Joseph
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    Segretario
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    244885560001
    SULLIVAN, Beverley Joyce
    Grange House Grange Park
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    Segretario
    Grange House Grange Park
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    British47891500002
    SULLIVAN, Beverley Joyce
    Grange House Grange Park
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    Segretario
    Grange House Grange Park
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    British47891500002
    ADDIS, Jonathan Peter
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    Amministratore
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    EnglandBritish260439420001
    AHMAD, Nauman
    Wilton International
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    Amministratore
    Wilton International
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    EnglandPakistani246516040001
    ALLEN, Anthony
    7 Conway Road
    Hucclecote
    GL3 3PD Gloucester
    Amministratore
    7 Conway Road
    Hucclecote
    GL3 3PD Gloucester
    British43845510001
    ARMOUR, Robert Malcolm
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Amministratore
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    United KingdomBritish50003350005
    BERESFORD, Nigel Stephen
    c/o Edf Energy
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    England
    Amministratore
    c/o Edf Energy
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    England
    United KingdomEnglish140458520001
    BILLINGHAM, Stephen Robert, Doctor
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Amministratore
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    British983300008
    BLISS, Simon Richard Weston
    Edgehill
    West Glen Road
    PA13 4PH Kilmalcolm
    Amministratore
    Edgehill
    West Glen Road
    PA13 4PH Kilmalcolm
    ScotlandBritish82638440001
    BROOKSHAW, Terry
    Saddlers Field
    Bowbridge Lane, Prestbury
    GL52 3BJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Saddlers Field
    Bowbridge Lane, Prestbury
    GL52 3BJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British78425070001
    CLEMENTS, Andrew Arthur
    27 Grange Court Road
    Westbury On Trym
    BS9 4DR Bristol
    Amministratore
    27 Grange Court Road
    Westbury On Trym
    BS9 4DR Bristol
    British52249820001
    COLEY, William Alfred
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Amministratore
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    British90266090006
    DOWN, Leonard Michael
    6 King Malcolm Close
    EH10 7JB Edinburgh
    Amministratore
    6 King Malcolm Close
    EH10 7JB Edinburgh
    British58057730001
    EMRICH, Timothy Wayne
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    England
    Amministratore
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    England
    United KingdomAmerican159180900001
    HOLLINS, Peter Thomas
    10d Kinnear Road
    EH3 5PE Edinburgh
    Amministratore
    10d Kinnear Road
    EH3 5PE Edinburgh
    British56803330002
    JEFFREY, Robin Campbell, Dr
    71d Partickhill Road
    G11 5AD Glasgow
    Amministratore
    71d Partickhill Road
    G11 5AD Glasgow
    British34426500002
    JOHNSON, Christopher Brian
    31 Merevale Road
    GL2 0QX Gloucester
    Amministratore
    31 Merevale Road
    GL2 0QX Gloucester
    United KingdomBritish46900180001
    KIRWAN, Michael Ralph
    18 Greenhill Gardens
    EH10 4BW Edinburgh
    Lothian
    Amministratore
    18 Greenhill Gardens
    EH10 4BW Edinburgh
    Lothian
    ScotlandBritish55649070001
    KIRWAN, Michael Ralph
    18 Greenhill Gardens
    EH10 4BW Edinburgh
    Lothian
    Amministratore
    18 Greenhill Gardens
    EH10 4BW Edinburgh
    Lothian
    ScotlandBritish55649070001
    KUSTERER, Thomas Andreas
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    Amministratore
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    United KingdomGerman137548090001
    LANGLEY, Michael James
    13 Nelson Street
    EH3 6LF Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    13 Nelson Street
    EH3 6LF Edinburgh
    Midlothian
    British70818670002
    LOUGH, Keith Geddes
    Lochside
    PA12 4JH Lochwinnoch
    Renfrewshire
    Amministratore
    Lochside
    PA12 4JH Lochwinnoch
    Renfrewshire
    United KingdomBritish101630860001
    LOW, Michael Brian John
    Grange House
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    Grange House
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    British76638420001
    MACDONALD, Jean Elizabeth
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Amministratore
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    ScotlandBritish4947170004
    MARSHALL, Richard Allan Jeffrey
    c/o British Energy
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o British Energy
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    EnglandBritish151085170001

    Chi sono le persone con controllo significativo di DISTRICT ENERGY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    6th Floor, Radcliffe House
    England
    06 apr 2016
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    6th Floor, Radcliffe House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleUk
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione7385282
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    DISTRICT ENERGY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 16 nov 2015
    Consegnato il 20 nov 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Aberaman park industrial estate aberaman aberdare t/no CYM18100. Please see image for details of further property charged.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 20 nov 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 gen 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 16 nov 2015
    Consegnato il 19 nov 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Aberaman park industrial eatate, aberaman, aberdare t/no CYM18100. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (in Its Capacity as Security Trustee)
    Transazioni
    • 19 nov 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 gen 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 ago 2014
    Consegnato il 20 ago 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 20 ago 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 19 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 ago 2014
    Consegnato il 20 ago 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 20 ago 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 19 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 14 gen 2005
    Consegnato il 17 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Sizewell power station and adjoining land suffolk t/no's SK160398,SK160390,SK160388 and SK155462, dungeness power station and adjoining land kent t/no 761827 hinkley point power station and adjoining land somerset t/no's ST127567 and st 127518 (for details of further properties charged please refer to form 395) first fixed charge all of its rights in and to the charged securities which are not scottish charge securities,floating charge,all its present and future assets,property,business,undertaking and uncalled capital and all rights under and in respect of any of the foregoing.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nuclear Generation Decommissioning Fund Limited
    Transazioni
    • 17 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 27 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of amendment
    Creato il 28 nov 2002
    Consegnato il 16 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due or to become due from each and every facility obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights under or in respect of the special accounts and all sums standing to the credit of such accounts and the intragroup receivables including all other assets and rights thereunder (fixed charge); floating charge over all future assets,property,business,undertaking, uncalled capital,rights and interests thereunder; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transazioni
    • 16 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 set 2002
    Consegnato il 09 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed security all its rights under or in respect of the assigned assets, its whole right, title and interest, including all rights of action past, present and future, in and to any assigned assets, its intagroup receivables, the special accounts. By way of first floating charge, all its present and future assets, property, business, undertaking and uncalled capital.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transazioni
    • 09 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0