DISTRICT ENERGY LIMITED
Panoramica
| Nome della società | DISTRICT ENERGY LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02362017 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DISTRICT ENERGY LIMITED?
- Produzione di energia elettrica (35110) / Fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata
Dove si trova DISTRICT ENERGY LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 6th Floor, Radcliffe House Blenheim Court B91 2AA Solihull England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di DISTRICT ENERGY LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BRITISH ENERGY MERCHANT GENERATION LIMITED | 19 mar 1999 | 19 mar 1999 |
| BRITISH ENERGY INVESTMENT (NO.4) LIMITED | 26 feb 1999 | 26 feb 1999 |
| NE GENERATION LIMITED | 16 feb 1994 | 16 feb 1994 |
| NUCLEAR ELECTRIC (1990) LTD. | 06 apr 1990 | 06 apr 1990 |
| SIGNKIT LIMITED | 16 mar 1989 | 16 mar 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di DISTRICT ENERGY LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per DISTRICT ENERGY LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Nomina di Mr Andrew Robert Koss come amministratore in data 03 ago 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Nauman Ahmad come amministratore in data 03 ago 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Sam Kieron Wither come amministratore in data 30 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough TS90 8WS | 1 pagine | AD03 | ||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough TS90 8WS | 1 pagine | AD02 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 17 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Paul David Tomlinson come amministratore in data 30 set 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough Cleveland TS90 8WS England a 6th Floor, Radcliffe House Blenheim Court Solihull B91 2AA in data 18 apr 2019 | 1 pagine | AD01 | ||
Nomina di Mr Stephen Christopher Hands come segretario in data 01 apr 2019 | 2 pagine | AP03 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Uk Power Reserve Ltd Radcliffe House Blenheim Court Warwick Road Solihull West Midlands B91 2AA a Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough Cleveland TS90 8WS in data 18 apr 2019 | 1 pagine | AD01 | ||
Cessazione della carica di Andrew Joseph Mountford come segretario in data 01 apr 2019 | 1 pagine | TM02 | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2018 | 17 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Paul David Tomlinson come amministratore in data 12 feb 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Sriram Narayanan come amministratore in data 12 feb 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Jonathan Peter Addis come amministratore in data 31 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Soddisfazione dell'onere 023620170007 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 023620170008 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Stephen Christopher Hands come amministratore in data 31 mag 2018 | 2 pagine | AP01 | ||
Chi sono gli amministratori di DISTRICT ENERGY LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANDS, Stephen Christopher | Segretario | Blenheim Court B91 2AA Solihull 6th Floor, Radcliffe House England | 257684290001 | |||||||
| HANDS, Stephen Christopher | Amministratore | Wilton International TS90 8WS Middlesbrough Sembcorp Uk Headquarters United Kingdom | England | British | 205116300001 | |||||
| KOSS, Andrew Robert | Amministratore | Blenheim Court B91 2AA Solihull 6th Floor, Radcliffe House England | England | English | 157160710002 | |||||
| ALLEN, Anthony | Segretario | 7 Conway Road Hucclecote GL3 3PD Gloucester | British | 43845510001 | ||||||
| ARMOUR, Robert Malcolm | Segretario | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | British | 50003350005 | ||||||
| ARMOUR, Robert Malcolm | Segretario | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | British | 50003350005 | ||||||
| GRANT, Paul Robert | Segretario | c/o Uk Power Reserve Ltd Blenheim Court Warwick Road B91 2AA Solihull Radcliffe House West Midlands England | 170448160001 | |||||||
| LAWRIE, Karen Nicola | Segretario | Bishops Frome WR6 5AS Worcester Boscombe House Worcestershire | British | 138732390001 | ||||||
| MELVILLE, John Rex | Segretario | Haileywood 3 Birchen Lane RH16 1RY Haywards Heath West Sussex | British | 12057640001 | ||||||
| MOUNTFORD, Andrew Joseph | Segretario | c/o Uk Power Reserve Ltd Blenheim Court Warwick Road B91 2AA Solihull Radcliffe House West Midlands | 244885560001 | |||||||
| SULLIVAN, Beverley Joyce | Segretario | Grange House Grange Park Somerford Keynes GL7 6EW Cirencester Gloucestershire | British | 47891500002 | ||||||
| SULLIVAN, Beverley Joyce | Segretario | Grange House Grange Park Somerford Keynes GL7 6EW Cirencester Gloucestershire | British | 47891500002 | ||||||
| ADDIS, Jonathan Peter | Amministratore | c/o Uk Power Reserve Ltd Blenheim Court Warwick Road B91 2AA Solihull Radcliffe House West Midlands | England | British | 260439420001 | |||||
| AHMAD, Nauman | Amministratore | Wilton International TS90 8WS Middlesbrough Sembcorp Uk Headquarters United Kingdom | England | Pakistani | 246516040001 | |||||
| ALLEN, Anthony | Amministratore | 7 Conway Road Hucclecote GL3 3PD Gloucester | British | 43845510001 | ||||||
| ARMOUR, Robert Malcolm | Amministratore | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | United Kingdom | British | 50003350005 | |||||
| BERESFORD, Nigel Stephen | Amministratore | c/o Edf Energy Grosvenor Place SW1X 7EN London 40 England | United Kingdom | English | 140458520001 | |||||
| BILLINGHAM, Stephen Robert, Doctor | Amministratore | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | British | 983300008 | ||||||
| BLISS, Simon Richard Weston | Amministratore | Edgehill West Glen Road PA13 4PH Kilmalcolm | Scotland | British | 82638440001 | |||||
| BROOKSHAW, Terry | Amministratore | Saddlers Field Bowbridge Lane, Prestbury GL52 3BJ Cheltenham Gloucestershire | British | 78425070001 | ||||||
| CLEMENTS, Andrew Arthur | Amministratore | 27 Grange Court Road Westbury On Trym BS9 4DR Bristol | British | 52249820001 | ||||||
| COLEY, William Alfred | Amministratore | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | British | 90266090006 | ||||||
| DOWN, Leonard Michael | Amministratore | 6 King Malcolm Close EH10 7JB Edinburgh | British | 58057730001 | ||||||
| EMRICH, Timothy Wayne | Amministratore | c/o Uk Power Reserve Ltd Blenheim Court Warwick Road B91 2AA Solihull Radcliffe House West Midlands England | United Kingdom | American | 159180900001 | |||||
| HOLLINS, Peter Thomas | Amministratore | 10d Kinnear Road EH3 5PE Edinburgh | British | 56803330002 | ||||||
| JEFFREY, Robin Campbell, Dr | Amministratore | 71d Partickhill Road G11 5AD Glasgow | British | 34426500002 | ||||||
| JOHNSON, Christopher Brian | Amministratore | 31 Merevale Road GL2 0QX Gloucester | United Kingdom | British | 46900180001 | |||||
| KIRWAN, Michael Ralph | Amministratore | 18 Greenhill Gardens EH10 4BW Edinburgh Lothian | Scotland | British | 55649070001 | |||||
| KIRWAN, Michael Ralph | Amministratore | 18 Greenhill Gardens EH10 4BW Edinburgh Lothian | Scotland | British | 55649070001 | |||||
| KUSTERER, Thomas Andreas | Amministratore | Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London 40 United Kingdom | United Kingdom | German | 137548090001 | |||||
| LANGLEY, Michael James | Amministratore | 13 Nelson Street EH3 6LF Edinburgh Midlothian | British | 70818670002 | ||||||
| LOUGH, Keith Geddes | Amministratore | Lochside PA12 4JH Lochwinnoch Renfrewshire | United Kingdom | British | 101630860001 | |||||
| LOW, Michael Brian John | Amministratore | Grange House Somerford Keynes GL7 6EW Cirencester Gloucestershire | British | 76638420001 | ||||||
| MACDONALD, Jean Elizabeth | Amministratore | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | Scotland | British | 4947170004 | |||||
| MARSHALL, Richard Allan Jeffrey | Amministratore | c/o British Energy Grosvenor Place SW1X 7EN London 40 United Kingdom | England | British | 151085170001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di DISTRICT ENERGY LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uk Power Reserve Ltd | 06 apr 2016 | Blenheim Court B91 2AA Solihull 6th Floor, Radcliffe House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
DISTRICT ENERGY LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 16 nov 2015 Consegnato il 20 nov 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Aberaman park industrial estate aberaman aberdare t/no CYM18100. Please see image for details of further property charged. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 16 nov 2015 Consegnato il 19 nov 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Aberaman park industrial eatate, aberaman, aberdare t/no CYM18100. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 13 ago 2014 Consegnato il 20 ago 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 13 ago 2014 Consegnato il 20 ago 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 14 gen 2005 Consegnato il 17 gen 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Sizewell power station and adjoining land suffolk t/no's SK160398,SK160390,SK160388 and SK155462, dungeness power station and adjoining land kent t/no 761827 hinkley point power station and adjoining land somerset t/no's ST127567 and st 127518 (for details of further properties charged please refer to form 395) first fixed charge all of its rights in and to the charged securities which are not scottish charge securities,floating charge,all its present and future assets,property,business,undertaking and uncalled capital and all rights under and in respect of any of the foregoing.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of amendment | Creato il 28 nov 2002 Consegnato il 16 dic 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All obligations and liabilities due or to become due from each and every facility obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All rights under or in respect of the special accounts and all sums standing to the credit of such accounts and the intragroup receivables including all other assets and rights thereunder (fixed charge); floating charge over all future assets,property,business,undertaking, uncalled capital,rights and interests thereunder; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 26 set 2002 Consegnato il 09 ott 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of fixed security all its rights under or in respect of the assigned assets, its whole right, title and interest, including all rights of action past, present and future, in and to any assigned assets, its intagroup receivables, the special accounts. By way of first floating charge, all its present and future assets, property, business, undertaking and uncalled capital.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0