ARRIVA DERBY LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ARRIVA DERBY LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02362274 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ARRIVA DERBY LIMITED?
- Altri trasporti passeggeri urbani, suburbani o metropolitani via terra (non metropolitana o sistemi simili) (49319) / Trasporto e stoccaggio
- Operazione di taxi (49320) / Trasporto e stoccaggio
Dove si trova ARRIVA DERBY LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York North Yorkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ARRIVA DERBY LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| DERBY CITY TRANSPORT LIMITED | 15 set 1989 | 15 set 1989 |
| DARTPINE LIMITED | 16 mar 1989 | 16 mar 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ARRIVA DERBY LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per ARRIVA DERBY LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Arriva (2007) Limited come persona con controllo significativo il 10 nov 2017 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 11 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP a 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor York North Yorkshire YO30 4XG in data 14 mar 2017 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon William Mathieson come amministratore in data 27 giu 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Anthony Bowler come amministratore in data 27 giu 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Robert James Cheveaux come amministratore in data 27 giu 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Antony Bowd come amministratore in data 27 giu 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Lorna Edwards come amministratore in data 27 giu 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mark Antony Bowd come amministratore in data 22 gen 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Charles Barlow come amministratore in data 27 nov 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alexander Donald Perry come amministratore in data 31 ago 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark David James Yexley come amministratore in data 03 lug 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Simon William Mathieson il 28 apr 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Matthew Evans come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 mar 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di ARRIVA DERBY LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWARDS, Lorna | Segretario | James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York 11 Clifton Moor Business Village North Yorkshire | 183720730001 | |||||||
| EDWARDS, Lorna | Amministratore | James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York 11 Clifton Moor Business Village North Yorkshire | England | British | 205425080001 | |||||
| BOWLER, Richard Anthony | Segretario | 4 Waterfield Road Cropston LE7 7HN Leicester | British | 35116070001 | ||||||
| DAVIES, Elizabeth Anne | Segretario | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | British | 102907000002 | ||||||
| JARRATT, Andrew Howard | Segretario | Thatched Cottage Church Lane Attenborough NG9 6AS Nottingham Nottinghamshire | British | 1860730001 | ||||||
| TURNER, David Paul | Segretario | 139 Eastern Way Darras Hall Ponteland NE20 9RH Newcastle Upon Tyne | British | 48937720001 | ||||||
| BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED | Segretario | 54 Endless Street SP1 3UH Salisbury Wiltshire | 42985760001 | |||||||
| BARLOW, John Charles | Amministratore | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 66466620003 | |||||
| BAXTER, Barry James | Amministratore | 5 Denver Fold ST17 9XE Stafford Staffordshire | British | 83122700001 | ||||||
| BAYFIELD, Stephen | Amministratore | Windy Ridge Riverside Close Stoford SP2 0PX Salisbury Wiltshire | British | 42058550001 | ||||||
| BAYFIELD, Stephen | Amministratore | Windy Ridge Riverside Close Stoford SP2 0PX Salisbury Wiltshire | British | 42058550001 | ||||||
| BICKLE, Kenneth | Amministratore | Langton Cottage Roston DE6 2EH Ashbourne Derbyshire | British | 3036960002 | ||||||
| BOWD, Mark Antony | Amministratore | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 204447910001 | |||||
| BOWD, Mark Antony | Amministratore | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 204447910001 | |||||
| BOWLER, Richard Anthony | Amministratore | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 35116070003 | |||||
| BOWLER, Richard Charles | Amministratore | 23b Brazenose Driftway Cowley OX4 2QY Oxford | British | 51739150001 | ||||||
| CHALLANDS, John Frank | Amministratore | 218 Caxton Street Sunnyhill DE23 7RB Derby Derbyshire | British | 12008050001 | ||||||
| CHEVEAUX, Robert James | Amministratore | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | Wales | British | 182114820001 | |||||
| CLARKE, Kenneth Barry | Amministratore | 2 Sherwood Drive WF2 7QT Wakefield West Yorkshire | British | 76952760002 | ||||||
| CLAYTON, Stephen John | Amministratore | New Hall Farmhouse Fanhams Hall Road Newhall Green Wareside SG12 7SD Ware Hertfordshire | England | British | 46866840005 | |||||
| CUMMING, Graham Jackson | Amministratore | Tudor House 19 Ashpole Furlong Loughton MK5 8EA Milton Keynes | British | 22410440002 | ||||||
| DYBALL, Richard Charles | Amministratore | 110 Upper Harlestone NN7 4EL Northampton | British | 33781930001 | ||||||
| EDGE, Christopher | Amministratore | 46 Howards Lane Putney SW15 6NJ London | British | 11465390001 | ||||||
| EVANS, Matthew John | Amministratore | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 197082950001 | |||||
| HARVEY, Peter | Amministratore | Chapel End 36 Main Street Swithland LE12 8TH Loughborough Leicestershire | United Kingdom | British | 30318040003 | |||||
| HIND, Robert Andrew | Amministratore | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | 21961900003 | |||||
| HIND, Robert Andrew | Amministratore | 173 Station Road Cropston LE7 7HH Leicester Leicestershire | British | 21961900001 | ||||||
| HOPKINS, Christian | Amministratore | Whitehill Avenue LU1 3SP Luton 46 Bedfordshire United Kingdom | England | British | 248192360001 | |||||
| JARRATT, Andrew Howard | Amministratore | Thatched Cottage Church Lane Attenborough NG9 6AS Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | 1860730001 | |||||
| JOHNSTONE, David Graham | Amministratore | 7 Pont Haugh Eland Mews Ponteland NE20 9XD Newcastle Upon Tyne | British | 95834280001 | ||||||
| JONES, Michael Adrian | Amministratore | 3 Old Shaftesbury Drive Old Blandford Road Harnham SP2 8QH Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 77984700001 | |||||
| LLOYD, Alfred | Amministratore | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 131555780001 | |||||
| LONSDALE, Stephen Philip | Amministratore | 5 Lintfort Picktree Farm Picktree NE38 9HX Chester Le Street County Durham | United Kingdom | British | 4971910001 | |||||
| MARTIN, David Robert | Amministratore | Bondwood Barn Repton Shrubs Bretby DE15 0RJ Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 6874440001 | |||||
| MARTIN, David Robert | Amministratore | Bondwood Barn Repton Shrubs Bretby DE15 0RJ Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 6874440001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ARRIVA DERBY LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arriva Uk Bus Holdings Limited | 06 apr 2016 | Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ARRIVA DERBY LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage | Creato il 10 ott 2008 Consegnato il 17 ott 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The mortgagor assigns by way of security and charges with full title guarantee all of its right title and interest in the goods specified in the schedule please see form 395 for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 09 set 1994 Consegnato il 23 set 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined therein) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over shares | Creato il 09 set 1994 Consegnato il 23 set 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the company to the first national bank of boston (as agent and trustee for the beneficiaries -as defined) under or pursuant to terms of the charge, | |
Brevi particolari All right title and interest in and under the shares as deposited or ot be deposited with the agent to secure the due payment and discharge of the indebtedness, the shares being all the ordinary shares held by the derby city transport limited (ordinary shares of £1 each, company name jolmino limited) please see doc for further details,. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter of charge and set-off over credit balances | Creato il 15 ago 1994 Consegnato il 31 ago 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the working capital facility letter dated 15TH august 1994 | |
Brevi particolari All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Credit agreement | Creato il 27 ago 1993 Consegnato il 07 set 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £81,585 due under the agreement | |
Brevi particolari All rights,title and interest in all sums payable.see form 395. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A credit agreement | Creato il 14 set 1992 Consegnato il 24 set 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £72203.04 under the agreement | |
Brevi particolari All its right title and interest under the insurance polices for details see form 395 ref:397. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 25 ago 1989 Consegnato il 14 set 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of legal mortgage over land & building situate at ascot drive derby and/or the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
ARRIVA DERBY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0