ARRIVA DERBY LIMITED

ARRIVA DERBY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàARRIVA DERBY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02362274
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ARRIVA DERBY LIMITED?

    • Altri trasporti passeggeri urbani, suburbani o metropolitani via terra (non metropolitana o sistemi simili) (49319) / Trasporto e stoccaggio
    • Operazione di taxi (49320) / Trasporto e stoccaggio

    Dove si trova ARRIVA DERBY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    North Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ARRIVA DERBY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DERBY CITY TRANSPORT LIMITED15 set 198915 set 1989
    DARTPINE LIMITED16 mar 198916 mar 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di ARRIVA DERBY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per ARRIVA DERBY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Modifica dei dettagli di Arriva (2007) Limited come persona con controllo significativo il 10 nov 2017

    2 paginePSC05

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP a 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor York North Yorkshire YO30 4XG in data 14 mar 2017

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 27 feb 2017

    LRESSP

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    12 pagineAA

    Cessazione della carica di Simon William Mathieson come amministratore in data 27 giu 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Richard Anthony Bowler come amministratore in data 27 giu 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robert James Cheveaux come amministratore in data 27 giu 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Antony Bowd come amministratore in data 27 giu 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Lorna Edwards come amministratore in data 27 giu 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 10 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 mar 2016

    Stato del capitale al 10 mar 2016

    • Capitale: GBP 3,108,173
    SH01

    Nomina di Mark Antony Bowd come amministratore in data 22 gen 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John Charles Barlow come amministratore in data 27 nov 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Alexander Donald Perry come amministratore in data 31 ago 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    9 pagineAA

    Cessazione della carica di Mark David James Yexley come amministratore in data 03 lug 2015

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Simon William Mathieson il 28 apr 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 10 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 mar 2015

    Stato del capitale al 10 mar 2015

    • Capitale: GBP 3,108,173
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    19 pagineAA

    Cessazione della carica di Matthew Evans come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 10 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 mar 2014

    Stato del capitale al 10 mar 2014

    • Capitale: GBP 3,108,173
    SH01

    Chi sono gli amministratori di ARRIVA DERBY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EDWARDS, Lorna
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    North Yorkshire
    Segretario
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    North Yorkshire
    183720730001
    EDWARDS, Lorna
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    North Yorkshire
    Amministratore
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    North Yorkshire
    EnglandBritish205425080001
    BOWLER, Richard Anthony
    4 Waterfield Road
    Cropston
    LE7 7HN Leicester
    Segretario
    4 Waterfield Road
    Cropston
    LE7 7HN Leicester
    British35116070001
    DAVIES, Elizabeth Anne
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Segretario
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    British102907000002
    JARRATT, Andrew Howard
    Thatched Cottage Church Lane
    Attenborough
    NG9 6AS Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Thatched Cottage Church Lane
    Attenborough
    NG9 6AS Nottingham
    Nottinghamshire
    British1860730001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    Segretario
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    42985760001
    BARLOW, John Charles
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish66466620003
    BAXTER, Barry James
    5 Denver Fold
    ST17 9XE Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    5 Denver Fold
    ST17 9XE Stafford
    Staffordshire
    British83122700001
    BAYFIELD, Stephen
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    British42058550001
    BAYFIELD, Stephen
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    British42058550001
    BICKLE, Kenneth
    Langton Cottage
    Roston
    DE6 2EH Ashbourne
    Derbyshire
    Amministratore
    Langton Cottage
    Roston
    DE6 2EH Ashbourne
    Derbyshire
    British3036960002
    BOWD, Mark Antony
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish204447910001
    BOWD, Mark Antony
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish204447910001
    BOWLER, Richard Anthony
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish35116070003
    BOWLER, Richard Charles
    23b Brazenose Driftway
    Cowley
    OX4 2QY Oxford
    Amministratore
    23b Brazenose Driftway
    Cowley
    OX4 2QY Oxford
    British51739150001
    CHALLANDS, John Frank
    218 Caxton Street
    Sunnyhill
    DE23 7RB Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    218 Caxton Street
    Sunnyhill
    DE23 7RB Derby
    Derbyshire
    British12008050001
    CHEVEAUX, Robert James
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    WalesBritish182114820001
    CLARKE, Kenneth Barry
    2 Sherwood Drive
    WF2 7QT Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    2 Sherwood Drive
    WF2 7QT Wakefield
    West Yorkshire
    British76952760002
    CLAYTON, Stephen John
    New Hall Farmhouse Fanhams Hall
    Road Newhall Green Wareside
    SG12 7SD Ware
    Hertfordshire
    Amministratore
    New Hall Farmhouse Fanhams Hall
    Road Newhall Green Wareside
    SG12 7SD Ware
    Hertfordshire
    EnglandBritish46866840005
    CUMMING, Graham Jackson
    Tudor House 19 Ashpole Furlong
    Loughton
    MK5 8EA Milton Keynes
    Amministratore
    Tudor House 19 Ashpole Furlong
    Loughton
    MK5 8EA Milton Keynes
    British22410440002
    DYBALL, Richard Charles
    110
    Upper Harlestone
    NN7 4EL Northampton
    Amministratore
    110
    Upper Harlestone
    NN7 4EL Northampton
    British33781930001
    EDGE, Christopher
    46 Howards Lane
    Putney
    SW15 6NJ London
    Amministratore
    46 Howards Lane
    Putney
    SW15 6NJ London
    British11465390001
    EVANS, Matthew John
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish197082950001
    HARVEY, Peter
    Chapel End 36 Main Street
    Swithland
    LE12 8TH Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Chapel End 36 Main Street
    Swithland
    LE12 8TH Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish30318040003
    HIND, Robert Andrew
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish21961900003
    HIND, Robert Andrew
    173 Station Road
    Cropston
    LE7 7HH Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    173 Station Road
    Cropston
    LE7 7HH Leicester
    Leicestershire
    British21961900001
    HOPKINS, Christian
    Whitehill Avenue
    LU1 3SP Luton
    46
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Whitehill Avenue
    LU1 3SP Luton
    46
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish248192360001
    JARRATT, Andrew Howard
    Thatched Cottage Church Lane
    Attenborough
    NG9 6AS Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Thatched Cottage Church Lane
    Attenborough
    NG9 6AS Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish1860730001
    JOHNSTONE, David Graham
    7 Pont Haugh
    Eland Mews Ponteland
    NE20 9XD Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    7 Pont Haugh
    Eland Mews Ponteland
    NE20 9XD Newcastle Upon Tyne
    British95834280001
    JONES, Michael Adrian
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish77984700001
    LLOYD, Alfred
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish131555780001
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Amministratore
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritish4971910001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish6874440001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish6874440001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ARRIVA DERBY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Admiral Way
    Doxford International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    1
    England
    06 apr 2016
    Admiral Way
    Doxford International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    1
    England
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione4166672
    Natura del controllo
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    ARRIVA DERBY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage
    Creato il 10 ott 2008
    Consegnato il 17 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The mortgagor assigns by way of security and charges with full title guarantee all of its right title and interest in the goods specified in the schedule please see form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 09 set 1994
    Consegnato il 23 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined therein)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The First National Bank of Boston"the Agent"
    Transazioni
    • 23 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares
    Creato il 09 set 1994
    Consegnato il 23 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to the first national bank of boston (as agent and trustee for the beneficiaries -as defined) under or pursuant to terms of the charge,
    Brevi particolari
    All right title and interest in and under the shares as deposited or ot be deposited with the agent to secure the due payment and discharge of the indebtedness, the shares being all the ordinary shares held by the derby city transport limited (ordinary shares of £1 each, company name jolmino limited) please see doc for further details,.
    Persone aventi diritto
    • The First National Bank of Boston,
    Transazioni
    • 23 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge and set-off over credit balances
    Creato il 15 ago 1994
    Consegnato il 31 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the working capital facility letter dated 15TH august 1994
    Brevi particolari
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement
    Creato il 27 ago 1993
    Consegnato il 07 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £81,585 due under the agreement
    Brevi particolari
    All rights,title and interest in all sums payable.see form 395.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 07 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A credit agreement
    Creato il 14 set 1992
    Consegnato il 24 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £72203.04 under the agreement
    Brevi particolari
    All its right title and interest under the insurance polices for details see form 395 ref:397.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limted
    Transazioni
    • 24 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 25 ago 1989
    Consegnato il 14 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage over land & building situate at ascot drive derby and/or the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ARRIVA DERBY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    27 feb 2017Inizio della liquidazione
    25 dic 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Adam Broadbent
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link
    YO30 4XG Clifton Moor
    York
    Praticante
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link
    YO30 4XG Clifton Moor
    York
    Ian James Royle
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    North Yorkshire
    Praticante
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    North Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0