MIDLANDS RADIO LIMITED

MIDLANDS RADIO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMIDLANDS RADIO LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02365381
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MIDLANDS RADIO LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MIDLANDS RADIO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Media House Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MIDLANDS RADIO LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MIDLANDS RADIO PLC03 lug 198903 lug 1989
    NECTARPLACE PLC23 mar 198923 mar 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di MIDLANDS RADIO LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per MIDLANDS RADIO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 feb 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2019

    8 pagineAA

    legacy

    38 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 feb 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Stato del capitale al 03 dic 2019

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 19 nov 2019

    • Capitale: GBP 4,001,000
    3 pagineSH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2018

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 feb 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 10 dic 2018

    • Capitale: GBP 1,000.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of the share premium account and cancellation of the capital redemption reserve 04/12/2018
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Anthony Keenan il 25 set 2018

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 feb 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di MIDLANDS RADIO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BAUER GROUP SECRETARIAT LIMITED
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Segretario
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione00944753
    159023720001
    FORD, Deidre Ann
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United KingdomBritish109666380002
    KEENAN, Paul Anthony
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritish243390510001
    VICKERY, Sarah Jane
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritish119137220004
    EVANS, Mark Roy
    17 Carless Avenue
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    17 Carless Avenue
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    British54693600002
    FLUET, Cliff
    11 Rokesly Avenue
    N8 8NS London
    Segretario
    11 Rokesly Avenue
    N8 8NS London
    British97684290001
    LOCKWOOD, John Trevor
    2 South Street
    Barrow-Upon-Soar
    LE12 8LZ Loughborough
    Leicestershire
    Segretario
    2 South Street
    Barrow-Upon-Soar
    LE12 8LZ Loughborough
    Leicestershire
    British9159330001
    MANNING, Richard Denley John
    39 Ash Lane
    BA5 2LR Wells
    Somerset
    Segretario
    39 Ash Lane
    BA5 2LR Wells
    Somerset
    British77961690001
    NAISMITH, Roy Cameron
    The Corn Store
    Manor Farm Barns
    SO24 9DH Old Alresford
    Hampshire
    Segretario
    The Corn Store
    Manor Farm Barns
    SO24 9DH Old Alresford
    Hampshire
    British50349450001
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Segretario
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    British3182530002
    SCHWARZ, Nathalie Esther
    Flat 10
    28 Belsize Avenue
    NW3 4AU London
    Segretario
    Flat 10
    28 Belsize Avenue
    NW3 4AU London
    British59245010001
    WHITE, Steven Nicholas
    35 Malting Close
    Stoke Goldington
    MK16 8NX Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Segretario
    35 Malting Close
    Stoke Goldington
    MK16 8NX Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    British43421870001
    ALLEN, Charles Lamb
    Victoria Road
    W8 5RH London
    71
    Amministratore
    Victoria Road
    W8 5RH London
    71
    United KingdomBritish142635780001
    BAGLEY, David Laurence
    19 Darnford Lane
    WS14 9RW Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    19 Darnford Lane
    WS14 9RW Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritish10984400001
    BATTMAN, Geoffrey Neil
    Wakeley Cottage The Green
    Tanworth In Arden
    B94 5AL Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Wakeley Cottage The Green
    Tanworth In Arden
    B94 5AL Solihull
    West Midlands
    British2326960001
    CHATAWAY, Christopher, Sir
    80 Maida Vale
    W9 1PR London
    Amministratore
    80 Maida Vale
    W9 1PR London
    British33231970001
    COLES, Ronald John
    Manor Farm Main Street
    Upton
    NG23 5ST Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Manor Farm Main Street
    Upton
    NG23 5ST Newark
    Nottinghamshire
    British9159370001
    CONNOLE, Michael Damien
    117 Thornbury Road
    TW7 4ND Isleworth
    Middlesex
    Amministratore
    117 Thornbury Road
    TW7 4ND Isleworth
    Middlesex
    EnglandIrish47934750001
    DAVIES, Paul Richard
    28 Roehampton Gate
    Roehampton
    SW15 5JS London
    Amministratore
    28 Roehampton Gate
    Roehampton
    SW15 5JS London
    British55332120002
    EVANS, Mark Roy
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritish54693600002
    EYRE, Richard Anthony
    31 Croham Park Avenue
    CR2 7HN South Croydon
    Surrey
    Amministratore
    31 Croham Park Avenue
    CR2 7HN South Croydon
    Surrey
    British5219910001
    HARRIS, Peter Jonathan
    381 Wimbledon Park Road
    SW19 6PE London
    Amministratore
    381 Wimbledon Park Road
    SW19 6PE London
    EnglandBritish40917640001
    LEADBEATER, Edward Timothy David
    Crofts Cottage Bagot Street
    Abbots Bromley
    WS15 3DB Rugeley
    Staffordshire
    Amministratore
    Crofts Cottage Bagot Street
    Abbots Bromley
    WS15 3DB Rugeley
    Staffordshire
    British34775550001
    LOCKWOOD, John Trevor
    2 South Street
    Barrow-Upon-Soar
    LE12 8LZ Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    2 South Street
    Barrow-Upon-Soar
    LE12 8LZ Loughborough
    Leicestershire
    British9159330001
    MANNING, Richard Denley John
    39 Ash Lane
    BA5 2LR Wells
    Somerset
    Amministratore
    39 Ash Lane
    BA5 2LR Wells
    Somerset
    United KingdomBritish77961690001
    MANSFIELD, David James
    16 Sudbrooke Road
    SW12 8TG London
    Amministratore
    16 Sudbrooke Road
    SW12 8TG London
    United KingdomBritish32585450001
    NAISMITH, Roy Cameron
    The Corn Store
    Manor Farm Barns
    SO24 9DH Old Alresford
    Hampshire
    Amministratore
    The Corn Store
    Manor Farm Barns
    SO24 9DH Old Alresford
    Hampshire
    EnglandBritish50349450001
    ORCHARD, Stephen
    Clements Meadow Cross Lane
    SN8 1JZ Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    Clements Meadow Cross Lane
    SN8 1JZ Marlborough
    Wiltshire
    EnglandBritish46952160003
    PALLOT, Wendy Monica
    The Willows
    Springwood Park
    TN11 9LZ Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    The Willows
    Springwood Park
    TN11 9LZ Tonbridge
    Kent
    United KingdomBritish74832570006
    PARK, Richard Francis Jackson
    55 Gloucester Crescent
    NW1 7EG London
    Amministratore
    55 Gloucester Crescent
    NW1 7EG London
    EnglandBritish75081070002
    PARKINSON, Arnold John
    50 Links Drive
    B91 2DL Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    50 Links Drive
    B91 2DL Solihull
    West Midlands
    British4093310001
    RILEY, Philip Stephen
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritish140085310001
    RUFUS, Ian Douglas
    55 Whitemoor Drive
    Monkspath
    B90 4UL Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    55 Whitemoor Drive
    Monkspath
    B90 4UL Solihull
    West Midlands
    British14867850005
    STANGER, Edward
    Whitewings Southmeads Road
    Oadby
    LE2 2LR Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    Whitewings Southmeads Road
    Oadby
    LE2 2LR Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritish10498070001
    STANLEY, Ailsa
    7 Trentdale Road
    Carlton
    NG4 1BU Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    7 Trentdale Road
    Carlton
    NG4 1BU Nottingham
    Nottinghamshire
    British10100130001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MIDLANDS RADIO LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    06 apr 2016
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom (England)
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06898191
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    MIDLANDS RADIO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 20 mag 2011
    Consegnato il 27 mag 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the note issuer and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Andrew Price
    Transazioni
    • 27 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 05 mag 2010
    Consegnato il 20 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from orion media limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Matthew Paul Ramsbottom
    Transazioni
    • 20 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 29 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 05 mag 2010
    Consegnato il 20 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from orion media limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Robert John Norman
    Transazioni
    • 20 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 05 mag 2010
    Consegnato il 18 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the note issuer to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Geoffrey Percy
    Transazioni
    • 18 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 05 mag 2010
    Consegnato il 13 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from orion media holdings limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Global Radio Group Limited
    Transazioni
    • 13 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 31 lug 2009
    Consegnato il 06 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transazioni
    • 06 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 31 lug 2009
    Consegnato il 06 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Philip Riley
    Transazioni
    • 06 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 31 lug 2009
    Consegnato il 06 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Antony Thomas Lloyd
    Transazioni
    • 06 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 31 lug 2009
    Consegnato il 05 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All land vested in or charged to the chargor, all fixtures and fittings attached to the land and all rents, all plant & machinery, contacts goodwill uncalled capital stocks shares patents copyrights and all other intellectual property rights. A floating charge over all the other property assets and rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Consideration letter between the company and the governor and company of the bank of scotland (in its capacity as security trustee for and on behalf of the security beneficiaries ("the security trustee")
    Creato il 21 feb 2001
    Consegnato il 08 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys as at 21 april 2000 or at any time thereafter owing to the security trustee and security beneficiaries by the principal debtors or any of them (where any company is also a principal debtor, the liability of such company to the security beneficiaries under the deed shall only have effect in relation to all the other principal debtors) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge
    Creato il 20 apr 2000
    Consegnato il 04 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the principal debtors (as defined) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All moneys as at 20 april 2000 or at any time thereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the books of the bank.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge
    Creato il 31 ott 1996
    Consegnato il 06 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the books of the bank.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge
    Creato il 04 apr 1995
    Consegnato il 07 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the comapny in the bank's books.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge
    Creato il 03 giu 1994
    Consegnato il 11 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 set 1991
    Consegnato il 20 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land to rear of radio house, aston road north birmingham west midlands park of t/n wk 97666.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 feb 1991
    Consegnato il 18 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & premises k/a radio house, 79-84 aston road north, aston, birmingham west midlands t/nwk 97666.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 feb 1991
    Consegnato il 15 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0