ANIX GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàANIX GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02367983
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ANIX GROUP LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ANIX GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4 Triton Square
    Triton Square
    NW1 3HG London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ANIX GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ANIX COMPUTERS LIMITED31 mag 199031 mag 1990
    ANIX LIMITED17 ott 198917 ott 1989
    DAPPLESTONE COMPUTERS LIMITED04 apr 198904 apr 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di ANIX GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per ANIX GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Remove company from register 12/09/2017
    RES13

    legacy

    3 pagineSH20

    Stato del capitale al 06 lug 2017

    • Capitale: GBP 1,270,606
    3 pagineSH19

    legacy

    3 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduction of the share premium account 29/06/2017
    RES13

    legacy

    3 pagineSH20

    Stato del capitale al 30 giu 2017

    • Capitale: GBP 1,207,606
    3 pagineSH19

    legacy

    3 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduction of share premium account 29/06/2017
    RES13

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 apr 2016

    Stato del capitale al 04 apr 2016

    • Capitale: GBP 1,270,606
    SH01

    Nomina di Mr Adrian Paul Gregory come amministratore in data 01 dic 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ursula Franziska Morgenstern come amministratore in data 01 dic 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    13 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    39 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Nomina di Mr Chad Sterling Harris come amministratore in data 01 lug 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di York Place Company Secretaries Limited come segretario in data 01 lug 2015

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr James Terrence John Loughrey come segretario in data 01 lug 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di James Michael Peffer come segretario in data 01 lug 2015

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Kevin Lee Taylor come amministratore in data 01 lug 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Steven Graham come amministratore in data 01 lug 2015

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di ANIX GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LOUGHREY, James Terrence John
    Triton Square
    NW1 3HG London
    4 Triton Square
    England
    Segretario
    Triton Square
    NW1 3HG London
    4 Triton Square
    England
    199012170001
    GREGORY, Adrian Paul
    Triton Square
    NW1 3HG London
    4 Triton Square
    England
    Amministratore
    Triton Square
    NW1 3HG London
    4 Triton Square
    England
    EnglandBritish203421120001
    HARRIS, Chad Sterling
    N. Haskell Ave.
    75204 Dallas
    2828
    Texas
    Usa
    Amministratore
    N. Haskell Ave.
    75204 Dallas
    2828
    Texas
    Usa
    United StatesAmerican199018650001
    PROCH, Michel Alain
    c/o Atos Se
    Quai Voltaire
    95877 Bezons
    River Ouest, 80
    France
    Amministratore
    c/o Atos Se
    Quai Voltaire
    95877 Bezons
    River Ouest, 80
    France
    FranceFrench167956020001
    BRICKMAN, Lowell K
    4024 Enclave Mesa Circle
    Austin
    Texas 78731
    Usa
    Segretario
    4024 Enclave Mesa Circle
    Austin
    Texas 78731
    Usa
    United States127222980001
    COOPER, Paul Antony
    35 Colston Avenue
    BS1 4TT Bristol
    Avon
    Segretario
    35 Colston Avenue
    BS1 4TT Bristol
    Avon
    British41111910001
    DJURIC, George
    Farm
    Watery Lane
    MK19 6DZ Beachampton
    Grange
    Buckinghamshire
    England
    Segretario
    Farm
    Watery Lane
    MK19 6DZ Beachampton
    Grange
    Buckinghamshire
    England
    British180779760001
    DUNKLEY, Michael Robert Paul
    53 Waterford Close
    Thornbury
    BS35 2HU Bristol
    Avon
    Segretario
    53 Waterford Close
    Thornbury
    BS35 2HU Bristol
    Avon
    British19347000001
    GILBERT, Julie Helen
    124 Ormonds Close
    Bradley Stoke
    BS32 0DY Bristol
    Segretario
    124 Ormonds Close
    Bradley Stoke
    BS32 0DY Bristol
    British86072560001
    PEFFER, James Michael
    N Haskell Avenue
    75204 Dallas
    2828
    Texas
    Usa
    Segretario
    N Haskell Avenue
    75204 Dallas
    2828
    Texas
    Usa
    167316460001
    SIMMONDS, Mark Oakley
    2 Glendower House
    Clifton Down
    BS8 3BP Bristol
    Avon
    Segretario
    2 Glendower House
    Clifton Down
    BS8 3BP Bristol
    Avon
    British44853240002
    BEACH SECRETARIES LIMITED
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    Segretario
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    76729800001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    York Place
    LS1 2EZ Leeds
    White Rose House 28a
    West Yorkshire
    Segretario
    York Place
    LS1 2EZ Leeds
    White Rose House 28a
    West Yorkshire
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2538096
    51066720001
    AHLUWALIA, Inderjit
    2 Orchard Close The Mount
    Winterbourne
    BS17 5BE Bristol
    Avon
    Amministratore
    2 Orchard Close The Mount
    Winterbourne
    BS17 5BE Bristol
    Avon
    British46393210001
    ARROWSMITH, Robert George
    8 Brendon Drive
    KT10 9EQ Esher
    Amministratore
    8 Brendon Drive
    KT10 9EQ Esher
    United KingdomBritish70780350004
    BALDWIN, Anthony John
    16 Lynch Road
    GL13 9TA Berkeley
    Gloucestershire
    Amministratore
    16 Lynch Road
    GL13 9TA Berkeley
    Gloucestershire
    British46963020001
    BROOKS, Alan Russell
    Hortonwood
    TF1 7GT Telford
    37
    Shropshire
    Amministratore
    Hortonwood
    TF1 7GT Telford
    37
    Shropshire
    United KingdomEnglish152133250002
    BROWN, Charles
    1 Hill Farm Cottage
    Hill Farm Lane
    AL6 9BN Ayot St Lawrence
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 Hill Farm Cottage
    Hill Farm Lane
    AL6 9BN Ayot St Lawrence
    Hertfordshire
    British99539020001
    CORNISH, Neil David
    Chesnut House
    Ashley Road
    GL52 6PH Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Chesnut House
    Ashley Road
    GL52 6PH Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish125871580001
    DJURIC, George
    Farm
    Watery Lane
    MK19 6DZ Beachampton
    Grange
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    Farm
    Watery Lane
    MK19 6DZ Beachampton
    Grange
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish180779760001
    FERGUSON, Alan
    Middle Street
    Ashcott
    TA7 9QG Bridgwater
    2
    Somerset
    Amministratore
    Middle Street
    Ashcott
    TA7 9QG Bridgwater
    2
    Somerset
    United KingdomBritish132201720001
    GRAHAM, Steven
    4548 Arcady Ave
    Highland Park
    Texas 75205
    Usa
    Amministratore
    4548 Arcady Ave
    Highland Park
    Texas 75205
    Usa
    UsaUnited States127222880001
    HOWARTH, Clive Duncan Ward
    The Old Barn
    Compton Dando
    BS18 4LA Bristol
    Avon
    Amministratore
    The Old Barn
    Compton Dando
    BS18 4LA Bristol
    Avon
    British33870940001
    JAMES, Derrell
    Groves Circle
    76226 Argyle
    3
    Texas
    United States
    Amministratore
    Groves Circle
    76226 Argyle
    3
    Texas
    United States
    UsaAmerican139135010001
    MCDERMOTT, Kevin
    Floor Ringway House
    Bell Road
    RG24 8FB Basingstoke
    2nd
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor Ringway House
    Bell Road
    RG24 8FB Basingstoke
    2nd
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish155228700001
    MILLING, Mark Baird
    9 Millford Street
    Southville
    BS3 1EE Bristol
    Amministratore
    9 Millford Street
    Southville
    BS3 1EE Bristol
    British99539270002
    MORGENSTERN, Ursula Franziska
    Triton Square
    NW1 3HG London
    4 Triton Square
    England
    Amministratore
    Triton Square
    NW1 3HG London
    4 Triton Square
    England
    EnglandGerman169985440001
    RATHBONE, John James
    Wedgewood Sarratt Lane
    Loudwater
    WD3 4AS Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    Wedgewood Sarratt Lane
    Loudwater
    WD3 4AS Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandBritish12232920002
    SHEPPARD, Paul Jeremy
    81 Johnson Road
    Emersons Green
    BS16 7JP Bristol
    Avon
    Amministratore
    81 Johnson Road
    Emersons Green
    BS16 7JP Bristol
    Avon
    EnglandBritish110186990001
    SIMMONDS, Mark Oakley
    2 Glendower House
    Clifton Down
    BS8 3BP Bristol
    Avon
    Amministratore
    2 Glendower House
    Clifton Down
    BS8 3BP Bristol
    Avon
    United KingdomBritish44853240002
    SMITH, Andrew Ian
    The Lodge
    31 Hook Hill
    CR2 0LB Sanderstead
    Surrey
    Amministratore
    The Lodge
    31 Hook Hill
    CR2 0LB Sanderstead
    Surrey
    EnglandEnglish94602120001
    TAYLOR, Kevin Lee, Mr.
    Triton Square
    NW1 3HG London
    4 Triton Square
    England
    Amministratore
    Triton Square
    NW1 3HG London
    4 Triton Square
    England
    EnglandBritish261210950001
    TOMALIN, Andrew Simon Edward
    The Old Fleece
    Stanley Downton
    GL10 3QS Stonehouse
    Gloucestershire
    Amministratore
    The Old Fleece
    Stanley Downton
    GL10 3QS Stonehouse
    Gloucestershire
    United KingdomBritish4685800002

    Chi sono le persone con controllo significativo di ANIX GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Atos It Outsourcing Services Limited
    Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3HG London
    4
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3HG London
    4
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione01980455
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ANIX GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 07 ago 2007
    Consegnato il 11 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 giu 2005
    Consegnato il 11 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or anix holdings limited, anix computers limited, anix business systems limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit 3 the alpha centre armstrong way great western business park yate t/no AV173886.
    Persone aventi diritto
    • Ibm United Kingdom Financial Services Limited
    Transazioni
    • 11 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 08 dic 1999
    Consegnato il 14 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present or future obligations and liabilities owing by any chargor (as defined) to the chargee under the facility documents (as defined) or any other document;
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ibm United Kingdom Financial Services Limited
    Transazioni
    • 14 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 19 feb 1997
    Consegnato il 25 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 04 set 1996
    Consegnato il 10 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/as 1 & 2 the alpha centre yate bristol avon t/no AV175230 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0