ANIX GROUP LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ANIX GROUP LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02367983 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ANIX GROUP LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova ANIX GROUP LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 4 Triton Square Triton Square NW1 3HG London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ANIX GROUP LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ANIX COMPUTERS LIMITED | 31 mag 1990 | 31 mag 1990 |
| ANIX LIMITED | 17 ott 1989 | 17 ott 1989 |
| DAPPLESTONE COMPUTERS LIMITED | 04 apr 1989 | 04 apr 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ANIX GROUP LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per ANIX GROUP LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 06 lug 2017
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 30 giu 2017
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 apr 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Adrian Paul Gregory come amministratore in data 01 dic 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ursula Franziska Morgenstern come amministratore in data 01 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 39 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Chad Sterling Harris come amministratore in data 01 lug 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di York Place Company Secretaries Limited come segretario in data 01 lug 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr James Terrence John Loughrey come segretario in data 01 lug 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di James Michael Peffer come segretario in data 01 lug 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kevin Lee Taylor come amministratore in data 01 lug 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Steven Graham come amministratore in data 01 lug 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ANIX GROUP LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOUGHREY, James Terrence John | Segretario | Triton Square NW1 3HG London 4 Triton Square England | 199012170001 | |||||||||||
| GREGORY, Adrian Paul | Amministratore | Triton Square NW1 3HG London 4 Triton Square England | England | British | 203421120001 | |||||||||
| HARRIS, Chad Sterling | Amministratore | N. Haskell Ave. 75204 Dallas 2828 Texas Usa | United States | American | 199018650001 | |||||||||
| PROCH, Michel Alain | Amministratore | c/o Atos Se Quai Voltaire 95877 Bezons River Ouest, 80 France | France | French | 167956020001 | |||||||||
| BRICKMAN, Lowell K | Segretario | 4024 Enclave Mesa Circle Austin Texas 78731 Usa | United States | 127222980001 | ||||||||||
| COOPER, Paul Antony | Segretario | 35 Colston Avenue BS1 4TT Bristol Avon | British | 41111910001 | ||||||||||
| DJURIC, George | Segretario | Farm Watery Lane MK19 6DZ Beachampton Grange Buckinghamshire England | British | 180779760001 | ||||||||||
| DUNKLEY, Michael Robert Paul | Segretario | 53 Waterford Close Thornbury BS35 2HU Bristol Avon | British | 19347000001 | ||||||||||
| GILBERT, Julie Helen | Segretario | 124 Ormonds Close Bradley Stoke BS32 0DY Bristol | British | 86072560001 | ||||||||||
| PEFFER, James Michael | Segretario | N Haskell Avenue 75204 Dallas 2828 Texas Usa | 167316460001 | |||||||||||
| SIMMONDS, Mark Oakley | Segretario | 2 Glendower House Clifton Down BS8 3BP Bristol Avon | British | 44853240002 | ||||||||||
| BEACH SECRETARIES LIMITED | Segretario | 100 Fetter Lane EC4A 1BN London | 76729800001 | |||||||||||
| YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Segretario | York Place LS1 2EZ Leeds White Rose House 28a West Yorkshire |
| 51066720001 | ||||||||||
| AHLUWALIA, Inderjit | Amministratore | 2 Orchard Close The Mount Winterbourne BS17 5BE Bristol Avon | British | 46393210001 | ||||||||||
| ARROWSMITH, Robert George | Amministratore | 8 Brendon Drive KT10 9EQ Esher | United Kingdom | British | 70780350004 | |||||||||
| BALDWIN, Anthony John | Amministratore | 16 Lynch Road GL13 9TA Berkeley Gloucestershire | British | 46963020001 | ||||||||||
| BROOKS, Alan Russell | Amministratore | Hortonwood TF1 7GT Telford 37 Shropshire | United Kingdom | English | 152133250002 | |||||||||
| BROWN, Charles | Amministratore | 1 Hill Farm Cottage Hill Farm Lane AL6 9BN Ayot St Lawrence Hertfordshire | British | 99539020001 | ||||||||||
| CORNISH, Neil David | Amministratore | Chesnut House Ashley Road GL52 6PH Cheltenham Gloucestershire | England | British | 125871580001 | |||||||||
| DJURIC, George | Amministratore | Farm Watery Lane MK19 6DZ Beachampton Grange Buckinghamshire England | England | British | 180779760001 | |||||||||
| FERGUSON, Alan | Amministratore | Middle Street Ashcott TA7 9QG Bridgwater 2 Somerset | United Kingdom | British | 132201720001 | |||||||||
| GRAHAM, Steven | Amministratore | 4548 Arcady Ave Highland Park Texas 75205 Usa | Usa | United States | 127222880001 | |||||||||
| HOWARTH, Clive Duncan Ward | Amministratore | The Old Barn Compton Dando BS18 4LA Bristol Avon | British | 33870940001 | ||||||||||
| JAMES, Derrell | Amministratore | Groves Circle 76226 Argyle 3 Texas United States | Usa | American | 139135010001 | |||||||||
| MCDERMOTT, Kevin | Amministratore | Floor Ringway House Bell Road RG24 8FB Basingstoke 2nd Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 155228700001 | |||||||||
| MILLING, Mark Baird | Amministratore | 9 Millford Street Southville BS3 1EE Bristol | British | 99539270002 | ||||||||||
| MORGENSTERN, Ursula Franziska | Amministratore | Triton Square NW1 3HG London 4 Triton Square England | England | German | 169985440001 | |||||||||
| RATHBONE, John James | Amministratore | Wedgewood Sarratt Lane Loudwater WD3 4AS Rickmansworth Hertfordshire | England | British | 12232920002 | |||||||||
| SHEPPARD, Paul Jeremy | Amministratore | 81 Johnson Road Emersons Green BS16 7JP Bristol Avon | England | British | 110186990001 | |||||||||
| SIMMONDS, Mark Oakley | Amministratore | 2 Glendower House Clifton Down BS8 3BP Bristol Avon | United Kingdom | British | 44853240002 | |||||||||
| SMITH, Andrew Ian | Amministratore | The Lodge 31 Hook Hill CR2 0LB Sanderstead Surrey | England | English | 94602120001 | |||||||||
| TAYLOR, Kevin Lee, Mr. | Amministratore | Triton Square NW1 3HG London 4 Triton Square England | England | British | 261210950001 | |||||||||
| TOMALIN, Andrew Simon Edward | Amministratore | The Old Fleece Stanley Downton GL10 3QS Stonehouse Gloucestershire | United Kingdom | British | 4685800002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ANIX GROUP LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atos It Outsourcing Services Limited | 06 apr 2016 | Triton Square Regent's Place NW1 3HG London 4 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ANIX GROUP LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 07 ago 2007 Consegnato il 11 ago 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 08 giu 2005 Consegnato il 11 giu 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company or anix holdings limited, anix computers limited, anix business systems limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari L/H property k/a unit 3 the alpha centre armstrong way great western business park yate t/no AV173886. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 08 dic 1999 Consegnato il 14 dic 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present or future obligations and liabilities owing by any chargor (as defined) to the chargee under the facility documents (as defined) or any other document; | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 19 feb 1997 Consegnato il 25 feb 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 04 set 1996 Consegnato il 10 set 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H property k/as 1 & 2 the alpha centre yate bristol avon t/no AV175230 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0