RELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | RELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Liquidazione |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02368530 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di RELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova RELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 124 Rookery Road Handsworth B21 9NN Birmingham England And Wales United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di RELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| RELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) PLC | 15 mar 2012 | 15 mar 2012 |
| RELIGARE CAPITAL MARKETS PLC | 10 mar 2010 | 10 mar 2010 |
| RELIGARE HICHENS, HARRISON PLC | 01 ago 2008 | 01 ago 2008 |
| HICHENS, HARRISON & CO. PLC | 05 apr 1989 | 05 apr 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di RELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 mar 2020 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 mar 2021 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2019 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per RELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 06 feb 2021 |
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 20 mar 2021 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 06 feb 2020 |
| Scaduto | Sì |
Quali sono le ultime deposizioni per RELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Ordine del tribunale di liquidazione | 3 pagine | COCOMP | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 feb 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2019 | 35 pagine | AA | ||
Nomina di Mr. Amarjeet Singh Arora come amministratore in data 15 ott 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 feb 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Rajesh Sharma come amministratore in data 29 mar 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa | 1 pagine | DISS16(SOAS) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2018 | 40 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Mark Alastair Runacres come amministratore in data 17 set 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione di Shivinder Mohan Singh come persona con controllo significativo il 14 dic 2018 | 1 pagine | PSC07 | ||
Cessazione di Malvinder Mohan Singh come persona con controllo significativo il 14 dic 2018 | 1 pagine | PSC07 | ||
Notifica di Rajesh Sharma come persona con controllo significativo il 14 dic 2018 | 2 pagine | PSC01 | ||
Cessazione della carica di Tmf Corporate Administration Services Limited come segretario in data 16 nov 2018 | 1 pagine | TM02 | ||
Cessazione della carica di Brian William Tempest come amministratore in data 22 apr 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 feb 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Anil Saxena come amministratore in data 14 nov 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2017 | 37 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Rajesh Sharma come amministratore in data 12 ott 2017 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Sunil Kumar Garg come amministratore in data 18 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 feb 2017 con aggiornamenti | 7 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mark Alastair Runacres il 01 ott 2016 | 2 pagine | CH01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da The Studio 1 Doughty Street London WC1N 2PH a 124 Rookery Road Handsworth Birmingham England and Wales B21 9NN in data 11 gen 2017 | 1 pagine | AD01 | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2016 | 83 pagine | AA | ||
Chi sono gli amministratori di RELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARORA, Amarjeet Singh, Mr. | Amministratore | I-42, Ff, Jangpura Extension, Delhi 110014 Jangpura I-42, Ff, Jangpura Extension, Delhi New Delhi India | India | Indian | 263432890001 | |||||||||
| AVES, Peter Nicholas | Segretario | 26 Sidney Square E1 2EY London | British | 71180520001 | ||||||||||
| BAILEY, Dennis Bryan | Segretario | Tile House Shepherds Green RG9 4QW Rotherfield Greys Henley On Thames Oxfordshire | British | 4881010002 | ||||||||||
| GARMON JONES, Richard | Segretario | Plas Newydd Devonshire Avenue HP6 5JF Amersham Buckinghamshire | British | 85123650003 | ||||||||||
| NOROSE COMPANY SECRETARIAL SERVICE LTD | Segretario | 3 More London Riverside SE1 2AQ London | 123465420001 | |||||||||||
| TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED | Segretario | 6 St Andrew Street EC4A 3AE London 5th Floor England |
| 140723560001 | ||||||||||
| TMF NOMINEES LIMITED | Segretario | Capability Green LU1 3AE Luton 400 Bedfordshire | 136449070001 | |||||||||||
| BAILEY, Dennis Bryan | Amministratore | Tile House Shepherds Green RG9 4QW Rotherfield Greys Henley On Thames Oxfordshire | United Kingdom | British | 4881010002 | |||||||||
| BALANI, Jaickismin Wadhumal | Amministratore | Compas De La Victoria Malaga 29012 Spain | Spanish | 25676590001 | ||||||||||
| BHANSALI, Pankaj, Mr. | Amministratore | B Dheeraj Gaurav Heights Ii Off Link Road, Oshiwara, Andheri (W) Mumbai 400053 India | India | Indian | 135937020004 | |||||||||
| CAMPBELL, Jeremy Philip | Amministratore | The Brough Upper Hartfield TN7 4DL Hartfield East Sussex | British | 24078880001 | ||||||||||
| COIA, Gary James | Amministratore | Cannon Street EC4N 6EU London 100 | United Kingdom | British | 174444760001 | |||||||||
| DELMAR-MORGAN, Jeremy | Amministratore | 5 Western Terrace Hammersmith W6 9TX London | United Kingdom | British | 23953030001 | |||||||||
| DHILLON, Gurpreet Singh, Mr. | Amministratore | 20 Dunraven Street W1K 7FF London Flat 1 | United Kingdom | Spanish | 134369040001 | |||||||||
| DURRENT, Simon Tobias | Amministratore | Turneville Road W14 9PS London 32 | British | 138367220001 | ||||||||||
| GARG, Sunil Kumar | Amministratore | District Centre Saket 110017 New Dehli D3 P3b India | India | Indian | 206396590001 | |||||||||
| GONZENBACH, Gerald | Amministratore | Flat 8 Cranley Place SW7 3AB London | Swiss | 79153450002 | ||||||||||
| HOWARD SMITH, John Christopher Anthony | Amministratore | Hill End Woodcote Side KT18 7HB Epsom Surrey | British | 81994350001 | ||||||||||
| HYTNER, Robert William | Amministratore | 6 Bressingham Gardens CM3 5RF Southwoodham Ferrers Essex | British | 76950590001 | ||||||||||
| KUNATHARAJU, Venkata Raghuram Raju, Mr. | Amministratore | Saket New Delhi D3 P3b District Centre 110017 India | India | Indian | 168289440001 | |||||||||
| MCGUIRE, Roland Clive | Amministratore | Ironwood Heath Drive Walton On The Hill KT20 7QJ Tadworth Surrey | England | English | 24078890001 | |||||||||
| MEHROTRA, Ravi Umesh | Amministratore | Estoril Court 55, Garden Road, Mid Levels Hong Kong 40a Block 1 Hong Kong | India | Indian | 162836300001 | |||||||||
| NATH, Shachindra | Amministratore | Villas At Palm Springs Sector 54 Urban Estate 122001 Gurgagon Tpv-Gv-65 Haryana India | India | Indian | 129564460003 | |||||||||
| NEWSON, Martin John | Amministratore | Palace Gardens Terrace W8 4RP London 22 | United Kingdom | British | 146049450001 | |||||||||
| PUNTER, Jonathan Dominic | Amministratore | 7 Orchard Drive Blackheath SE3 0QP London | United Kingdom | British | 26297750001 | |||||||||
| ROWBOTHAM, Brian | Amministratore | 7 Dundee Court 73 Wapping High Street E1W 2YG London | England | British | 88067200001 | |||||||||
| RUNACRES, Mark Alastair | Amministratore | Safdarjung Enclave New Delhi 110029 Delhi A1/166, Second Floor India | India | British | 140980120004 | |||||||||
| SAMUELS, James Anthony Angus | Amministratore | Flat 6 34 Stanhope Gardens SW7 5QY London | England | British | 66307920004 | |||||||||
| SAXENA, Anil | Amministratore | Sector 104 Gautam Buddha Nagar 201304 Noida Flat No. 4222, Tower 4, Ats One Hamlet Uttar Pradesh India | India | Indian | 129564380005 | |||||||||
| SHARMA, Rajesh | Amministratore | Rookery Road Handsworth B21 9NN Birmingham 124 England And Wales United Kingdom | India | Indian | 239345240001 | |||||||||
| TEMPEST, Brian William, Dr | Amministratore | Grayswood Road GU27 2DJ Haslemere South Park Farm Surrey England | United Kingdom | British | 124004410003 | |||||||||
| THOMAS, Colin Richard | Amministratore | Moorcroft 56 Lammas Lane KT10 8PD Esher Surrey | England | British | 40946090002 | |||||||||
| WILSON, Adam Richard | Amministratore | 78 Park Street Mayfair W1K 2JZ London | United Arab Emirates | British | 114909720002 | |||||||||
| WONG QUEE QUEE, Jeffrey | Amministratore | 43rd Floor Uob Plaza 1 048624 Singapore 80 Raffles Place Singapore | Singapore | Singapore Citizen | 170574120001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di RELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
|---|---|---|---|
| Mr. Rajesh Sharma | 14 dic 2018 | Rookery Road Handsworth B21 9NN Birmingham 124 England And Wales United Kingdom | No |
Nazionalità: Indian Paese di residenza: India | |||
Natura del controllo
| |||
| Mr. Malvinder Mohan Singh | 06 apr 2016 | Janpath 110001 New Delhi 54 India | Sì |
Nazionalità: Indian Paese di residenza: India | |||
Natura del controllo
| |||
| Mr. Shivinder Mohan Singh | 06 apr 2016 | Janpath 110001 New Delhi 54 India | Sì |
Nazionalità: Indian Paese di residenza: India | |||
Natura del controllo
| |||
RELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Headlease security agreement | Creato il 17 lug 2009 Consegnato il 24 lug 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the borrower to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari L/H property at 98-106 (even) cannon street and 9 laurence pountney hill, london, all buildings, fixtures, fixed plant and machinery, see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deposit, charge and settlement agreement | Creato il 16 lug 2009 Consegnato il 24 lug 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the borrower to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All of its right, title and interest in and to the deposit account and the deposit see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 15 dic 2004 Consegnato il 31 dic 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari £10,465. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A security agreement | Creato il 16 giu 2003 Consegnato il 19 giu 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All personal property and fixtures, the security agreement. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Terms of business agreement | Creato il 10 ago 1999 Consegnato il 18 ago 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All obligations of the company or any associate under the agreement and under any transaction or other obligation of the company to the chargee or any associate of the chargee | |
Brevi particolari By way of first, fixed charge and pledge over all deposits and margin and all securities, documents of or entering title property, cash or other assets of any nature held by or subject to the control of ics (or any nominee or custodian of ics) for the account of the company and a general lien and right of set-off. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental deed | Creato il 10 mar 1999 Consegnato il 11 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company or any crest member to the chargee | |
Brevi particolari By way of first fixed charge all sums and payments receivable all right title and interest to and in all monies by way of first floating charge all eligible stock all and any property all and any sums. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security deed | Creato il 14 feb 1997 Consegnato il 17 feb 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All debts obligations or liabilities whatsoever due or to become due from the company or by the crest member (as defined) to the chargee including all debts obligations and liabilities which arise out of or in connection with the provision of crest settlement bank facilities | |
Brevi particolari All sums and payments receivable by or for the company referable to the crest member in crest or any transfer by the company or the crest member of any of it's right title and interest in all stock represented by credit balance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 15 apr 1993 Consegnato il 20 apr 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due under the terms of the charge | |
Brevi particolari All shares stock and other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
RELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
| Liquidazione coatta |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0