VIKINGS REALISATIONS 7 LIMITED

VIKINGS REALISATIONS 7 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVIKINGS REALISATIONS 7 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02368678
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VIKINGS REALISATIONS 7 LIMITED?

    • (7222) /

    Dove si trova VIKINGS REALISATIONS 7 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    10 Furnival Street
    EC4A 1YH London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VIKINGS REALISATIONS 7 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NORWOOD ADAM SYSTEMS LIMITED05 apr 198905 apr 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di VIKINGS REALISATIONS 7 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per VIKINGS REALISATIONS 7 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 02 mar 2011

    50 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 01 apr 2011

    51 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 02 mar 2011

    51 pagine2.24B

    Indirizzo della sede legale modificato da 66 Wigmore Street London W1U 2SB in data 03 mar 2011

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    6 pagine2.16B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    179 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da Innovation House Millbrook Business Park Mill Lane Rainford WA11 8LZ in data 23 set 2010

    2 pagineAD01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed norwood adam systems LIMITED\certificate issued on 21/09/10
    3 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 10 set 2010

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Cessazione della carica di David Hargaden come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Essex Trust Limited come segretario

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Daniel Holohan come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2009 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Guarantee 21/08/2008
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Guarantee 16/09/2008
    RES13

    legacy

    6 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    12 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di VIKINGS REALISATIONS 7 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ESSEX TRUST LIMITED
    Floor
    Beaux Lane House Mercer Street Lower
    Dublin 2
    5th
    Ireland
    Segretario
    Floor
    Beaux Lane House Mercer Street Lower
    Dublin 2
    5th
    Ireland
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione251687
    151028540001
    BRADY, Tara Christopher
    14 Ellesmere Close
    E11 1PT London
    Amministratore
    14 Ellesmere Close
    E11 1PT London
    United KingdomBritishCompany Director145701300001
    HEALY, Maurice Leonard
    Knocksinna
    Foxrock
    Dublin 18
    "Glencroe"
    Ireland
    Amministratore
    Knocksinna
    Foxrock
    Dublin 18
    "Glencroe"
    Ireland
    IrelandIrishCompany Director59920210002
    BERRY, Keith Norwood Frederick
    7 London Road
    Halstead
    TN14 7DS Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    7 London Road
    Halstead
    TN14 7DS Sevenoaks
    Kent
    BritishCompany Secretary16098340001
    HOLOHAN, Daniel Joseph
    17 Ardlea,
    Trim Road
    IRISH Dunshaughlin
    Co. Meath
    Ireland
    Segretario
    17 Ardlea,
    Trim Road
    IRISH Dunshaughlin
    Co. Meath
    Ireland
    IrishAccountant114162330001
    LEE, Christopher James
    Garden Cottage
    Ledgers Lane
    CR6 9QB Chelsham
    Surrey
    Segretario
    Garden Cottage
    Ledgers Lane
    CR6 9QB Chelsham
    Surrey
    BritishFinance Director120977620001
    THAIN, Christopher Anthony
    47a London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    47a London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    British68372230001
    BEACH SECRETARIES LIMITED
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    Segretario
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    76729800001
    BERRY, Keith Norwood Frederick
    7 London Road
    Halstead
    TN14 7DS Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    7 London Road
    Halstead
    TN14 7DS Sevenoaks
    Kent
    BritishDirector16098340001
    COAKLEY, Gerard
    161 Stillorgan Heath
    IRISH Stillorgan
    Co Dublin
    Ireland
    Amministratore
    161 Stillorgan Heath
    IRISH Stillorgan
    Co Dublin
    Ireland
    IrishFinance Director112426940001
    HARGADEN, David
    2 St James Terrace
    Clonskeagh Road
    Dublin 6
    Ireland
    Amministratore
    2 St James Terrace
    Clonskeagh Road
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandIrishAccountant140574350001
    HEALY, Maurice Leonard
    Glencroe
    Knocksinna
    IRISH Foxrock
    Dublin 18
    Ireland
    Amministratore
    Glencroe
    Knocksinna
    IRISH Foxrock
    Dublin 18
    Ireland
    IrelandIrishChief Executive Officer59920210002
    PHILLIPS, David
    12 Ainslie Wood Crescent
    Chingford
    E4 9DB London
    Amministratore
    12 Ainslie Wood Crescent
    Chingford
    E4 9DB London
    BritishDirector20228100001
    SMITH, Andrew Ian
    The Lodge
    31 Hook Hill
    CR2 0LB Sanderstead
    Surrey
    Amministratore
    The Lodge
    31 Hook Hill
    CR2 0LB Sanderstead
    Surrey
    EnglandEnglishCompany Director94602120001
    THAIN, Christopher Anthony
    47a London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    47a London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    BritishChartered Accountant/Director68372230001
    THOMAS, Grahame Derek
    68 Kingsley Avenue
    Cheshunt
    EN8 9PR Waltham Cross
    Hertfordshire
    Amministratore
    68 Kingsley Avenue
    Cheshunt
    EN8 9PR Waltham Cross
    Hertfordshire
    BritishDirector20228120001
    WEAVER, Anthony
    Freshfields
    Maynards Green
    TN21 0DE Heathfield
    East Sussex
    Amministratore
    Freshfields
    Maynards Green
    TN21 0DE Heathfield
    East Sussex
    United KingdomBritishDirector1435050002
    WILLIAMS, Nicholas
    Heath Ride
    Finchampstead
    RG40 3QJ Wokingham
    Sandy Way
    Berkshire
    Amministratore
    Heath Ride
    Finchampstead
    RG40 3QJ Wokingham
    Sandy Way
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director160931630001

    VIKINGS REALISATIONS 7 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite debenture
    Creato il 17 set 2008
    Consegnato il 29 set 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 29 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite debenture
    Creato il 29 ago 2008
    Consegnato il 11 set 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 11 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 08 nov 2007
    Consegnato il 28 nov 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the companies under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC in Its Capacity as Security Trustee for the Secured Parties(The Security Trustee)
    Transazioni
    • 28 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 28 apr 2005
    Consegnato il 30 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 30 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 ago 1990
    Consegnato il 12 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 11 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    VIKINGS REALISATIONS 7 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    03 set 2010Inizio dell'amministrazione
    01 apr 2011Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Philip Lewis Armstrong
    66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Praticante
    66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Geoffrey Paul Rowley
    Po Box 2653 66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Praticante
    Po Box 2653 66 Wigmore Street
    W1A 3RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0