BLITZ VISION LIMITED

BLITZ VISION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBLITZ VISION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02372013
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BLITZ VISION LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova BLITZ VISION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BLITZ VISION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ROBAWN LIMITED13 apr 198913 apr 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di BLITZ VISION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per BLITZ VISION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagineLIQ13

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Rsm Uk Central Square, Fifth Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Central Square 5th Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL England a Rsm Uk Central Square, Fifth Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Ges Silverstone Drive Gallagher Business Park Coventry CV6 6PA England a Deloitte Llp 1 City Square Leeds LS1 2AL in data 23 gen 2020

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 13 gen 2020

    LRESSP

    Cessazione della carica di Jason Popp come amministratore in data 20 set 2019

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    5 pagineAA

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Central Square 5th Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL

    1 pagineAD02

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Michael Stewart come segretario in data 09 gen 2019

    2 pagineAP03

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Paul Mckenna Silverstone Drive Gallagher Business Park Coventry CV6 6PA a Ges Silverstone Drive Gallagher Business Park Coventry CV6 6PA in data 09 gen 2019

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Jason Popp come amministratore in data 09 gen 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nicholas John Marshall come amministratore in data 09 gen 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Mckenna come segretario in data 09 gen 2019

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 giu 2016

    Stato del capitale al 09 giu 2016

    • Capitale: GBP 400,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 giu 2015

    Stato del capitale al 11 giu 2015

    • Capitale: GBP 400,000
    SH01

    Chi sono gli amministratori di BLITZ VISION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    STEWART, Michael
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Deloitte Llp
    Segretario
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Deloitte Llp
    254077040001
    INGERSOLL, Ellen Marie
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Deloitte Llp
    Amministratore
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Deloitte Llp
    United StatesAmerican118864140001
    MOSTER, Steven
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Deloitte Llp
    Amministratore
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Deloitte Llp
    United StatesAmerican193607710001
    BREEN, Michael John
    47 Wieland Road
    HA6 3QX Northwood
    Middlesex
    Segretario
    47 Wieland Road
    HA6 3QX Northwood
    Middlesex
    English8442840002
    COOK, Russell John
    26 Egmont Road
    KT6 7AT Surbiton
    Surrey
    Segretario
    26 Egmont Road
    KT6 7AT Surbiton
    Surrey
    British64676640001
    DAVIES, Digby John
    1a Cambridge Road
    TW1 2HN Twickenham
    Middlesex
    Segretario
    1a Cambridge Road
    TW1 2HN Twickenham
    Middlesex
    British38937270002
    DAY, Christopher Alexander Coryton
    48 Whitley Court Road
    Quinton
    B32 1EY Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    48 Whitley Court Road
    Quinton
    B32 1EY Birmingham
    West Midlands
    British92047820001
    GORDON, Neil Arthur
    Stable Cottage, Burrows Lea
    Hook Lane, Shere
    GU5 9QQ Guildford
    Surrey
    Segretario
    Stable Cottage, Burrows Lea
    Hook Lane, Shere
    GU5 9QQ Guildford
    Surrey
    British73989530001
    MAKANJI, Ashok
    Silverstone Drive
    Gallagher Business Park
    CV6 6PA Coventry
    C/O Paul Mckenna
    England
    Segretario
    Silverstone Drive
    Gallagher Business Park
    CV6 6PA Coventry
    C/O Paul Mckenna
    England
    191997100001
    MAKANJI, Ashok
    Unit 100
    Centennial Avenue
    WD6 3SA Elstree
    Hertfordshire
    Segretario
    Unit 100
    Centennial Avenue
    WD6 3SA Elstree
    Hertfordshire
    British120367360001
    MCKENNA, Paul
    Silverstone Drive
    Gallagher Business Park
    CV6 6PA Coventry
    C/O Paul Mckenna
    England
    Segretario
    Silverstone Drive
    Gallagher Business Park
    CV6 6PA Coventry
    C/O Paul Mckenna
    England
    193460210001
    PARDEN, Susannah Mary Louise
    87 Sutton Court
    Chiswick
    W4 3JF London
    Segretario
    87 Sutton Court
    Chiswick
    W4 3JF London
    British75930520001
    PATEL, Daxshaben
    2 Millers Court
    Vicars Bridge Close
    HA0 1XG Alperton
    Middlesex
    Segretario
    2 Millers Court
    Vicars Bridge Close
    HA0 1XG Alperton
    Middlesex
    British96045520001
    WAKELEY, David Peacefull
    166 Rosemary Hill Road
    B74 4HN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    166 Rosemary Hill Road
    B74 4HN Sutton Coldfield
    West Midlands
    British86839080001
    BEDDOW, Charles Edward Kenneth
    Manor Road
    MK45 4NU Barton Le Clay
    163
    Bedfordshire
    Amministratore
    Manor Road
    MK45 4NU Barton Le Clay
    163
    Bedfordshire
    United KingdomBritish132281430001
    BEDDOW, Charles Edward Kenneth
    Manor Road
    MK45 4NU Barton Le Clay
    163
    Bedfordshire
    Amministratore
    Manor Road
    MK45 4NU Barton Le Clay
    163
    Bedfordshire
    United KingdomBritish132281430001
    BREEN, Michael John
    47 Wieland Road
    HA6 3QX Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    47 Wieland Road
    HA6 3QX Northwood
    Middlesex
    EnglandEnglish8442840002
    BREEN, Michael John
    47 Wieland Road
    HA6 3QX Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    47 Wieland Road
    HA6 3QX Northwood
    Middlesex
    EnglandEnglish8442840002
    BURTON, Peter
    The Old School
    Sandridgebury
    AL3 6JB St Albans
    Amministratore
    The Old School
    Sandridgebury
    AL3 6JB St Albans
    United KingdomBritish1753870005
    DAVIES, Digby John
    1a Cambridge Road
    TW1 2HN Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    1a Cambridge Road
    TW1 2HN Twickenham
    Middlesex
    British38937270002
    DAY, Barry David
    The Old Rectory Hatton Green
    Hatton
    CV35 7LA Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    The Old Rectory Hatton Green
    Hatton
    CV35 7LA Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritish57937960001
    DYKSTRA, Paul Brian
    Silverstone Drive
    Gallagher Business Park
    CV6 6PA Coventry
    C/O Paul Mckenna
    England
    Amministratore
    Silverstone Drive
    Gallagher Business Park
    CV6 6PA Coventry
    C/O Paul Mckenna
    England
    UsaAmerican118864330001
    ELLIS, Robert Keith
    55 Bushy Park Road
    TW11 9DQ Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    55 Bushy Park Road
    TW11 9DQ Teddington
    Middlesex
    EnglandBritish45171010001
    ELLIS, Robert Keith
    55 Bushy Park Road
    TW11 9DQ Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    55 Bushy Park Road
    TW11 9DQ Teddington
    Middlesex
    EnglandBritish45171010001
    FRASER, Donald
    Beechwood 4 Dower Close
    Knotty Green
    HP9 1XL Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Beechwood 4 Dower Close
    Knotty Green
    HP9 1XL Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British60234160001
    GORDON, Neil Arthur
    Stable Cottage, Burrows Lea
    Hook Lane, Shere
    GU5 9QQ Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Stable Cottage, Burrows Lea
    Hook Lane, Shere
    GU5 9QQ Guildford
    Surrey
    EnglandBritish73989530001
    HUTTON, Paul William Peter
    68 Allandale Crescent
    EN6 2JZ Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    68 Allandale Crescent
    EN6 2JZ Potters Bar
    Hertfordshire
    British37588540001
    JURELLER, John Michael
    150 Brite Avenue Scarsdale
    Westchester New York
    10583 Usa
    Amministratore
    150 Brite Avenue Scarsdale
    Westchester New York
    10583 Usa
    UsaAmerican150101410001
    MAKANJI, Ashok
    Unit 100
    Centennial Avenue
    WD6 3SA Elstree
    Hertfordshire
    Amministratore
    Unit 100
    Centennial Avenue
    WD6 3SA Elstree
    Hertfordshire
    United KingdomBritish120367360001
    MARSHALL, Nicholas John
    Silverstone Drive
    Gallagher Business Park
    CV6 6PA Coventry
    C/O Paul Mckenna
    England
    Amministratore
    Silverstone Drive
    Gallagher Business Park
    CV6 6PA Coventry
    C/O Paul Mckenna
    England
    EnglandBritish20708530004
    MARSHALL, Nicholas John
    Spring House
    Fieldgate Lawn, Fieldgate Lane
    CV8 1BT Kenilworth
    Warwickshire
    Amministratore
    Spring House
    Fieldgate Lawn, Fieldgate Lane
    CV8 1BT Kenilworth
    Warwickshire
    EnglandBritish20708530004
    POPP, Jason
    Silverstone Drive
    Gallagher Business Park
    CV6 6PA Coventry
    Ges
    England
    Amministratore
    Silverstone Drive
    Gallagher Business Park
    CV6 6PA Coventry
    Ges
    England
    United StatesAmerican254059920001
    SAMJI, Munir Akberali
    Unit 100
    Centennial Avenue
    WD6 3SA Elstree
    Hertfordshire
    Amministratore
    Unit 100
    Centennial Avenue
    WD6 3SA Elstree
    Hertfordshire
    United KingdomUnited Kingdom119498620001
    SUTTON, Peter Howard
    109 Pembroke Road
    Muswell Hill
    N10 2JE London
    Amministratore
    109 Pembroke Road
    Muswell Hill
    N10 2JE London
    British61149380001
    VENT, Richard H
    93 Tahoe Boulevard Suite 802-318
    Incline Village
    89451 Nevada
    Usa
    Amministratore
    93 Tahoe Boulevard Suite 802-318
    Incline Village
    89451 Nevada
    Usa
    American55991280001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BLITZ VISION LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Viad Corp
    1850 N. Central Avenue
    Suite 1900
    Phoenix
    Viad Corp
    Arizona 85004-4565
    United States
    06 apr 2017
    1850 N. Central Avenue
    Suite 1900
    Phoenix
    Viad Corp
    Arizona 85004-4565
    United States
    No
    Forma giuridicaLimited
    Autorità legaleThe Securities Act Of 1933 And The Securities And Exchange Act Of 1934, Sarbanes-Oxley Act Of 2002
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    BLITZ VISION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and debenture between (1) the chargor (the company) and (2) national westminster bank PLC (the security trustee) as agent and trustee for the secured parties (as defined)
    Creato il 08 mag 2000
    Consegnato il 16 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the chargor to any of the secured parties under or pursuant to all or any of the financing documents (as defined) including the debenture
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 30 lug 1998
    Consegnato il 11 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to all or any of the financing documents including the guarantee and debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 mag 1993
    Consegnato il 03 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Legal charge over all moneys from time to time held on any current deposit and/or other account at the bank.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Co.
    Transazioni
    • 03 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 19 giu 1991
    Consegnato il 10 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company
    Transazioni
    • 10 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 08 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 19 giu 1991
    Consegnato il 21 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from simplecover limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charges upon a) the stock in trade, work-in-progress, pre-payments investments quoted on a recognised stock exchange and cash of the company both present and future b) all other the undertaking and all other property and assets of the company c) any property and assets of company both present and future not charged by way of fixed charge.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 21 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 24 mag 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 12 set 1990
    Consegnato il 15 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Charge over funds held on deposit on a designated account.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company
    Transazioni
    • 15 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 14 dic 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 feb 1990
    Consegnato il 10 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Legal charge over credit balances.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company
    Transazioni
    • 10 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 14 dic 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 09 ago 1989
    Consegnato il 12 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company
    Transazioni
    • 12 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 14 dic 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BLITZ VISION LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    13 gen 2020Inizio della liquidazione
    23 dic 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Adrian Peter Berry
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Praticante
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Stephen Roland Browne
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Praticante
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0