BLITZ VISION LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BLITZ VISION LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02372013 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BLITZ VISION LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova BLITZ VISION LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Deloitte Llp 1 City Square LS1 2AL Leeds |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BLITZ VISION LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ROBAWN LIMITED | 13 apr 1989 | 13 apr 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BLITZ VISION LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per BLITZ VISION LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 10 pagine | LIQ13 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Rsm Uk Central Square, Fifth Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL | 2 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Central Square 5th Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL England a Rsm Uk Central Square, Fifth Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Ges Silverstone Drive Gallagher Business Park Coventry CV6 6PA England a Deloitte Llp 1 City Square Leeds LS1 2AL in data 23 gen 2020 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 6 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Jason Popp come amministratore in data 20 set 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 5 pagine | AA | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Central Square 5th Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 giu 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Michael Stewart come segretario in data 09 gen 2019 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Paul Mckenna Silverstone Drive Gallagher Business Park Coventry CV6 6PA a Ges Silverstone Drive Gallagher Business Park Coventry CV6 6PA in data 09 gen 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mr Jason Popp come amministratore in data 09 gen 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nicholas John Marshall come amministratore in data 09 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Mckenna come segretario in data 09 gen 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 giu 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 giu 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di BLITZ VISION LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEWART, Michael | Segretario | 1 City Square LS1 2AL Leeds Deloitte Llp | 254077040001 | |||||||
| INGERSOLL, Ellen Marie | Amministratore | 1 City Square LS1 2AL Leeds Deloitte Llp | United States | American | 118864140001 | |||||
| MOSTER, Steven | Amministratore | 1 City Square LS1 2AL Leeds Deloitte Llp | United States | American | 193607710001 | |||||
| BREEN, Michael John | Segretario | 47 Wieland Road HA6 3QX Northwood Middlesex | English | 8442840002 | ||||||
| COOK, Russell John | Segretario | 26 Egmont Road KT6 7AT Surbiton Surrey | British | 64676640001 | ||||||
| DAVIES, Digby John | Segretario | 1a Cambridge Road TW1 2HN Twickenham Middlesex | British | 38937270002 | ||||||
| DAY, Christopher Alexander Coryton | Segretario | 48 Whitley Court Road Quinton B32 1EY Birmingham West Midlands | British | 92047820001 | ||||||
| GORDON, Neil Arthur | Segretario | Stable Cottage, Burrows Lea Hook Lane, Shere GU5 9QQ Guildford Surrey | British | 73989530001 | ||||||
| MAKANJI, Ashok | Segretario | Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry C/O Paul Mckenna England | 191997100001 | |||||||
| MAKANJI, Ashok | Segretario | Unit 100 Centennial Avenue WD6 3SA Elstree Hertfordshire | British | 120367360001 | ||||||
| MCKENNA, Paul | Segretario | Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry C/O Paul Mckenna England | 193460210001 | |||||||
| PARDEN, Susannah Mary Louise | Segretario | 87 Sutton Court Chiswick W4 3JF London | British | 75930520001 | ||||||
| PATEL, Daxshaben | Segretario | 2 Millers Court Vicars Bridge Close HA0 1XG Alperton Middlesex | British | 96045520001 | ||||||
| WAKELEY, David Peacefull | Segretario | 166 Rosemary Hill Road B74 4HN Sutton Coldfield West Midlands | British | 86839080001 | ||||||
| BEDDOW, Charles Edward Kenneth | Amministratore | Manor Road MK45 4NU Barton Le Clay 163 Bedfordshire | United Kingdom | British | 132281430001 | |||||
| BEDDOW, Charles Edward Kenneth | Amministratore | Manor Road MK45 4NU Barton Le Clay 163 Bedfordshire | United Kingdom | British | 132281430001 | |||||
| BREEN, Michael John | Amministratore | 47 Wieland Road HA6 3QX Northwood Middlesex | England | English | 8442840002 | |||||
| BREEN, Michael John | Amministratore | 47 Wieland Road HA6 3QX Northwood Middlesex | England | English | 8442840002 | |||||
| BURTON, Peter | Amministratore | The Old School Sandridgebury AL3 6JB St Albans | United Kingdom | British | 1753870005 | |||||
| DAVIES, Digby John | Amministratore | 1a Cambridge Road TW1 2HN Twickenham Middlesex | British | 38937270002 | ||||||
| DAY, Barry David | Amministratore | The Old Rectory Hatton Green Hatton CV35 7LA Warwick Warwickshire | England | British | 57937960001 | |||||
| DYKSTRA, Paul Brian | Amministratore | Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry C/O Paul Mckenna England | Usa | American | 118864330001 | |||||
| ELLIS, Robert Keith | Amministratore | 55 Bushy Park Road TW11 9DQ Teddington Middlesex | England | British | 45171010001 | |||||
| ELLIS, Robert Keith | Amministratore | 55 Bushy Park Road TW11 9DQ Teddington Middlesex | England | British | 45171010001 | |||||
| FRASER, Donald | Amministratore | Beechwood 4 Dower Close Knotty Green HP9 1XL Beaconsfield Buckinghamshire | British | 60234160001 | ||||||
| GORDON, Neil Arthur | Amministratore | Stable Cottage, Burrows Lea Hook Lane, Shere GU5 9QQ Guildford Surrey | England | British | 73989530001 | |||||
| HUTTON, Paul William Peter | Amministratore | 68 Allandale Crescent EN6 2JZ Potters Bar Hertfordshire | British | 37588540001 | ||||||
| JURELLER, John Michael | Amministratore | 150 Brite Avenue Scarsdale Westchester New York 10583 Usa | Usa | American | 150101410001 | |||||
| MAKANJI, Ashok | Amministratore | Unit 100 Centennial Avenue WD6 3SA Elstree Hertfordshire | United Kingdom | British | 120367360001 | |||||
| MARSHALL, Nicholas John | Amministratore | Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry C/O Paul Mckenna England | England | British | 20708530004 | |||||
| MARSHALL, Nicholas John | Amministratore | Spring House Fieldgate Lawn, Fieldgate Lane CV8 1BT Kenilworth Warwickshire | England | British | 20708530004 | |||||
| POPP, Jason | Amministratore | Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry Ges England | United States | American | 254059920001 | |||||
| SAMJI, Munir Akberali | Amministratore | Unit 100 Centennial Avenue WD6 3SA Elstree Hertfordshire | United Kingdom | United Kingdom | 119498620001 | |||||
| SUTTON, Peter Howard | Amministratore | 109 Pembroke Road Muswell Hill N10 2JE London | British | 61149380001 | ||||||
| VENT, Richard H | Amministratore | 93 Tahoe Boulevard Suite 802-318 Incline Village 89451 Nevada Usa | American | 55991280001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BLITZ VISION LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viad Corp | 06 apr 2017 | 1850 N. Central Avenue Suite 1900 Phoenix Viad Corp Arizona 85004-4565 United States | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
| |||||||
BLITZ VISION LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee and debenture between (1) the chargor (the company) and (2) national westminster bank PLC (the security trustee) as agent and trustee for the secured parties (as defined) | Creato il 08 mag 2000 Consegnato il 16 mag 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All the actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the chargor to any of the secured parties under or pursuant to all or any of the financing documents (as defined) including the debenture | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 30 lug 1998 Consegnato il 11 ago 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to all or any of the financing documents including the guarantee and debenture | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 28 mag 1993 Consegnato il 03 giu 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Legal charge over all moneys from time to time held on any current deposit and/or other account at the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 19 giu 1991 Consegnato il 10 lug 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Collateral debenture | Creato il 19 giu 1991 Consegnato il 21 giu 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from simplecover limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Floating charges upon a) the stock in trade, work-in-progress, pre-payments investments quoted on a recognised stock exchange and cash of the company both present and future b) all other the undertaking and all other property and assets of the company c) any property and assets of company both present and future not charged by way of fixed charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 12 set 1990 Consegnato il 15 set 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Charge over funds held on deposit on a designated account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 23 feb 1990 Consegnato il 10 mar 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Legal charge over credit balances. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 09 ago 1989 Consegnato il 12 ago 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
BLITZ VISION LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0