PS INTERIM LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPS INTERIM LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02372386
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PS INTERIM LIMITED?

    • Attività delle agenzie di lavoro interinale (78200) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova PS INTERIM LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    Bedfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PS INTERIM LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PRAXIS EXECUTIVE TASKFORCE LIMITED16 lug 199216 lug 1992
    LOCUM EXECUTIVE LEASE LIMITED12 giu 198912 giu 1989
    MINSTERLINE LIMITED14 apr 198914 apr 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di PS INTERIM LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per PS INTERIM LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Ritiro della richiesta di cancellazione della società

    2 pagineDS02

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    15 pagineMG01

    legacy

    15 pagineMG01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 dic 2011

    9 pagineAA

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Pellipar House 1st Floor 9 Cloak Lane London EC4R 2RU United Kingdom

    1 pagineAD02

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 gen 2012

    Stato del capitale al 06 gen 2012

    • Capitale: GBP 200
    SH01

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2010

    9 pagineAA

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 201 Bishopsgate London EC2M 3AF United Kingdom

    1 pagineAD02

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2009

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Andrew Burchall il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Rebecca Jane Watson il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Rebecca Jane Watson il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2008

    6 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine353

    Chi sono gli amministratori di PS INTERIM LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WATSON, Rebecca Jane
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Other133821050001
    BURCHALL, Andrew Jeremy
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish69904570002
    WATSON, Rebecca Jane
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish70686070002
    CAMERON-CHILESHE, Stephanie Delores
    24 Fairway Avenue
    UB7 7AN West Drayton
    Middlesex
    Segretario
    24 Fairway Avenue
    UB7 7AN West Drayton
    Middlesex
    British96226170001
    HACKNEY, Kenneth
    11 Highwood Road
    ST14 8BQ Uttoxeter
    Staffordshire
    Segretario
    11 Highwood Road
    ST14 8BQ Uttoxeter
    Staffordshire
    British25932680001
    PENNINGTON, David Ian
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    Segretario
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    British38346120001
    SLADE, Richard
    31 Upcroft
    SL4 3NH Windsor
    Berkshire
    Segretario
    31 Upcroft
    SL4 3NH Windsor
    Berkshire
    British82272600001
    SPARKES, Margaret
    127 Whitecrest
    Great Barr
    B43 6ES Birmingham
    Segretario
    127 Whitecrest
    Great Barr
    B43 6ES Birmingham
    British38912430001
    THORPE, Adele Loraine
    Wilton Cottage
    Puers Lane Jordans
    HP9 2TE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Segretario
    Wilton Cottage
    Puers Lane Jordans
    HP9 2TE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British59134290002
    BLACKDEN, Benjamin Paul
    7 Layters Way
    SL9 7QZ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    7 Layters Way
    SL9 7QZ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish12656880001
    BLACKDEN, Benjamin Paul
    7 Layters Way
    SL9 7QZ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    7 Layters Way
    SL9 7QZ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish12656880001
    BRADFORD, Richard James
    Holcombe House
    Olney Road
    MK46 5BX Emberton
    Buckinghamshire
    Bucks
    Amministratore
    Holcombe House
    Olney Road
    MK46 5BX Emberton
    Buckinghamshire
    Bucks
    United KingdomBritish72452740004
    COATES, Jeremy William
    62 The Grove
    MK40 3JN Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    62 The Grove
    MK40 3JN Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritish58806030001
    DIXEY, Andrew Roger
    Hill House
    Bloxham
    OX15 4PH Oxon
    Amministratore
    Hill House
    Bloxham
    OX15 4PH Oxon
    EnglandBritish152068670001
    DOYLE, Desmond Mark Christopher
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Green Hill
    Hampshire
    Amministratore
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Green Hill
    Hampshire
    EnglandBritish266121440001
    HABBOO, Patrique Mansoor
    The Old Rectory
    CV8 3BH Bubbenhall
    Warwickshire
    Amministratore
    The Old Rectory
    CV8 3BH Bubbenhall
    Warwickshire
    British75853590002
    HAGUE, Carl Maxwell
    Fir Tree Cottage
    Bridstow
    HR9 6QF Ross On Wye
    Herefordshire
    Amministratore
    Fir Tree Cottage
    Bridstow
    HR9 6QF Ross On Wye
    Herefordshire
    British50437030003
    HAGUE, Heather Joan
    10 Riverside Court
    Wye Street
    HR2 7RA Hereford
    Herefordshire
    Amministratore
    10 Riverside Court
    Wye Street
    HR2 7RA Hereford
    Herefordshire
    British50437080001
    PENNINGTON, David Ian
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    EnglandBritish38346120001
    WORRALL, Kevin
    Guildersfield East Hill Farm Road
    Taplow
    SL6 0HQ Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Guildersfield East Hill Farm Road
    Taplow
    SL6 0HQ Maidenhead
    Berkshire
    British46493430003

    PS INTERIM LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and fixed and floating charge
    Creato il 23 ago 2012
    Consegnato il 28 ago 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Guarantee and fixed and floating charge
    Creato il 08 ago 2012
    Consegnato il 14 ago 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 06 mag 2008
    Consegnato il 23 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee or to any of the otehr finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited (the "Security Trustee")
    Transazioni
    • 23 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 06 mag 2008
    Consegnato il 17 mag 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from impellam group PLC, the original security obligors and any person which grants a security interest to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 10 nov 2005
    Consegnato il 24 nov 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 10 lug 2003
    Consegnato il 24 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Finance PLC as Trustee for Itself and Gmac Commercial Finance Llc
    Transazioni
    • 24 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 gen 1999
    Consegnato il 05 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 mar 1993
    Consegnato il 16 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plot 2A garages at cotts farm, lugwardine near hereford, herefordshire. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 nov 1992
    Consegnato il 21 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plot 2A cotts farm lugwardine near hereford county of hereford together with the garage buildings erected thereon or on some part thereof. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 19 giu 1991
    Consegnato il 24 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 24 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 07 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0