MARKETPLACE DESIGN LIMITED

MARKETPLACE DESIGN LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMARKETPLACE DESIGN LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02374116
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MARKETPLACE DESIGN LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova MARKETPLACE DESIGN LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o MSQ PARTNERS LIMITED
    90 Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MARKETPLACE DESIGN LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MARKETPLACE DESIGN PARTNERSHIP LIMITED12 apr 199612 apr 1996
    LEISURE MARKETPLACE LIMITED19 apr 198919 apr 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di MARKETPLACE DESIGN LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per MARKETPLACE DESIGN LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per MARKETPLACE DESIGN LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Msq Partners Limited 6 York Street London W1U 6PL a C/O Msq Partners Limited 90 Tottenham Court Road London W1T 4TJ in data 13 ago 2014

    1 pagineAD01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2013

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 ott 2013

    Stato del capitale al 22 ott 2013

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Nomina di Mr Daniel Yardley come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Peter David Reid come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Dean Wright come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 feb 2012

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Media Square Plc 6 York Street London W1U 6PL United Kingdom* in data 05 nov 2012

    1 pagineAD01

    legacy

    3 pagineMG02

    Nomina di Ashish Shah come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Colin Brigden come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 19 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2011

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Bruce Winfield come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Bruce Winfield come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Dean Anthony Wright come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 19 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2010

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di MARKETPLACE DESIGN LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHAH, Ashish
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Segretario
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    164776680001
    REID, Peter David
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Amministratore
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    EnglandBritish147274580002
    YARDLEY, Daniel John
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Amministratore
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    EnglandBritish180507300001
    BRIGDEN, Colin John
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Segretario
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    147343180001
    BURNS, Graeme Ian, Mr.
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    Segretario
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    British75720570001
    CLARKE, Martin John
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    Segretario
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    British53461320002
    JAMES, Jane Margaret
    6 Bugloss Walk
    OX26 3EB Bicester
    Segretario
    6 Bugloss Walk
    OX26 3EB Bicester
    British79460090001
    KENWORTHY, Brian
    24 Wendle Beck
    OX11 7EB Didcot
    Oxfordshire
    Segretario
    24 Wendle Beck
    OX11 7EB Didcot
    Oxfordshire
    British50236840003
    SILVERMAN, Harold
    Arbor House The Coombe
    Streatley
    RG8 9QT Reading
    Berkshire
    Segretario
    Arbor House The Coombe
    Streatley
    RG8 9QT Reading
    Berkshire
    British7613040001
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Segretario
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    British147948820001
    BROWN, Bryan Wyman
    Clanfield House 16 Park Crescent
    OX14 1DF Abingdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    Clanfield House 16 Park Crescent
    OX14 1DF Abingdon
    Oxfordshire
    United KingdomBritish7613050002
    BURNS, Graeme Ian, Mr.
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    Amministratore
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    United KingdomBritish75720570001
    CARTLIDGE, James Alan
    2 The Old Post Office Cottage
    East Hendred
    OX12 8JY Oxon
    Amministratore
    2 The Old Post Office Cottage
    East Hendred
    OX12 8JY Oxon
    British30764030001
    CHUNG, Philip
    Taverne Cottage 4 Hemplands Lane
    Privett
    GU34 3NU Alton
    Hampshire
    Amministratore
    Taverne Cottage 4 Hemplands Lane
    Privett
    GU34 3NU Alton
    Hampshire
    British7613080001
    COCHRANE, Ian Andrew
    Woolton House Oval Way
    SL9 8QD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Woolton House Oval Way
    SL9 8QD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish23219890001
    GOODALL, Ashley Graham
    The Willow House
    The Ridings, Headington
    OX3 8TB Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Willow House
    The Ridings, Headington
    OX3 8TB Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish53488670002
    KENWORTHY, Brian
    24 Wendle Beck
    OX11 7EB Didcot
    Oxfordshire
    Amministratore
    24 Wendle Beck
    OX11 7EB Didcot
    Oxfordshire
    British50236840003
    MIDDLETON, Jeremy
    Corbar Hall
    Corbar Road
    SK17 6TF Buxton
    Amministratore
    Corbar Hall
    Corbar Road
    SK17 6TF Buxton
    United KingdomBritish77048380001
    SILVERMAN, Harold
    Arbor House The Coombe
    Streatley
    RG8 9QT Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Arbor House The Coombe
    Streatley
    RG8 9QT Reading
    Berkshire
    British7613040001
    TAYLOR, Michael Simon
    Araucaria
    Elm Lane, Lower Earley
    RG6 5UQ Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Araucaria
    Elm Lane, Lower Earley
    RG6 5UQ Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish67702580001
    TURNER, Raymond
    15 Eastgate Street
    SO23 8EB Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    15 Eastgate Street
    SO23 8EB Winchester
    Hampshire
    British85794780001
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Amministratore
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    United KingdomBritish147948820001
    WRIGHT, Dean Anthony
    c/o Msq Partners Limited
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Msq Partners Limited
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    EnglandBritish159138180001

    MARKETPLACE DESIGN LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 04 nov 2005
    Consegnato il 17 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 17 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 16 dic 2004
    Consegnato il 23 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 05 lug 1996
    Consegnato il 16 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 03 ott 1989
    Consegnato il 20 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures & fittings fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 02 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0