YAXLEY SD LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàYAXLEY SD LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02376693
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di YAXLEY SD LIMITED?

    • fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture (25110) / Industrie manifatturiere
    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova YAXLEY SD LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    66 Clifton Street
    EC2A 4HB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di YAXLEY SD LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ELECO (SD) LIMITED04 giu 201304 giu 2013
    SPEEDDECK BUILDING SYSTEMS LIMITED01 ago 199701 ago 1997
    GANG - NAIL SYSTEMS UK LIMITED27 apr 198927 apr 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di YAXLEY SD LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per YAXLEY SD LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rinvio della dissoluzione

    1 pagineL64.04

    Completamento della liquidazione

    1 pagineL64.07

    Ordine del tribunale di liquidazione

    2 pagineCOCOMP

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed eleco (sd) LIMITED\certificate issued on 07/03/14
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name07 mar 2014

    Risoluzione di cambio di nome della società il 06 mar 2014

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Bilancio annuale redatto al 10 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 dic 2013

    Stato del capitale al 16 dic 2013

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio modificato redatto al 31 dic 2012

    11 pagineAAMD

    Cessazione della carica di Matthew Turner come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    11 pagineAA

    Cessazione della carica di Liam O'hara come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Lowe come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Haywood come amministratore

    2 pagineTM01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed speeddeck building systems LIMITED\certificate issued on 04/06/13
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name04 giu 2013

    Risoluzione di cambio di nome della società il 31 mag 2013

    RES15
    change-of-name04 giu 2013

    Cambio di nome" per delibera

    NM01

    Bilancio annuale redatto al 10 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Bilancio modificato redatto al 31 dic 2011

    11 pagineAAMD

    Nomina di Ivor Ashley Barton come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Ivor Barton come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ivor Barton come segretario

    2 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    11 pagineAA

    Nomina di Graham Neil Spratling come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr Ivor Ashley Barton come amministratore

    3 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 10 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Cessazione della carica di Richard Slater come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Matthew Lloyd Turner come amministratore

    3 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di YAXLEY SD LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BARTON, Ivor Ashley
    Bluebell Close
    HP1 2DH Hemel Hempstead
    5
    Herts
    Segretario
    Bluebell Close
    HP1 2DH Hemel Hempstead
    5
    Herts
    British174082340001
    SPRATLING, Graham Neil
    The Mall
    Park Street
    AL2 2HT St Albans
    3c
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    The Mall
    Park Street
    AL2 2HT St Albans
    3c
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishAccountant153162830001
    BARTON, Ivor Ashley
    5 Bluebell Close
    HP1 2DH Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Segretario
    5 Bluebell Close
    HP1 2DH Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British15818320006
    GRAVETT, Philip James
    Ellerslie Crawley End
    Chrishall
    SG8 8QJ Royston
    Hertfordshire
    Segretario
    Ellerslie Crawley End
    Chrishall
    SG8 8QJ Royston
    Hertfordshire
    British36746090001
    HANKS, Patricia Ellen
    54 Rounton Road
    Church Crookham
    GU13 0JH Fleet
    Hampshire
    Segretario
    54 Rounton Road
    Church Crookham
    GU13 0JH Fleet
    Hampshire
    British12812270001
    HOLDCROFT, Laurence Nigel
    71 Fanshawe Crescent
    SG12 0AR Ware
    Hertfordshire
    Segretario
    71 Fanshawe Crescent
    SG12 0AR Ware
    Hertfordshire
    British58539950002
    HOPKINS, Nigel Antony
    9 Norton Leys
    Wavendon Gate
    MK7 7TA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    9 Norton Leys
    Wavendon Gate
    MK7 7TA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British75324110002
    TSAPPIS, Neil John Alfred
    Burfield 85 Church Green Road
    Bletchley
    MK3 6DA Milton Keynes
    Segretario
    Burfield 85 Church Green Road
    Bletchley
    MK3 6DA Milton Keynes
    British49019640001
    BARTON, Ivor Ashley
    Bluebell Close
    HP1 2DH Hemel Hempstead
    5
    Herts
    England
    Amministratore
    Bluebell Close
    HP1 2DH Hemel Hempstead
    5
    Herts
    England
    EnglandBritishChartered Secretary15818320006
    BEALE, Leonard Michael
    5 Wrecclesham Hill
    Wrecclesham
    GU10 4JN Farnham
    Surrey
    Amministratore
    5 Wrecclesham Hill
    Wrecclesham
    GU10 4JN Farnham
    Surrey
    United KingdomBritishSales Director9456870001
    CRAMPHORN, Terence Henry
    White Oaks Moor Hall Lane
    Danbury
    CM3 4ER Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    White Oaks Moor Hall Lane
    Danbury
    CM3 4ER Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritishDirector47883780001
    CRAVEN, Timothy Asgill
    Moatfields
    Hoxne
    IP21 5AL Eye
    Suffolk
    Amministratore
    Moatfields
    Hoxne
    IP21 5AL Eye
    Suffolk
    BritishDirector20737780001
    DANNHAUSER, David Stephen
    8 Marsworth Avenue
    HA5 4UB Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    8 Marsworth Avenue
    HA5 4UB Pinner
    Middlesex
    EnglandBritishChartered Accountant55176170003
    GRAVETT, Philip James
    Ellerslie Crawley End
    Chrishall
    SG8 8QJ Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    Ellerslie Crawley End
    Chrishall
    SG8 8QJ Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritishGroup Financial Controller36746090001
    HADDON, Anthony
    Forest House
    Thornton Lane
    LE67 9RP Markfield
    Leicestershire
    Amministratore
    Forest House
    Thornton Lane
    LE67 9RP Markfield
    Leicestershire
    BritishGeneral Manager72194430001
    HANKS, Patricia Ellen
    54 Rounton Road
    Church Crookham
    GU13 0JH Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    54 Rounton Road
    Church Crookham
    GU13 0JH Fleet
    Hampshire
    BritishAccountant12812270001
    HART, Clifford Roy
    5 Holly Green
    Wetheringsett Road, Mickfield
    IP14 5LH Stowmarket
    Suffolk
    Amministratore
    5 Holly Green
    Wetheringsett Road, Mickfield
    IP14 5LH Stowmarket
    Suffolk
    BritishProduction Director66081020001
    HAYWOOD, Mark Royston
    8 Abinger Way
    Eaton
    NR4 6NA Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    8 Abinger Way
    Eaton
    NR4 6NA Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishAccountant68960560002
    KETTELEY, John Henry Beevor
    Keeway
    Ferry Road, Creeksea
    CM0 8PL Burnham On Crouch
    Essex
    Amministratore
    Keeway
    Ferry Road, Creeksea
    CM0 8PL Burnham On Crouch
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director3514610001
    LOWE, David Howard
    Willowdale The Street
    Redgrave
    IP22 1RY Diss
    Norfolk
    Amministratore
    Willowdale The Street
    Redgrave
    IP22 1RY Diss
    Norfolk
    EnglandBritishDirector40112290001
    NEWBY, Frederick Edward
    Farthingham Lane Ockley Road
    Ewhurst
    GU6 7QN Cranleigh
    Hartley
    Surrey
    Amministratore
    Farthingham Lane Ockley Road
    Ewhurst
    GU6 7QN Cranleigh
    Hartley
    Surrey
    United KingdomBritishManaging Director28923840001
    O'HARA, Liam Paul
    Shamrock Cottage
    King Street
    NR16 2QG East Harling
    Norfolk
    Amministratore
    Shamrock Cottage
    King Street
    NR16 2QG East Harling
    Norfolk
    United KingdomBritishCommercial Sales115473930001
    O'HARA, Liam Paul
    Shamrock Cottage
    King Street
    NR16 2QG East Harling
    Norfolk
    Amministratore
    Shamrock Cottage
    King Street
    NR16 2QG East Harling
    Norfolk
    United KingdomBritishCommercial Director115473930001
    PETERS, Christopher John
    11 Clarkes Close
    Palgrave
    IP22 1AY Diss
    Norfolk
    Amministratore
    11 Clarkes Close
    Palgrave
    IP22 1AY Diss
    Norfolk
    BritishDirector54417360001
    SHACKELL, Martin Edward
    4 Hidcote Close
    NN8 2JD Wellingborough
    Northamptonshire
    Amministratore
    4 Hidcote Close
    NN8 2JD Wellingborough
    Northamptonshire
    BritishGeneral Manager51840120002
    SHUM, Robert Jefferson
    Inishmore
    Fallowfield Drive, Barton Under Need
    DE13 8DH Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Inishmore
    Fallowfield Drive, Barton Under Need
    DE13 8DH Burton On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritishSales & Marketing Director66080960001
    SHUTTLE, Alan Peter
    16 Copse Avenue
    Weybourne
    GU9 9ED Farnham
    Surrey
    Amministratore
    16 Copse Avenue
    Weybourne
    GU9 9ED Farnham
    Surrey
    BritishManaging Director9456880001
    SLATER, Richard Craig Alan
    Stannage Lane
    Churton
    CH3 6LE Chester
    Westleigh
    England
    Amministratore
    Stannage Lane
    Churton
    CH3 6LE Chester
    Westleigh
    England
    United KingdomBritishCompany Director37111560008
    TAYLOR, Paul James
    40 Azalea Close
    LE17 4FR Lutterworth
    Leicestershire
    Amministratore
    40 Azalea Close
    LE17 4FR Lutterworth
    Leicestershire
    United KingdomBritishGeneral Manager69909170003
    TURNER, Matthew Lloyd
    Clifton Street
    EC2A 4HB London
    66
    Amministratore
    Clifton Street
    EC2A 4HB London
    66
    EnglandBritishChartered Accountant158037130001
    WHALE, Luke Richard John, Dr
    Stowehill Lymington Bottom
    Medstead
    GU34 Alton
    Hampshire
    Amministratore
    Stowehill Lymington Bottom
    Medstead
    GU34 Alton
    Hampshire
    BritishStructural Engineer12818450001

    YAXLEY SD LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 12TH september 2007 and
    Creato il 05 gen 2009
    Consegnato il 14 gen 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 14 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    An omnibus letter of set-off
    Creato il 12 set 2007
    Consegnato il 14 set 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 14 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off dated 4 march 1999 and
    Creato il 05 dic 2003
    Consegnato il 09 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture deed
    Creato il 05 mar 1999
    Consegnato il 26 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 26 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture deed
    Creato il 04 mar 1999
    Consegnato il 08 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge supplemental to a debenture dated 8 june 1998
    Creato il 13 ott 1998
    Consegnato il 21 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the aforesaid debenture
    Brevi particolari
    All right title benefit and interest in or arising out of a factoring invoice discounting or sales ledger financing agreement dated 20 october 1998 between the company and bny financial limited and all book and other debts the subject thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 giu 1998
    Consegnato il 23 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 ott 1997
    Consegnato il 31 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bny Financial Limited
    Transazioni
    • 31 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    YAXLEY SD LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    17 apr 2014Data della petizione
    07 mar 2019Conclusione della liquidazione
    09 giu 2014Inizio della liquidazione
    18 gen 2024Data prevista di scioglimento
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Praticante
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0