COASTAL SEAFORTH CONTAINER TERMINALS LIMITED

COASTAL SEAFORTH CONTAINER TERMINALS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOASTAL SEAFORTH CONTAINER TERMINALS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02379221
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COASTAL SEAFORTH CONTAINER TERMINALS LIMITED?

    • Trasporto passeggeri via acqua interna (50300) / Trasporto e stoccaggio

    Dove si trova COASTAL SEAFORTH CONTAINER TERMINALS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Maritime Centre
    Port Of Liverpool
    L21 1LA
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di COASTAL SEAFORTH CONTAINER TERMINALS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per COASTAL SEAFORTH CONTAINER TERMINALS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 13 mag 2016

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Cancel; share prem a/c 29/03/2016
    RES13

    Cessazione della carica di John Whittaker come amministratore in data 29 mar 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Thomas Eardley Allison come amministratore in data 29 mar 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 09 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 gen 2016

    Stato del capitale al 08 gen 2016

    • Capitale: GBP 128,600
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    13 pagineAA

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Risoluzioni

    Resolutions
    19 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John Whittaker il 07 apr 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 nov 2014

    Stato del capitale al 27 nov 2014

    • Capitale: GBP 128,600
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 09 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 gen 2014

    Stato del capitale al 14 gen 2014

    • Capitale: GBP 128,600
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    13 pagineAA

    legacy

    4 pagineMG02

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Nomina di Ian Graeme Lloyd Charnock come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di COASTAL SEAFORTH CONTAINER TERMINALS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MARRISON GILL, Caroline Ruth
    113 Tarvin Road
    Littleton
    CH3 7DE Chester
    Woodleigh
    Cheshire
    Segretario
    113 Tarvin Road
    Littleton
    CH3 7DE Chester
    Woodleigh
    Cheshire
    Other140064590001
    CHARNOCK, Ian Graeme Lloyd
    Holly Bank Drive
    HX3 8PA Halifax
    Woodcote
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Holly Bank Drive
    HX3 8PA Halifax
    Woodcote
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish165341530001
    WHITWORTH, Mark
    Culvert Lane
    Off Back Lane
    WN8 7XA Newburgh
    Springside
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Culvert Lane
    Off Back Lane
    WN8 7XA Newburgh
    Springside
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish120679580002
    BOWLEY, William John
    17 St Georges Road
    Formby
    L37 3HH Liverpool
    Merseyside
    Segretario
    17 St Georges Road
    Formby
    L37 3HH Liverpool
    Merseyside
    British4171240002
    ALLISON, Thomas Eardley
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Rockdale Lodge
    Amministratore
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Rockdale Lodge
    ScotlandBritish1037730004
    ALLISON, Thomas Eardley
    Rockdale Lodge
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Scotland
    Amministratore
    Rockdale Lodge
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Scotland
    ScotlandBritish1037730004
    BARR, Alan Andrew
    7 Wellington Terrace
    ML11 7QQ Lanark
    Lanarkshire
    Amministratore
    7 Wellington Terrace
    ML11 7QQ Lanark
    Lanarkshire
    ScotlandBritish121452150001
    BAXTER, Stephen Roy
    Springkell Avenue
    Pollokshields
    G41 4EH Glasgow
    94
    United Kingdom
    Amministratore
    Springkell Avenue
    Pollokshields
    G41 4EH Glasgow
    94
    United Kingdom
    ScotlandBritish86622660005
    CARTER, William
    7 Brows Lane
    L37 3HY Formby
    Amministratore
    7 Brows Lane
    L37 3HY Formby
    EnglandBritish50474650001
    CLIFF, Bernard
    7 Monks Way
    West Kirby
    L48 7ER Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    7 Monks Way
    West Kirby
    L48 7ER Wirral
    Merseyside
    British2637520001
    FINDLAY, Alastair Ian
    High Billinge House
    Utkinton
    CW6 0LA Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    High Billinge House
    Utkinton
    CW6 0LA Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritish30045540003
    FURLONG, Percival Trevor
    215 Queens Drive
    Wavertree
    L15 6YE Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    215 Queens Drive
    Wavertree
    L15 6YE Liverpool
    Merseyside
    British9867770001
    GREEN, David Simon
    16a Inverleith Row
    EH3 5LS Edinburgh
    Amministratore
    16a Inverleith Row
    EH3 5LS Edinburgh
    British42038120003
    HILL, Michael Gerard
    6 Larkhill Lane
    Freshfield
    L37 1LX Formby
    Merseyside
    Amministratore
    6 Larkhill Lane
    Freshfield
    L37 1LX Formby
    Merseyside
    EnglandBritish52180800001
    JONES, Peter Anthony
    22a Victoria Road
    West Kirby
    CH48 3HL Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    22a Victoria Road
    West Kirby
    CH48 3HL Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritish104612790001
    MASON, Geoffrey
    15 Ranelagh Drive North
    L19 9DS Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    15 Ranelagh Drive North
    L19 9DS Liverpool
    Merseyside
    United KingdomBritish4171260001
    MURRAY, Leslie Porter
    36 Ballymorran Road
    Killinchy
    BT23 6UE Newtownards
    County Down
    Amministratore
    36 Ballymorran Road
    Killinchy
    BT23 6UE Newtownards
    County Down
    Northern IrelandBritish144389520001
    PORT, David Charles
    Spellar Park
    Brandsby
    YO61 4RN York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Spellar Park
    Brandsby
    YO61 4RN York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish58053990001
    SCOTT, Peter Anthony
    6 Bowling Green Way
    Bamford
    OL11 5QQ Rochdale
    Lancashire
    Amministratore
    6 Bowling Green Way
    Bamford
    OL11 5QQ Rochdale
    Lancashire
    British1674500002
    WHITTAKER, John
    The Trafford Centre
    M17 8PL Manchester
    Peel Dome
    England
    England
    Amministratore
    The Trafford Centre
    M17 8PL Manchester
    Peel Dome
    England
    England
    Isle Of ManBritish1614010001

    COASTAL SEAFORTH CONTAINER TERMINALS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security deed of accession
    Creato il 28 feb 2007
    Consegnato il 13 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each other obligor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for Itself and Eachof the Secured Creditors
    Transazioni
    • 13 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 30 mar 2006
    Consegnato il 06 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee (whether for its own account or as security trustee for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 06 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0