RADIOWAVE (BLACKPOOL) LIMITED
Panoramica
Nome della società | RADIOWAVE (BLACKPOOL) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02380110 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di RADIOWAVE (BLACKPOOL) LIMITED?
- Radiodiffusione (60100) / Informazione e comunicazione
Dove si trova RADIOWAVE (BLACKPOOL) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Media House Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di RADIOWAVE (BLACKPOOL) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per RADIOWAVE (BLACKPOOL) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 lug 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 7 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 02 ott 2020
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorandum e Statuto | 11 pagine | MA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 lug 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 lug 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Deidre Ann Ford come amministratore in data 27 feb 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Charles Gill come amministratore in data 27 feb 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Paul Anthony Keenan come amministratore in data 27 feb 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Charles Stoddart Longcroft come amministratore in data 27 feb 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Notifica di Bauer Radio Limited come persona con controllo significativo il 28 feb 2019 | 4 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Scott William Taunton come amministratore in data 27 feb 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Bauer Group Secretariat Limited come segretario in data 28 feb 2019 | 3 pagine | AP04 | ||||||||||
Cessazione di The Wireless Group (Ilrs) Ltd come persona con controllo significativo il 28 feb 2019 | 3 pagine | PSC07 | ||||||||||
Modifica della data di chiusura dell'esercizio contabile | 3 pagine | AA01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da , 1 London Bridge Street, London, SE1 9GF, England a Media House Peterborough Business Park Lynch Wood Peterborough PE2 6EA in data 04 giu 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Sarah Jane Vickery come amministratore in data 27 feb 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 01 lug 2018 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di RADIOWAVE (BLACKPOOL) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAUER GROUP SECRETARIAT LIMITED | Segretario | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom |
| 159023720001 | ||||||||||
FORD, Deidre Ann | Amministratore | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | England | British | Director | 255749500002 | ||||||||
KEENAN, Paul Anthony | Amministratore | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | England | British | Director | 39692770004 | ||||||||
VICKERY, Sarah Jane | Amministratore | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 119137220002 | ||||||||
ALLEN, Stephen | Segretario | 1 Avenue Cottages High Street Mill Hill NW7 1QY London | British | 68299700001 | ||||||||||
ASHTON, Keir | Segretario | Top Flat 82 Brondesbury Road NW6 6RX London | British | 68400270001 | ||||||||||
BARNETT, Danielle | Segretario | 33 North Park Drive FY3 8NJ Blackpool Lancashire | British | 9233930001 | ||||||||||
DOWNEY, James Robinson | Segretario | 33 Karrington Heights Comber Road Dundonald BT16 1XZ Belfast County Antrim Northern Ireland | British | Finance Director | 107097580001 | |||||||||
LAWRENCE, Eric Alexander | Segretario | 26 Foxhills Covert Whickham NE16 5TN Newcastle Upon Tyne | British | 4250810002 | ||||||||||
SADLER, Keith John | Segretario | 12 Parrys Grove Stoke Bishop BS9 1TT Bristol Avon | British | 73173100006 | ||||||||||
TOMPKINS, Anthony | Segretario | London Bridge Street SE1 9GF London 1 England | 165681370001 | |||||||||||
OLSWANG COSEC LIMITED | Segretario | 90 High Holborn WC1V 6XX London Seventh Floor | 83864780002 | |||||||||||
AIREY, Andrew Simon | Amministratore | 57 North Park Drive FY3 8NH Blackpool Lancashire | England | British | Wine Merchant | 16913450001 | ||||||||
BARNETT, Danielle | Amministratore | 33 North Park Drive FY3 8NJ Blackpool Lancashire | British | Director | 9233930001 | |||||||||
BARNETT MBE DL, John Morris | Amministratore | Broadview 33 North Park Drive FY3 8NJ Blackpool Lancashire | England | British | Director (Managing) | 122413520001 | ||||||||
BATEY, James Derek | Amministratore | Holme Eden 172 St Annes Road East St Annes FY8 3HP Lytham St Annes Lancashire | United Kingdom | British | Director Production Company | 21252100001 | ||||||||
CARR, Anthony David | Amministratore | 3 Braxfield Court St Annes Road West FY8 1LQ Lytham St Annes Lancashire | British | Director Men/Ladies Retail | 13455890003 | |||||||||
DOWNEY, James Robinson | Amministratore | 33 Karrington Heights Comber Road Dundonald BT16 1XZ Belfast County Antrim Northern Ireland | United Kingdom | British | Finance Director | 107097580001 | ||||||||
FRIEDLAND, Sidney | Amministratore | 53 Broadway SK8 1LB Cheadle Cheshire | British | Commercial Banker | 28444360001 | |||||||||
GILL, Michael Charles | Amministratore | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 123013340001 | ||||||||
GOODWIN, Jonathan Philip Pryce | Amministratore | 29 Broadhinton Road SW4 0LT London | British | Managing Director | 68743940001 | |||||||||
JOSEPHS, John Irving | Amministratore | 22 Osbaldeston Gardens NE3 4JE Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | Company Director | 3830990001 | ||||||||
LAWRENCE, Eric Alexander | Amministratore | 26 Foxhills Covert Whickham NE16 5TN Newcastle Upon Tyne | British | Finance Director | 4250810002 | |||||||||
LEE, Matthew Everett | Amministratore | 2 East Mead KY3 9LN Blackpool Lancashire | United Kingdom | British | Publisher | 97863000001 | ||||||||
LEE, Samuel George | Amministratore | 7 St Clements Avenue FY3 8LT Blackpool Lancashire | British | Solicitor/Hm Coroner | 19009470001 | |||||||||
LONGCROFT, Christopher Charles Stoddart | Amministratore | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | England | British | Chief Financial Officer | 163116880001 | ||||||||
MACKENZIE, Ashley Calder | Amministratore | 6 Springshaw Close TN13 2QE Sevenoaks Kent | British | Director Radio Executive | 59529980005 | |||||||||
MACKENZIE, Kelvin Calder | Amministratore | Christophers Lockstone Close KT13 8EF Weybridge Surrey | United Kingdom | British | Director Chief Executive | 141795340001 | ||||||||
MCCANN, John | Amministratore | 175 Malone Road BT9 6TB Belfast County Antrim Northern Ireland | Northern Ireland | British | Managing Director | 75447990001 | ||||||||
MCKEOWN, Norman | Amministratore | Ormeau Road BT7 1EB Belfast Havelock House Northern Ireland | Northern Ireland | British | Director | 165664890001 | ||||||||
OWEN, Glyn David | Amministratore | 10 Woodside Drive CW11 0JP Sandbach Cheshire | British | Managing Director | 26534930001 | |||||||||
SADLER, Keith John | Amministratore | 12 Parrys Grove Stoke Bishop BS9 1TT Bristol Avon | British | Accountant | 73173100006 | |||||||||
TAUNTON, Scott William | Amministratore | London Bridge Street SE1 9GF London 1 United Kingdom | United Kingdom | Australian | Company Director | 80505610007 | ||||||||
TOMPKINS, Anthony David | Amministratore | London Bridge Street SE1 9GF London 1 England | England | British | Finance Director | 165684030001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di RADIOWAVE (BLACKPOOL) LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauer Radio Limited | 28 feb 2019 | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
The Wireless Group (Ilrs) Ltd | 06 apr 2016 | 401 Faraday Street, Birchwood Park WA3 6GA Warrington Ground Floor England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
RADIOWAVE (BLACKPOOL) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Guarantee | Creato il 21 ott 1999 Consegnato il 03 nov 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All liability crystallised and all other sums due. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee and debenture | Creato il 21 ott 1999 Consegnato il 03 nov 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 29 set 1999 Consegnato il 20 ott 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever save for those liabilities specifically excluded by the terms of a letter executed as a deed by the companies and the bank | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 16 feb 1998 Consegnato il 21 feb 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0