ARGENT DEVELOPMENT MANAGEMENT LIMITED

ARGENT DEVELOPMENT MANAGEMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàARGENT DEVELOPMENT MANAGEMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02383342
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ARGENT DEVELOPMENT MANAGEMENT LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova ARGENT DEVELOPMENT MANAGEMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5 Albany Courtyard
    Piccadilly
    W1J 0HF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ARGENT DEVELOPMENT MANAGEMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ARGENT REAL ESTATE (KNIGHTSBRIDGE) LIMITED15 giu 198915 giu 1989
    TAPMARR LIMITED12 mag 198912 mag 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di ARGENT DEVELOPMENT MANAGEMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per ARGENT DEVELOPMENT MANAGEMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di un amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gary John Taylor come amministratore in data 03 nov 2011

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di David Partridge come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Anthony Giddings come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andre Gibbs come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robert Evans come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    11 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 nov 2010

    Stato del capitale al 26 nov 2010

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Tillman il 30 lug 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David John Gratiaen Partridge il 01 apr 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andre Gibbs il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Roger Nigel Madelin il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andre Gibbs il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Robert Michael Evans il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di ARGENT DEVELOPMENT MANAGEMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PROWER, Aubyn James Sugden
    Marchants
    Lower Station Road Newick
    BN8 4HT Lewes
    East Sussex
    Segretario
    Marchants
    Lower Station Road Newick
    BN8 4HT Lewes
    East Sussex
    British45043490002
    SADLER, Anita Joanne
    8 Eddiscombe Road
    SW6 4UA London
    Segretario
    8 Eddiscombe Road
    SW6 4UA London
    British104279900001
    MADELIN, Roger Nigel
    Kings Road
    TW10 6NN Richmond
    23
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Kings Road
    TW10 6NN Richmond
    23
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish11621570005
    PROWER, Aubyn James Sugden
    Marchants
    Lower Station Road Newick
    BN8 4HT Lewes
    East Sussex
    Amministratore
    Marchants
    Lower Station Road Newick
    BN8 4HT Lewes
    East Sussex
    United KingdomBritish45043490002
    TILLMAN, Stephen
    Farmington
    GL54 3ND Cheltenham
    Church House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Farmington
    GL54 3ND Cheltenham
    Church House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish58659580031
    COOK, Kenneth Alan
    27 Glendower Road
    East Sheen
    SW14 8NY London
    Segretario
    27 Glendower Road
    East Sheen
    SW14 8NY London
    British100000003
    TAMBOR, Jane
    22 Montgomery Road
    Chiswick
    W4 5LZ London
    Segretario
    22 Montgomery Road
    Chiswick
    W4 5LZ London
    British11621560002
    BOSSOM, Bruce Charles
    Overbury Court
    GL20 7NP Tewkesbury
    Gloucestershire
    Amministratore
    Overbury Court
    GL20 7NP Tewkesbury
    Gloucestershire
    United KingdomBritish32773150001
    COOKSON, Peter James
    2 Elmfield Gardens
    Speen Lane
    RG14 1WA Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    2 Elmfield Gardens
    Speen Lane
    RG14 1WA Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish61776300002
    EVANS, Robert Michael
    66a Holtspur Top Lane
    HP9 1DT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    66a Holtspur Top Lane
    HP9 1DT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish99016100002
    FREEMAN, Michael Ian
    9 Connaught Square
    W2 2HG London
    Amministratore
    9 Connaught Square
    W2 2HG London
    United KingdomBritish2119280002
    FREEMAN, Peter Geoffrey
    Airlie Lodge 64 Sheffield Terrace
    W8 7AP London
    Amministratore
    Airlie Lodge 64 Sheffield Terrace
    W8 7AP London
    United KingdomBritish11621550012
    GIBBS, Andre
    21a Hampstead Lane
    Highgate
    N6 4RT London
    West Cottage
    United Kingdom
    Amministratore
    21a Hampstead Lane
    Highgate
    N6 4RT London
    West Cottage
    United Kingdom
    United KingdomBritish99016080003
    GIDDINGS, Anthony Jan
    The Old Alms House
    Cage End Hatfield Broad Oak
    CM22 7HW Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Old Alms House
    Cage End Hatfield Broad Oak
    CM22 7HW Bishops Stortford
    Hertfordshire
    EnglandBritish56956610003
    MILLAR, Ronald
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    Amministratore
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    British70586450001
    PARTRIDGE, David John Gratiaen
    39/41 All Saints Road Notting Hill
    W11 1HE London
    Flat 4
    United Kingdom
    Amministratore
    39/41 All Saints Road Notting Hill
    W11 1HE London
    Flat 4
    United Kingdom
    United KingdomBritish41215410019
    TAYLOR, Gary John
    21 South Road
    DY9 0JT West Hagley
    Worcestershire
    Amministratore
    21 South Road
    DY9 0JT West Hagley
    Worcestershire
    United KingdomBritish161266610001
    WATSON, John Harrison
    Scotton Lodge
    Scotton
    HG5 9HW Knaresborough
    North Yorks
    Amministratore
    Scotton Lodge
    Scotton
    HG5 9HW Knaresborough
    North Yorks
    British3592920001

    ARGENT DEVELOPMENT MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage of shares
    Creato il 05 set 1995
    Consegnato il 06 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due or to become due from the company, the trustee qcc (birmingham) limited and argent group investments PLC to the chargee on any account whatsoever under each finance document (as defined in the mortgage)
    Brevi particolari
    The shares save in respect of dividends payable all stocks shares securities rights moneys or property & all interest. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 06 set 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 05 set 1995
    Consegnato il 06 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due or to become due from the company, argent group investments PLC and the trustee qcc (birmingham) limited to the chargee on any account whatsoever under each finance document (as defined in the charge)
    Brevi particolari
    F/H land k/a queens college chambers inc, 37 37A 38 38A & 39 paradise street and the land & buildings on the north side of swallow street t/no WK15998 & WYK152590 inc all rental income the benefit of all guarantees and all book & other debts the goodwill of the business the benefit of all licences uncalled capital etc. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 06 set 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Equitable charge
    Creato il 18 lug 1995
    Consegnato il 19 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from argent (preston) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and premises k/a suffolk house and norfolk house, laurence pountney hill, london EC4 t/no. NGL95424 together with all fixtures fittings plant machinery goods and materials thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transazioni
    • 19 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 set 1989
    Consegnato il 18 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or transferee (as defined) to the chargee under the terms of a loan agreement dated 14/09/89
    Brevi particolari
    L/H princes court and situate at 78/94A brompton road london SW3 all proceeds of sale floating charge over & nights. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Security Pacific National Bank
    Transazioni
    • 18 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 24 feb 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0