ASHFORD GROUP HOLDINGS LTD
Panoramica
| Nome della società | ASHFORD GROUP HOLDINGS LTD |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02384207 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ASHFORD GROUP HOLDINGS LTD?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova ASHFORD GROUP HOLDINGS LTD?
| Indirizzo della sede legale | c/o FTI CONSULTING LLP 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ASHFORD GROUP HOLDINGS LTD?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CACTUSTREE LIMITED | 15 mag 1989 | 15 mag 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ASHFORD GROUP HOLDINGS LTD?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per ASHFORD GROUP HOLDINGS LTD?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori | 18 pagine | LIQ14 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 26 set 2018 | 17 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Suite 64 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE England a C/O Fti Consulting Llp 200 Aldersgate Street London EC1A 4HD in data 16 ott 2017 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione delle attività | 10 pagine | LIQ02 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 mag 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 68 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE a Suite 64 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE in data 09 giu 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Sally Ann Coughlan il 02 gen 2016 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Matthew Alexander Rosenberg come amministratore in data 01 apr 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Sally Ann Coughlan il 02 ott 2014 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Queens Court 9-17 Eastern Road Romford RM1 3NG a 68 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE in data 29 set 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 10 pagine | MR04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Michael Teasdale come amministratore in data 08 ago 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Martin Quinn come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Simon Michael Teasdale come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Erwin Rieck come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ASHFORD GROUP HOLDINGS LTD?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUGHLAN, Sally Ann | Segretario | c/o Fti Consulting Llp Aldersgate Street EC1A 4HD London 200 | British | 107832420001 | ||||||||||||
| QUINN, Martin Joseph | Amministratore | 34 Francis Grove, Wimbledon SW19 4DT London Westmont Management Limited England | England | Irish | 186571310001 | |||||||||||
| BURGESS, Keith John | Segretario | 3 Queen Annes Gate White House Walk GU9 9AN Farnham Surrey | British | 7009790002 | ||||||||||||
| CHRISTIAN, Tracy Joanne | Segretario | 19 Lovell Walk RM13 7ND Rainham Essex | British | 102667300001 | ||||||||||||
| JONES, Vanessa | Segretario | Stables House Castle Hill RH1 4LB Bletchingley Surrey | British | 72146200001 | ||||||||||||
| PURVIS, Martin Terence Alan | Segretario | Fenetters Melfort Road TN6 1QT Crowborough East Sussex | British | 7901050001 | ||||||||||||
| STADEN, Paul Sidney | Segretario | Swallows Barn New College Court MK18 5JP Chackmore Buckingham | British | 35453800001 | ||||||||||||
| WATERS, Jonathan Roy | Segretario | Maldon Road CO3 3BQ Colchester 237 Essex | British | 129848360001 | ||||||||||||
| ALLSOP, Heather Louise | Amministratore | 62 Prebend Street N1 8PS London | British | 101912850001 | ||||||||||||
| ASHFORD, Martin John | Amministratore | The Elms Chessetts Wood Road B94 6EL Lapworth Solihull | British | 1450190001 | ||||||||||||
| BAIRSTOW, John | Amministratore | Frieze Cottage Coxtie Green Road South Weald CM14 5RE Brentwood Essex | British | 537400001 | ||||||||||||
| CAIRNS, Michael Anthony | Amministratore | Birchlands Old Avenue KT13 0PY Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 36488470001 | |||||||||||
| COLES, Alan Clifford | Amministratore | The Knoll Grendon NN7 1JG Northampton Beeches, 5 Northamptonshire | England | British | 101144900002 | |||||||||||
| COLLYER, Brian Charles | Amministratore | 49 Route De Croissy 78110 Le Vesinet France | Canadian | 101144260001 | ||||||||||||
| COPPEL, Andrew Maxwell | Amministratore | Orchard House 8 Claremont Park Road KT10 9LT Esher Surrey | England | British | 14330100002 | |||||||||||
| CUTTS, John Charles | Amministratore | Tudor Gables Old Warwick Road Lapworth B94 6AY Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 56651680001 | |||||||||||
| GOIN, Russell Todd | Amministratore | 4 Rue Jadin 75017 FOREIGN Paris France | American | 108675490001 | ||||||||||||
| KABALAN, Fadi | Amministratore | Keyes House Dolphin Square SW1V 3NA London Suite 311 | England | British | 133846470001 | |||||||||||
| KRAIS, Ashley Simon | Amministratore | 74 Marsh Lane NW7 4NT London | United Kingdom | British | 105921220001 | |||||||||||
| LE POIDEVIN, Andrew Daryl | Amministratore | Kinneil 34 Bulstrode Way SL9 7QU Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 4958800007 | |||||||||||
| MENARD, Veronique Pascale Dominique | Amministratore | Goldman Sachs International Peterborough Court, 133 Fleet Street EC4A 2BB London Goldman Sachs International England | United Kingdom | French | 141156250001 | |||||||||||
| METCALFE, Michael Stuart | Amministratore | Harwil 37 Howards Thicket SL9 7NT Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 40294180002 | |||||||||||
| MOORE, Richard John | Amministratore | 2 Maple Wood Bedhampton PO9 3JB Havant Hampshire | England | British | 101144680001 | |||||||||||
| MULAHASANI, Heather Louise | Amministratore | Goldman Sachs International Peterborough Court, 133 Fleet Street EC4A 2BB London Goldman Sachs International | England | British | 136994090001 | |||||||||||
| OGDEN, Kathryn | Amministratore | 14 Arundel Court 43-47 Arundel Gardens W11 2LP London | American | 114248790002 | ||||||||||||
| RIECK, Erwin Joseph | Amministratore | Queens Court 9-17 Eastern Road RM1 3NG Romford Queens Court Essex England | German | 108675520002 | ||||||||||||
| ROSENBERG, Matthew Alexander | Amministratore | Queens Court 9-17 Eastern Road RM1 3NG Romford Queens Court Essex England | England | British | 134723670001 | |||||||||||
| SCOBLE, Timothy James | Amministratore | 57 Old Road Wheatley OX33 1NX Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | 83743120001 | |||||||||||
| STADEN, Paul Sidney | Amministratore | Swallows Barn New College Court MK18 5JP Chackmore Buckingham | British | 35453800001 | ||||||||||||
| TEASDALE, Simon Michael | Amministratore | Queens Court 9-17 Eastern Road RM1 3NG Romford | United Kingdom | British | 204008350001 | |||||||||||
| WILLIAMS, John Taylor | Amministratore | The Old Rectory Rectory Way Wappenham NW12 8XG Towcester Northants | British | 35538260004 | ||||||||||||
| W2001 BRITANNIA LLC | Amministratore | The Corporation Trust Company 1209 Orange Street Wilmington The Corporation Trust Company County Of Newcastle Usa |
| 152068560001 | ||||||||||||
| W2001 TWO CV | Amministratore | Strawinskylaan 1207 1077 Xx Amsterdam Strawinskylaan 1207 Netherlands |
| 152068080001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ASHFORD GROUP HOLDINGS LTD?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qmh Limited | 06 apr 2016 | Waterhouse Business Park 2 Cromar Way CM1 2QE Chelmsford Suite 64 Essex England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ASHFORD GROUP HOLDINGS LTD ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Creato il 19 ott 2012 Consegnato il 06 nov 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from qmh (a) construction limited and the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over all property and assets, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A composite guarantee and debenture | Creato il 23 feb 2005 Consegnato il 04 mar 2005 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 24 nov 2004 Consegnato il 14 dic 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of legal mortgage all estates or interests in the f/h, l/h and other immovable property. By way of fixed charge all estates or interests in any f/h, l/h and other immovable property, all stocks shares debentures bonds notes and loan capital, the goodwill, all copyrights and patents. By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 18 giu 2004 Consegnato il 25 giu 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental deed to the composite guarantee and debenture | Creato il 08 giu 2004 Consegnato il 11 giu 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 25 mar 2004 Consegnato il 26 mar 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
ASHFORD GROUP HOLDINGS LTD ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei creditori |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0