GIBB HOLDINGS LTD
Panoramica
| Nome della società | GIBB HOLDINGS LTD |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02387714 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GIBB HOLDINGS LTD?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova GIBB HOLDINGS LTD?
| Indirizzo della sede legale | Cottons Centre Cottons Lane SE1 2QG London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GIBB HOLDINGS LTD?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| GIBB LIMITED | 18 set 1989 | 18 set 1989 |
| CHULSAVALE LIMITED | 22 mag 1989 | 22 mag 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GIBB HOLDINGS LTD?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 01 ott 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per GIBB HOLDINGS LTD?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Nomina di Mr Geoffrey Roberts come segretario in data 21 ago 2023 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Rhona Mary Holman come segretario in data 21 ago 2023 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 29 giu 2023
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Rhona Mary Holman come segretario in data 10 feb 2023 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Tejender Singh Chaudhary come segretario in data 10 feb 2023 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 gen 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Katherine Helen Kenny come amministratore in data 15 dic 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Hugh Donald Morrison come amministratore in data 15 dic 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 01 ott 2021 | 24 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 gen 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 02 ott 2020 | 26 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mrs Sally Miles come amministratore in data 11 ago 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Guy Douglas come amministratore in data 11 ago 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 gen 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2019 | 26 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan R. Shattock come amministratore in data 30 nov 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Hugh Donald Morrison come amministratore in data 30 nov 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Guy Douglas il 17 dic 2020 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Jacobs Uk Limited come persona con controllo significativo il 02 nov 2020 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di GIBB HOLDINGS LTD?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTS, Geoffrey | Segretario | Cottons Lane SE1 2QG London Cottons Centre United Kingdom | 312725290001 | |||||||
| KENNY, Katherine Helen | Amministratore | Cottons Lane SE1 2QG London Cottons Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 216980410001 | |||||
| MILES, Sally Linda Joyce | Amministratore | Cottons Lane SE1 2QG London Cottons Centre United Kingdom | England | British | 161125950001 | |||||
| CHAUDHARY, Tejender Singh | Segretario | Cottons Lane SE1 2QG London Cottons Centre United Kingdom | 246698880001 | |||||||
| HOLMAN, Rhona Mary | Segretario | Cottons Lane SE1 2QG London Cottons Centre United Kingdom | 305629180001 | |||||||
| MARKLEY, William Clyde | Segretario | 2105 Sunnybank Drive La Canada 91011 Flintridge California United States Of America | American | 57955380001 | ||||||
| NORRIS, Michael Timothy | Segretario | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire United Kingdom | British | 52563600002 | ||||||
| UDOVIC, Michael Sean | Segretario | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire United Kingdom | 165335900001 | |||||||
| WARD, Sandra Lesley | Segretario | 17 Clayfields HP10 8AT Tylers Green Bucks | British | 89320390001 | ||||||
| WITHERS, Graham Reginald | Segretario | 33 Ryhill Way Lower Earley RG6 4AZ Reading Berkshire | British | 1420080001 | ||||||
| BACK, Paul Adrian Auchmuty, Dr | Amministratore | Parsonage Farm How Lane SL6 3JP White Waltham Berkshire | British | 22932520001 | ||||||
| BARBER, Walter Charles | Amministratore | 61 Riverside House Bear Wharf Fobney Street RG1 6BJ Reading Berkshire | American | 93663320001 | ||||||
| BOWCOCK, John Brown | Amministratore | Lothlorien Crowsley Road RG9 3JU Shiplake Oxfordshire | British | 34950050001 | ||||||
| BRETTELL, Peter Donald | Amministratore | Blorenge Cottage Holly Lane Ashampstead RG8 8RT Reading Berkshire | British | 34455550003 | ||||||
| BRICE, Geoffrey John | Amministratore | 3 Orwell Close Caversham RG4 7PU Reading Berkshire | British | 7239880001 | ||||||
| COATES, Geoffrey Hamilton | Amministratore | The Shealing Backsideans Wargrave-On-Thames RG10 8JP Reading Berkshire | British | 1420060001 | ||||||
| COLES, Bruce Charles | Amministratore | 703 Henley Fields Circle FOREIGN Duluth Georgia 30155 Usa | American | 49990460001 | ||||||
| DANGER, James Ivan | Amministratore | 2694 Northbrook Drive Atlanta FOREIGN Georgia 30340 Usa | American | 43472160001 | ||||||
| DAWSON, James Grant Forbes | Amministratore | Woodpeckers Pangbourne Hill RG8 8JS Pangbourne Berkshire | British | 32689240001 | ||||||
| DOUGLAS, Guy | Amministratore | Cottons Lane SE1 2QG London Cottons Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 258025190001 | |||||
| DOYLE, John Conor | Amministratore | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire United Kingdom | England | Irish | 78009780001 | |||||
| DUFF, Robert Shepherd | Amministratore | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire United Kingdom | Scotland | British | 165632810001 | |||||
| ELLIS, David | Amministratore | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire | United Kingdom | British | 206422550001 | |||||
| FOOSHEE, Robert Brown | Amministratore | 9000 Etching Overlook Drive FOREIGN Duluth Georgia 30097 Usa | American | 49990480001 | ||||||
| HENNESSEY, John Richard | Amministratore | Folly Farm Barkham Road RG11 4BS Wokingham Berkshire | British | 22928530001 | ||||||
| IRVIN, Robert Anthony Michael | Amministratore | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire United Kingdom | England | British | 161055320001 | |||||
| JONES, Graham Roger | Amministratore | Coningsby 81 The Rise TN13 1RN Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 42069750001 | |||||
| MONTGOMERY, Michael Wayne | Amministratore | Red Fox Cottage Old Bath Road Sonning RG4 0TA Reading Berkshire | American | 32725930002 | ||||||
| MORRISON, Hugh Donald | Amministratore | Cottons Lane SE1 2QG London Cottons Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 240150920001 | |||||
| SEHGAL, Raghbir Kumar | Amministratore | 55 Cliffside Crossing Atlanta Georgia Ga 30338 Usa | American | 32725940001 | ||||||
| SHATTOCK, Jonathan R. | Amministratore | Cottons Lane SE1 2QG London Cottons Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 259549880001 | |||||
| STANCOMBE, Christopher John | Amministratore | 8 Wellington Gardens Southend Bradfield RG7 6EJ Reading Berkshire | England | British | 33841950002 | |||||
| STEINBRENNER, Frederick James | Amministratore | 5707 Brynwood Circle 30101 Georgia Usa | American | 7239910004 | ||||||
| TAYLOR, Allyn Byram | Amministratore | Mill Lane Cookham SL6 9QT Maidenhead Formosa Court House Berkshire United Kingdom | England | United States | 124922150002 | |||||
| WALKER, William Allen | Amministratore | 3345 Robinson Farms Court Marietta FOREIGN Atlanta Georgia Ga 30068 Usa | American | 15467690004 |
Chi sono le persone con controllo significativo di GIBB HOLDINGS LTD?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacobs Uk Limited | 06 apr 2016 | Cottons Lane SE1 2QG London Cottons Centre United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
GIBB HOLDINGS LTD ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of rectification and supplemental charge | Creato il 03 nov 1995 Consegnato il 22 nov 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 13% of the issued share capital of prointec sa being: 300,000 pesetas............................13 Common stock of pesetas,100,000 numbered 8-18 and 21 and 94; all stocks,shares,bonds,debentures,notes...etc..........all dividends/other income and all rights,benefits,money or property..................all repayments of principal on loan notes.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 13 ott 1995 Consegnato il 18 ott 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over shares | Creato il 11 ott 1995 Consegnato il 18 ott 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to suntrust bank,atlanta for itself and as agent and trustee on behalf of the lenders (as defined)to each lender in any currency and whether or not the lender in question shall have been a party to the original transaction except any money or liabilities due by any company as guarantor for the depositor | |
Brevi particolari The securities all dividends distributions interest and other income all accretions of a capital nature and all capital sums received. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| First charge | Creato il 08 ott 1993 Consegnato il 13 ott 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The actual contingent present and/or future obligations and liabilities (i)of law companies group,inc.to trust company bank and other banks under a credit agreement dated 8 october 1993 (us$42,000,000 together with interest,charges and costs)(ii)of law companies group,inc.to trust company bank under a reimbursement agreement dated 8 october 1993 (all amounts due under letters of credit issued by trust company bank)(iii)of law companies group,inc.and sir alexander gibb & partners limited to barclays bank PLC under a facility letter dated 8 october 1993 (£16,900,000 together with interest charges and costs)(iv)of gibb limited to barclays bank PLC under a commercial mortgage facility letter dated 8 february 1990 (£495,900 together with interest charges and costs) and (v)the obligations of certain partnerships and companies defined as sir alexander gibb partnerships to barclays bank PLC (£2,000,000 together with interest,charges and costs)and amounts due under the indemnity contained in clause 15.3 of the first charge | |
Brevi particolari 2,217,800 shares of £1 each in sir alexander gibb & partners limited together with any substituted or additional shares or other securities and further including all allotments,accretions,offers,voting or other rights.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 02 mar 1990 Consegnato il 07 mar 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Flat 5, 2 hyde park street, london W2. Title no. Ngl 617261. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 22 ago 1989 Consegnato il 24 ago 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0