GIBB HOLDINGS LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGIBB HOLDINGS LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02387714
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GIBB HOLDINGS LTD?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova GIBB HOLDINGS LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Cottons Centre
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GIBB HOLDINGS LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GIBB LIMITED18 set 198918 set 1989
    CHULSAVALE LIMITED22 mag 198922 mag 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di GIBB HOLDINGS LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al01 ott 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per GIBB HOLDINGS LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Nomina di Mr Geoffrey Roberts come segretario in data 21 ago 2023

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Rhona Mary Holman come segretario in data 21 ago 2023

    1 pagineTM02

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Stato del capitale al 29 giu 2023

    • Capitale: GBP 0.40412
    5 pagineSH19

    legacy

    2 pagineSH20

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Nomina di Rhona Mary Holman come segretario in data 10 feb 2023

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Tejender Singh Chaudhary come segretario in data 10 feb 2023

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 gen 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mrs Katherine Helen Kenny come amministratore in data 15 dic 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Hugh Donald Morrison come amministratore in data 15 dic 2022

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 01 ott 2021

    24 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 gen 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 02 ott 2020

    26 pagineAA

    Nomina di Mrs Sally Miles come amministratore in data 11 ago 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Guy Douglas come amministratore in data 11 ago 2021

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 gen 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2019

    26 pagineAA

    Cessazione della carica di Jonathan R. Shattock come amministratore in data 30 nov 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Hugh Donald Morrison come amministratore in data 30 nov 2020

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Guy Douglas il 17 dic 2020

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Jacobs Uk Limited come persona con controllo significativo il 02 nov 2020

    2 paginePSC05

    Chi sono gli amministratori di GIBB HOLDINGS LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ROBERTS, Geoffrey
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Segretario
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    312725290001
    KENNY, Katherine Helen
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Amministratore
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish216980410001
    MILES, Sally Linda Joyce
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Amministratore
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    EnglandBritish161125950001
    CHAUDHARY, Tejender Singh
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Segretario
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    246698880001
    HOLMAN, Rhona Mary
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Segretario
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    305629180001
    MARKLEY, William Clyde
    2105 Sunnybank Drive
    La Canada
    91011 Flintridge
    California
    United States Of America
    Segretario
    2105 Sunnybank Drive
    La Canada
    91011 Flintridge
    California
    United States Of America
    American57955380001
    NORRIS, Michael Timothy
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    British52563600002
    UDOVIC, Michael Sean
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    165335900001
    WARD, Sandra Lesley
    17 Clayfields
    HP10 8AT Tylers Green
    Bucks
    Segretario
    17 Clayfields
    HP10 8AT Tylers Green
    Bucks
    British89320390001
    WITHERS, Graham Reginald
    33 Ryhill Way
    Lower Earley
    RG6 4AZ Reading
    Berkshire
    Segretario
    33 Ryhill Way
    Lower Earley
    RG6 4AZ Reading
    Berkshire
    British1420080001
    BACK, Paul Adrian Auchmuty, Dr
    Parsonage Farm
    How Lane
    SL6 3JP White Waltham
    Berkshire
    Amministratore
    Parsonage Farm
    How Lane
    SL6 3JP White Waltham
    Berkshire
    British22932520001
    BARBER, Walter Charles
    61 Riverside House
    Bear Wharf Fobney Street
    RG1 6BJ Reading
    Berkshire
    Amministratore
    61 Riverside House
    Bear Wharf Fobney Street
    RG1 6BJ Reading
    Berkshire
    American93663320001
    BOWCOCK, John Brown
    Lothlorien
    Crowsley Road
    RG9 3JU Shiplake
    Oxfordshire
    Amministratore
    Lothlorien
    Crowsley Road
    RG9 3JU Shiplake
    Oxfordshire
    British34950050001
    BRETTELL, Peter Donald
    Blorenge Cottage
    Holly Lane Ashampstead
    RG8 8RT Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Blorenge Cottage
    Holly Lane Ashampstead
    RG8 8RT Reading
    Berkshire
    British34455550003
    BRICE, Geoffrey John
    3 Orwell Close
    Caversham
    RG4 7PU Reading
    Berkshire
    Amministratore
    3 Orwell Close
    Caversham
    RG4 7PU Reading
    Berkshire
    British7239880001
    COATES, Geoffrey Hamilton
    The Shealing
    Backsideans Wargrave-On-Thames
    RG10 8JP Reading
    Berkshire
    Amministratore
    The Shealing
    Backsideans Wargrave-On-Thames
    RG10 8JP Reading
    Berkshire
    British1420060001
    COLES, Bruce Charles
    703 Henley Fields Circle
    FOREIGN Duluth
    Georgia 30155
    Usa
    Amministratore
    703 Henley Fields Circle
    FOREIGN Duluth
    Georgia 30155
    Usa
    American49990460001
    DANGER, James Ivan
    2694 Northbrook Drive
    Atlanta
    FOREIGN Georgia 30340
    Usa
    Amministratore
    2694 Northbrook Drive
    Atlanta
    FOREIGN Georgia 30340
    Usa
    American43472160001
    DAWSON, James Grant Forbes
    Woodpeckers
    Pangbourne Hill
    RG8 8JS Pangbourne
    Berkshire
    Amministratore
    Woodpeckers
    Pangbourne Hill
    RG8 8JS Pangbourne
    Berkshire
    British32689240001
    DOUGLAS, Guy
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Amministratore
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish258025190001
    DOYLE, John Conor
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandIrish78009780001
    DUFF, Robert Shepherd
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish165632810001
    ELLIS, David
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    Amministratore
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United KingdomBritish206422550001
    FOOSHEE, Robert Brown
    9000 Etching Overlook Drive
    FOREIGN Duluth
    Georgia 30097
    Usa
    Amministratore
    9000 Etching Overlook Drive
    FOREIGN Duluth
    Georgia 30097
    Usa
    American49990480001
    HENNESSEY, John Richard
    Folly Farm
    Barkham Road
    RG11 4BS Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    Folly Farm
    Barkham Road
    RG11 4BS Wokingham
    Berkshire
    British22928530001
    IRVIN, Robert Anthony Michael
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish161055320001
    JONES, Graham Roger
    Coningsby 81 The Rise
    TN13 1RN Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Coningsby 81 The Rise
    TN13 1RN Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish42069750001
    MONTGOMERY, Michael Wayne
    Red Fox Cottage
    Old Bath Road Sonning
    RG4 0TA Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Red Fox Cottage
    Old Bath Road Sonning
    RG4 0TA Reading
    Berkshire
    American32725930002
    MORRISON, Hugh Donald
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Amministratore
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish240150920001
    SEHGAL, Raghbir Kumar
    55 Cliffside Crossing
    Atlanta
    Georgia Ga 30338
    Usa
    Amministratore
    55 Cliffside Crossing
    Atlanta
    Georgia Ga 30338
    Usa
    American32725940001
    SHATTOCK, Jonathan R.
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Amministratore
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish259549880001
    STANCOMBE, Christopher John
    8 Wellington Gardens
    Southend Bradfield
    RG7 6EJ Reading
    Berkshire
    Amministratore
    8 Wellington Gardens
    Southend Bradfield
    RG7 6EJ Reading
    Berkshire
    EnglandBritish33841950002
    STEINBRENNER, Frederick James
    5707 Brynwood Circle
    30101 Georgia
    Usa
    Amministratore
    5707 Brynwood Circle
    30101 Georgia
    Usa
    American7239910004
    TAYLOR, Allyn Byram
    Mill Lane
    Cookham
    SL6 9QT Maidenhead
    Formosa Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Mill Lane
    Cookham
    SL6 9QT Maidenhead
    Formosa Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandUnited States124922150002
    WALKER, William Allen
    3345 Robinson Farms Court
    Marietta
    FOREIGN Atlanta
    Georgia Ga 30068
    Usa
    Amministratore
    3345 Robinson Farms Court
    Marietta
    FOREIGN Atlanta
    Georgia Ga 30068
    Usa
    American15467690004

    Chi sono le persone con controllo significativo di GIBB HOLDINGS LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Jacobs Uk Limited
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland Companies Registry
    Numero di registrazione02594504
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    GIBB HOLDINGS LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of rectification and supplemental charge
    Creato il 03 nov 1995
    Consegnato il 22 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    13% of the issued share capital of prointec sa being: 300,000 pesetas............................13 Common stock of pesetas,100,000 numbered 8-18 and 21 and 94; all stocks,shares,bonds,debentures,notes...etc..........all dividends/other income and all rights,benefits,money or property..................all repayments of principal on loan notes.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Suntrust Bank,Atlanta
    Transazioni
    • 22 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 13 ott 1995
    Consegnato il 18 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares
    Creato il 11 ott 1995
    Consegnato il 18 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to suntrust bank,atlanta for itself and as agent and trustee on behalf of the lenders (as defined)to each lender in any currency and whether or not the lender in question shall have been a party to the original transaction except any money or liabilities due by any company as guarantor for the depositor
    Brevi particolari
    The securities all dividends distributions interest and other income all accretions of a capital nature and all capital sums received. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Suntrust Bank Atlanta
    Transazioni
    • 18 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First charge
    Creato il 08 ott 1993
    Consegnato il 13 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities (i)of law companies group,inc.to trust company bank and other banks under a credit agreement dated 8 october 1993 (us$42,000,000 together with interest,charges and costs)(ii)of law companies group,inc.to trust company bank under a reimbursement agreement dated 8 october 1993 (all amounts due under letters of credit issued by trust company bank)(iii)of law companies group,inc.and sir alexander gibb & partners limited to barclays bank PLC under a facility letter dated 8 october 1993 (£16,900,000 together with interest charges and costs)(iv)of gibb limited to barclays bank PLC under a commercial mortgage facility letter dated 8 february 1990 (£495,900 together with interest charges and costs) and (v)the obligations of certain partnerships and companies defined as sir alexander gibb partnerships to barclays bank PLC (£2,000,000 together with interest,charges and costs)and amounts due under the indemnity contained in clause 15.3 of the first charge
    Brevi particolari
    2,217,800 shares of £1 each in sir alexander gibb & partners limited together with any substituted or additional shares or other securities and further including all allotments,accretions,offers,voting or other rights.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Trust Company Bankertain Other Banksas Collateral Agent and Trustee for Itself and C
    Transazioni
    • 13 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 mar 1990
    Consegnato il 07 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Flat 5, 2 hyde park street, london W2. Title no. Ngl 617261.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 31 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 ago 1989
    Consegnato il 24 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transazioni
    • 24 ago 1989Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0