DIODES ZETEX SEMICONDUCTORS LIMITED
Panoramica
Nome della società | DIODES ZETEX SEMICONDUCTORS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02387949 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DIODES ZETEX SEMICONDUCTORS LIMITED?
- fabbricazione di componenti elettronici (26110) / Industrie manifatturiere
Dove si trova DIODES ZETEX SEMICONDUCTORS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Zetex Technology Park Chadderton OL9 9LL Oldham |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di DIODES ZETEX SEMICONDUCTORS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ZETEX SEMICONDUCTORS LIMITED | 09 giu 2008 | 09 giu 2008 |
ZETEX SEMICONDUCTORS PLC | 23 apr 2004 | 23 apr 2004 |
ZETEX PLC | 29 dic 1997 | 29 dic 1997 |
ZETEX PLC | 03 lug 1989 | 03 lug 1989 |
SWITCHARM LIMITED | 23 mag 1989 | 23 mag 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di DIODES ZETEX SEMICONDUCTORS LIMITED?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2024 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per DIODES ZETEX SEMICONDUCTORS LIMITED?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 23 mag 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 06 giu 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 23 mag 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per DIODES ZETEX SEMICONDUCTORS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Bilancio redatto al 31 dic 2023 | 39 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Dr Gerard John Mccarthy come amministratore in data 01 feb 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Timothy Monaghan come amministratore in data 01 feb 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2022 | 39 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2020 | 39 pagine | AA | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2021 | 39 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 35 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Iscrizione dell'ipoteca 023879490005, creata il 06 mag 2020 | 38 pagine | MR01 | ||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||
Nomina di Mr Timothy Monaghan come amministratore in data 09 dic 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Keh-Shew Lu come amministratore in data 09 dic 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Brett Richardson Whitmire come amministratore in data 10 dic 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Richard Dallas White come amministratore in data 10 dic 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 32 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 31 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 30 pagine | AA | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 32 pagine | AA | ||
Chi sono gli amministratori di DIODES ZETEX SEMICONDUCTORS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCCARTHY, Gerard John, Dr | Amministratore | Zetex Technology Park Chadderton OL9 9LL Oldham | Scotland | British | Eu President | 76685410002 | ||||
WHITMIRE, Brett Richardson | Amministratore | Suite 100 Plano 75024 Texas 4949 Hedgecoxe Road United States | United States | American | Cfo | 265221660001 | ||||
GREENE, Colin Keith | Segretario | 15 Rippon Hall Avenue Ramsbottom BL0 9RE Bury Lancashire | British | Director | 59710770001 | |||||
HAZZLEWOOD, David Gordon | Segretario | 137 Davyhulme Road Davyhulme M41 8BX Urmston Manchester | British | 48307620001 | ||||||
MORTON, Julia Alison | Segretario | Kingsdown Close Wychwood Park CW2 5FX Weston 5 Cheshire United Kingdom | British | 135499480001 | ||||||
SEFTON, Michael Edward | Segretario | Oak Cottage Cuckoos Knob Wootton Rivers SN8 4NR Marlborough Wiltshire | British | 51018120001 | ||||||
SHARP, Lorraine | Segretario | 168 Ember Lane KT10 8EJ Esher Surrey | British | Company Secretary | 26356800001 | |||||
BENSTEAD, David Christopher | Amministratore | Mead House Walker Lane, Fulwood PR2 7AN Preston Lancashire | British | Director | 60199210002 | |||||
BIRKENSHAW, Charles Stephen | Amministratore | Beech Court 54a Lightfoot Lane Fulwood PR2 3LR Preston Lancashire | British | Chartered Accountant | 36848760001 | |||||
CONWAY, Robert David | Amministratore | 10 Harrop Green Diggle OL3 5LW Oldham Lancashire | British | Director | 34979860003 | |||||
COTTERILL, Roy Clifford George | Amministratore | 102 Evesham Road GL52 2AL Cheltenham Gloucestershire | British | Engineer/Director | 1540920001 | |||||
CURTIS, Timothy Malise | Amministratore | Street Farmhouse Vernham Street SP11 0EL Andover Hampshire | British | Director | 10381640015 | |||||
GREENE, Colin Keith | Amministratore | 15 Rippon Hall Avenue Ramsbottom BL0 9RE Bury Lancashire | England | British | Director | 59710770001 | ||||
HAWKINS, Nick Bryan | Amministratore | 2 Weaver Close WA14 3FY Bowdon Cheshire | British | Accountant | 112132820001 | |||||
HAZZLEWOOD, David Gordon | Amministratore | 137 Davyhulme Road Davyhulme M41 8BX Urmston Manchester | British | Chartered Accountant | 48307620001 | |||||
LU, Keh-Shew, Dr | Amministratore | 5109 Runnin River Drive Plano Texas 75093 United States | United States | American | Director | 126068550001 | ||||
MARX, Frank | Amministratore | Bergstrasse 3a Baierbrunn 82065 Germany | German | Director | 104021600002 | |||||
MCMANUS, Gary John | Amministratore | 13 Frampton Close Alkrington, Middleton M24 1FF Manchester | England | British | Director | 122408680001 | ||||
MONAGHAN, Timothy | Amministratore | Zetex Technology Park Chadderton OL9 9LL Oldham | United Kingdom | British | President Of Diodes Europe | 242363600001 | ||||
PARDON, Alan William | Amministratore | Hill View Alweston, Alweston DT9 5JR Sherborne Dorset | England | British | Finance Director | 109722740001 | ||||
RATTRAY, Bruce Davidson | Amministratore | The Little House 34 Parkway GU15 2PE Camberley Surrey | United Kingdom | British | Accountant | 3071690001 | ||||
ROEVES, Terence | Amministratore | 33 York Crescent Wilmslow Park South SK9 2BB Wilmslow Cheshire | British | Director | 77929440001 | |||||
ROHRER, Hans | Amministratore | 262 The Edge Clowes Street M3 5NG Manchester | England | German | Director | 110718200001 | ||||
STURT, Robert Montague | Amministratore | Woodlands Gallowsclough Lane WA6 8LW Norley Cheshire | British | Director | 28307300002 | |||||
WHITE, Richard Dallas | Amministratore | Twin Coves Street Dallas 5907 Texas 75248 United States | United States | American | Director | 132081680001 | ||||
WIGGANS, Edward Charles | Amministratore | Dockwray Grasmere LA22 9QD Ambleside Cumbria | British | Director | 42228590003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di DIODES ZETEX SEMICONDUCTORS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diodes Zetex Limited | 06 apr 2016 | Bentfield Industrial Units, Stockfield Road Chadderton OL9 9LL Oldham Zetex Technology Park England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
DIODES ZETEX SEMICONDUCTORS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 06 mag 2020 Consegnato il 14 mag 2020 | In corso | ||
Breve descrizione Land and buildings on the south side of stockfield road – registered at the land registry with title number LA180273.. Land and building on the south side of stockfield road – registered at the land registry with title number GM175967. Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 26 mar 2012 Consegnato il 28 mar 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from every employer to the diodes zetex pension scheme on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of first legal mortgage all of diodez zetex semiconductors limited's (company) estate or interest in the property k/a land and buildings on the south side of stockfield road t/no LA180273 and the land and buildings on the south side of stockfield road t/no GM175967 and every part of it including all buildings, fixtures. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 30 nov 2001 Consegnato il 06 dic 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £492,092.30 and all other sums due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari One s-4700 scanning electron microscope - serial no. 6040-03 and one rfx test system - serial no. 1101 together with all accessories and component parts and all improvements and renewals thereof.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 31 ott 2001 Consegnato il 02 nov 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,257,907.70 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The items as listed on the schedule attached. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 17 lug 1998 Consegnato il 23 lug 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,750,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Vacuum metal etcher machine model vae and pump, cambridge scanning electron microscope, portable analytical system pas-1FHN, rf bar coding system (for details of further goods charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0