DIODES ZETEX SEMICONDUCTORS LIMITED

DIODES ZETEX SEMICONDUCTORS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDIODES ZETEX SEMICONDUCTORS LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02387949
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di DIODES ZETEX SEMICONDUCTORS LIMITED?

    • fabbricazione di componenti elettronici (26110) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova DIODES ZETEX SEMICONDUCTORS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Zetex Technology Park
    Chadderton
    OL9 9LL Oldham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DIODES ZETEX SEMICONDUCTORS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ZETEX SEMICONDUCTORS LIMITED09 giu 200809 giu 2008
    ZETEX SEMICONDUCTORS PLC23 apr 200423 apr 2004
    ZETEX PLC29 dic 199729 dic 1997
    ZETEX PLC03 lug 198903 lug 1989
    SWITCHARM LIMITED23 mag 198923 mag 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di DIODES ZETEX SEMICONDUCTORS LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per DIODES ZETEX SEMICONDUCTORS LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al23 mag 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma06 giu 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al23 mag 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per DIODES ZETEX SEMICONDUCTORS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Bilancio redatto al 31 dic 2023

    39 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Dr Gerard John Mccarthy come amministratore in data 01 feb 2024

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Timothy Monaghan come amministratore in data 01 feb 2024

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2022

    39 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    39 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2021

    39 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    35 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 023879490005, creata il 06 mag 2020

    38 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    2 pagineMR04

    Nomina di Mr Timothy Monaghan come amministratore in data 09 dic 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Keh-Shew Lu come amministratore in data 09 dic 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Brett Richardson Whitmire come amministratore in data 10 dic 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard Dallas White come amministratore in data 10 dic 2019

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    32 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    31 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    30 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    32 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di DIODES ZETEX SEMICONDUCTORS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCCARTHY, Gerard John, Dr
    Zetex Technology Park
    Chadderton
    OL9 9LL Oldham
    Amministratore
    Zetex Technology Park
    Chadderton
    OL9 9LL Oldham
    ScotlandBritishEu President76685410002
    WHITMIRE, Brett Richardson
    Suite 100
    Plano
    75024
    Texas
    4949 Hedgecoxe Road
    United States
    Amministratore
    Suite 100
    Plano
    75024
    Texas
    4949 Hedgecoxe Road
    United States
    United StatesAmericanCfo265221660001
    GREENE, Colin Keith
    15 Rippon Hall Avenue
    Ramsbottom
    BL0 9RE Bury
    Lancashire
    Segretario
    15 Rippon Hall Avenue
    Ramsbottom
    BL0 9RE Bury
    Lancashire
    BritishDirector59710770001
    HAZZLEWOOD, David Gordon
    137 Davyhulme Road
    Davyhulme
    M41 8BX Urmston
    Manchester
    Segretario
    137 Davyhulme Road
    Davyhulme
    M41 8BX Urmston
    Manchester
    British48307620001
    MORTON, Julia Alison
    Kingsdown Close
    Wychwood Park
    CW2 5FX Weston
    5
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    Kingsdown Close
    Wychwood Park
    CW2 5FX Weston
    5
    Cheshire
    United Kingdom
    British135499480001
    SEFTON, Michael Edward
    Oak Cottage Cuckoos Knob
    Wootton Rivers
    SN8 4NR Marlborough
    Wiltshire
    Segretario
    Oak Cottage Cuckoos Knob
    Wootton Rivers
    SN8 4NR Marlborough
    Wiltshire
    British51018120001
    SHARP, Lorraine
    168 Ember Lane
    KT10 8EJ Esher
    Surrey
    Segretario
    168 Ember Lane
    KT10 8EJ Esher
    Surrey
    BritishCompany Secretary26356800001
    BENSTEAD, David Christopher
    Mead House
    Walker Lane, Fulwood
    PR2 7AN Preston
    Lancashire
    Amministratore
    Mead House
    Walker Lane, Fulwood
    PR2 7AN Preston
    Lancashire
    BritishDirector60199210002
    BIRKENSHAW, Charles Stephen
    Beech Court 54a Lightfoot Lane
    Fulwood
    PR2 3LR Preston
    Lancashire
    Amministratore
    Beech Court 54a Lightfoot Lane
    Fulwood
    PR2 3LR Preston
    Lancashire
    BritishChartered Accountant36848760001
    CONWAY, Robert David
    10 Harrop Green
    Diggle
    OL3 5LW Oldham
    Lancashire
    Amministratore
    10 Harrop Green
    Diggle
    OL3 5LW Oldham
    Lancashire
    BritishDirector34979860003
    COTTERILL, Roy Clifford George
    102 Evesham Road
    GL52 2AL Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    102 Evesham Road
    GL52 2AL Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishEngineer/Director1540920001
    CURTIS, Timothy Malise
    Street Farmhouse
    Vernham Street
    SP11 0EL Andover
    Hampshire
    Amministratore
    Street Farmhouse
    Vernham Street
    SP11 0EL Andover
    Hampshire
    BritishDirector10381640015
    GREENE, Colin Keith
    15 Rippon Hall Avenue
    Ramsbottom
    BL0 9RE Bury
    Lancashire
    Amministratore
    15 Rippon Hall Avenue
    Ramsbottom
    BL0 9RE Bury
    Lancashire
    EnglandBritishDirector59710770001
    HAWKINS, Nick Bryan
    2 Weaver Close
    WA14 3FY Bowdon
    Cheshire
    Amministratore
    2 Weaver Close
    WA14 3FY Bowdon
    Cheshire
    BritishAccountant112132820001
    HAZZLEWOOD, David Gordon
    137 Davyhulme Road
    Davyhulme
    M41 8BX Urmston
    Manchester
    Amministratore
    137 Davyhulme Road
    Davyhulme
    M41 8BX Urmston
    Manchester
    BritishChartered Accountant48307620001
    LU, Keh-Shew, Dr
    5109 Runnin River Drive
    Plano
    Texas 75093
    United States
    Amministratore
    5109 Runnin River Drive
    Plano
    Texas 75093
    United States
    United StatesAmericanDirector126068550001
    MARX, Frank
    Bergstrasse 3a
    Baierbrunn
    82065
    Germany
    Amministratore
    Bergstrasse 3a
    Baierbrunn
    82065
    Germany
    GermanDirector104021600002
    MCMANUS, Gary John
    13 Frampton Close
    Alkrington, Middleton
    M24 1FF Manchester
    Amministratore
    13 Frampton Close
    Alkrington, Middleton
    M24 1FF Manchester
    EnglandBritishDirector122408680001
    MONAGHAN, Timothy
    Zetex Technology Park
    Chadderton
    OL9 9LL Oldham
    Amministratore
    Zetex Technology Park
    Chadderton
    OL9 9LL Oldham
    United KingdomBritishPresident Of Diodes Europe242363600001
    PARDON, Alan William
    Hill View
    Alweston, Alweston
    DT9 5JR Sherborne
    Dorset
    Amministratore
    Hill View
    Alweston, Alweston
    DT9 5JR Sherborne
    Dorset
    EnglandBritishFinance Director109722740001
    RATTRAY, Bruce Davidson
    The Little House 34 Parkway
    GU15 2PE Camberley
    Surrey
    Amministratore
    The Little House 34 Parkway
    GU15 2PE Camberley
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant3071690001
    ROEVES, Terence
    33 York Crescent
    Wilmslow Park South
    SK9 2BB Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    33 York Crescent
    Wilmslow Park South
    SK9 2BB Wilmslow
    Cheshire
    BritishDirector77929440001
    ROHRER, Hans
    262 The Edge
    Clowes Street
    M3 5NG Manchester
    Amministratore
    262 The Edge
    Clowes Street
    M3 5NG Manchester
    EnglandGermanDirector110718200001
    STURT, Robert Montague
    Woodlands
    Gallowsclough Lane
    WA6 8LW Norley
    Cheshire
    Amministratore
    Woodlands
    Gallowsclough Lane
    WA6 8LW Norley
    Cheshire
    BritishDirector28307300002
    WHITE, Richard Dallas
    Twin Coves Street
    Dallas
    5907
    Texas 75248
    United States
    Amministratore
    Twin Coves Street
    Dallas
    5907
    Texas 75248
    United States
    United StatesAmericanDirector132081680001
    WIGGANS, Edward Charles
    Dockwray
    Grasmere
    LA22 9QD Ambleside
    Cumbria
    Amministratore
    Dockwray
    Grasmere
    LA22 9QD Ambleside
    Cumbria
    BritishDirector42228590003

    Chi sono le persone con controllo significativo di DIODES ZETEX SEMICONDUCTORS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bentfield Industrial Units, Stockfield Road
    Chadderton
    OL9 9LL Oldham
    Zetex Technology Park
    England
    06 apr 2016
    Bentfield Industrial Units, Stockfield Road
    Chadderton
    OL9 9LL Oldham
    Zetex Technology Park
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEnglish
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione1378777
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    DIODES ZETEX SEMICONDUCTORS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 06 mag 2020
    Consegnato il 14 mag 2020
    In corso
    Breve descrizione
    Land and buildings on the south side of stockfield road – registered at the land registry with title number LA180273.. Land and building on the south side of stockfield road – registered at the land registry with title number GM175967.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • James Brooks, Hr Trustees Limited and Ian Smith as Trustees of the Diodes Zetex Pension Scheme
    Transazioni
    • 14 mag 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Legal charge
    Creato il 26 mar 2012
    Consegnato il 28 mar 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from every employer to the diodes zetex pension scheme on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all of diodez zetex semiconductors limited's (company) estate or interest in the property k/a land and buildings on the south side of stockfield road t/no LA180273 and the land and buildings on the south side of stockfield road t/no GM175967 and every part of it including all buildings, fixtures.
    Persone aventi diritto
    • John Robert Earnshaw, H R Trustees Limited, Ian Smith as Trustee of the Diodes Zetex Pension Scheme
    Transazioni
    • 28 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 30 nov 2001
    Consegnato il 06 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £492,092.30 and all other sums due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    One s-4700 scanning electron microscope - serial no. 6040-03 and one rfx test system - serial no. 1101 together with all accessories and component parts and all improvements and renewals thereof.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 31 ott 2001
    Consegnato il 02 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,257,907.70 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The items as listed on the schedule attached. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 17 lug 1998
    Consegnato il 23 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,750,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Vacuum metal etcher machine model vae and pump, cambridge scanning electron microscope, portable analytical system pas-1FHN, rf bar coding system (for details of further goods charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 23 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0