PATALEX II PRODUCTIONS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PATALEX II PRODUCTIONS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02392350 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PATALEX II PRODUCTIONS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova PATALEX II PRODUCTIONS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 250, Bishopsgate EC2M 4AA London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PATALEX II PRODUCTIONS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ROVARD DISTRIBUTION LIMITED | 01 set 1989 | 01 set 1989 |
| BEAMLEY LIMITED | 06 giu 1989 | 06 giu 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PATALEX II PRODUCTIONS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per PATALEX II PRODUCTIONS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 ott 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 18 pagine | AA | ||||||
Seconda presentazione per la cessazione di Mr David Gerald Harris come amministratore | 5 pagine | RP04TM01 | ||||||
Nomina di Mr Simon Charles Lowe come amministratore in data 26 apr 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||
Cessazione della carica di Stephen Paul Nixon come amministratore in data 26 apr 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||
Indirizzo della sede legale modificato da The Quadrangle the Promenade Cheltenham Gloucestershire GL50 1PX a 250, Bishopsgate London EC2M 4AA in data 12 apr 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||
Nomina di Natwest Markets Secretarial Services Limited come segretario in data 29 gen 2019 | 2 pagine | AP04 | ||||||
Cessazione della carica di Rbs Secretarial Services Limited come segretario in data 29 gen 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2018 al 31 dic 2018 | 1 pagine | AA01 | ||||||
Cessazione della carica di Ian Andrew Ellis come amministratore in data 08 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||
Nomina di Keith Damian Pereira come amministratore in data 08 gen 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||
Nomina di Stephen Paul Nixon come amministratore in data 08 gen 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||
Cessazione della carica di Steven James Roulston come amministratore in data 08 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||
Cessazione della carica di David Gerald Harris come amministratore in data 08 gen 2018 | 2 pagine | TM01 | ||||||
| ||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 ott 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||
Bilancio redatto al 30 set 2017 | 19 pagine | AA | ||||||
Nomina di Ian Andrew Ellis come amministratore in data 06 mar 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||
Cessazione della carica di Emma-Marie Mayes come amministratore in data 06 mar 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||
Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 05 feb 2018 | 2 pagine | PSC09 | ||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 ott 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||
Chi sono gli amministratori di PATALEX II PRODUCTIONS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATWEST MARKETS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England |
| 249447430001 | ||||||||||
| LOWE, Simon Charles | Amministratore | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England | England | British | 109835010002 | |||||||||
| PEREIRA, Keith Damian | Amministratore | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 | England | British | 239981580001 | |||||||||
| BARNES, John Charlton | Segretario | Pinehurst Felcourt Road Felcourt RH19 2LA East Grinstead West Sussex | British | 2951340001 | ||||||||||
| BROMLEY, Heidi Elizabeth | Segretario | 1 Snowball Cottages Swan Lane RH6 0DB Charlwood Surrey | British | 33605720003 | ||||||||||
| THOMAS, Marina Louise | Segretario | Richmond Lodge Rhinefield Road SO42 7SQ Brockenhurst Hampshire | British | 80901390001 | ||||||||||
| THOMAS, Marina Louise | Segretario | Richmond Lodge Rhinefield Road SO42 7SQ Brockenhurst Hampshire | British | 80901390001 | ||||||||||
| WHITTAKER, Carolyn Jean | Segretario | 6 Whitewood Cottages Whitewood Lane RH9 8JR South Godstone Surrey | Other | 67499700003 | ||||||||||
| WHITTAKER, Carolyn Jean | Segretario | 6 Whitewood Cottages Whitewood Lane RH9 8JR South Godstone Surrey | Other | 67499700003 | ||||||||||
| WHITTAKER, Carolyn Jean | Segretario | 13 Clare Cottages Bletchingley RH1 4RE Redhill Surrey | British | 67499700001 | ||||||||||
| RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24/25 Scotland |
| 169073830001 | ||||||||||
| BRIAN, Michael | Amministratore | 30 Highlands Road KT22 8NJ Leatherhead Surrey | British | 24633390001 | ||||||||||
| CASTLEDINE, Trevor Vaughan | Amministratore | 22 Woodhayes Road Wimbledon SW19 4RF London | British | 98778780002 | ||||||||||
| CATERER, Sharon Jill | Amministratore | The Promonade GL50 1PX Cheltenham The Quadrangle Gloucestershire England | England | British | 15490360001 | |||||||||
| CLEMETT, Graham Colin | Amministratore | 15 Winchester Close KT10 8QH Esher Surrey | United Kingdom | British | 123744930001 | |||||||||
| CLIBBENS, Nigel Timothy John | Amministratore | The Quadrangle The Promenade GL50 1PX Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 49141230004 | |||||||||
| CLIBBENS, Nigel Timothy John | Amministratore | 40a Pennington Road Southborough TN4 0SL Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 49141230004 | |||||||||
| CROME, Trevor Douglas | Amministratore | The Quadrangle The Promenade GL50 1PX Cheltenham Gloucestershire | England | British | 186705800001 | |||||||||
| DEVINE, Alan Sinclair | Amministratore | 42 Mirfield Road B91 1JD Solihull West Midlands | British | 96634670001 | ||||||||||
| ELLIS, Ian Andrew | Amministratore | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England | United Kingdom | British | 243996550001 | |||||||||
| FARNELL, Adrian Colin | Amministratore | Whitestrand Gadshill Road Charlton Kings GL53 8EF Cheltenham Gloucestershire | England | British | 43015720002 | |||||||||
| FINNERTY, Colin William | Amministratore | Sayers House Sayers Common BN6 9HU Hassocks West Sussex | British | 52209790001 | ||||||||||
| GADSBY, Andrew Paul | Amministratore | The Quadrangle The Promenade GL50 1PX Cheltenham Gloucestershire | England | British | 74834980002 | |||||||||
| HARRIS, David Gerald | Amministratore | EC2M 4RB London 280 Bishopsgate England | United Kingdom | British | 236842580001 | |||||||||
| JOHNSON, Alan Piers | Amministratore | EC2M 4RB London, 280 Bishopsgate England | England | British | 155895050001 | |||||||||
| LATTER, William Vaughan | Amministratore | Mernian Bushley GL20 6HX Tewkesbury Gloucestershire | British | 52914600004 | ||||||||||
| LEWIS, Derek John | Amministratore | 48 Chantry Avenue Hartley DA3 8DD Longfield Kent | England | British | 34423910002 | |||||||||
| MAYES, Emma-Marie | Amministratore | The Quadrangle The Promenade GL50 1PX Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 258397370001 | |||||||||
| MCDAID, Neil Jason | Amministratore | EC2M 4RB London 250 Bishopsgate England | United Kingdom | British | 222279310001 | |||||||||
| NIXON, Stephen Paul | Amministratore | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 | England | British | 161010580001 | |||||||||
| PEARCE, Nigel | Amministratore | Willow Trees Hazelwood Lane CR5 3PF Chipstead Surrey | United Kingdom | British | 63084840002 | |||||||||
| ROGERS, Julian Edwin | Amministratore | 2 The Green RM15 6SD South Ockendon Nubbock House Essex England | England | British | 137180040001 | |||||||||
| ROULSTON, Steven James | Amministratore | Ground Floor, Business House F EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn, PO BOX 1000 Scotland | Scotland | British | 238205130001 | |||||||||
| SHEPHARD, Ian Maxwell | Amministratore | Hungerford House Pale Lane Winchfield RG27 8SW Hook Hampshire | British | 111421920002 | ||||||||||
| SLATTERY, Domhnal | Amministratore | 16 Ailesbury Road Ballsbridge IRISH Dublin 4 Ireland | Republic Of Ireland | Irish | 154385180001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PATALEX II PRODUCTIONS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Bank Leasing Limited | 06 apr 2016 | St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24/25 Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
PATALEX II PRODUCTIONS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Creato il 15 gen 2004 Consegnato il 27 gen 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right, title and interest in a) literary property, b) copyrights, c) music, d) ancillary rights, e) exploitation rights, f) accounts receivable. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of security assignment and charge | Creato il 15 gen 2004 Consegnato il 27 gen 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right, title and interest in 1) the entire copyright and all other rights in the film and in any music 2) the rights of copyright and other rights in all underlying material 3) all literary, property and ancillary rights, 4) all contracts and contract rights 5) all other rights and tangible and intangible properties. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0