PROSALT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPROSALT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02395362
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PROSALT LIMITED?

    • Ristoranti con licenza (56101) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova PROSALT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Montague Place, Quayside
    Chatham Maritime
    ME4 4QU Chatham
    Kent
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PROSALT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HARRY RAMSDEN'S LIMITED11 lug 200611 lug 2006
    HARRY RAMSDEN'S PUBLIC LIMITED COMPANY17 ott 198917 ott 1989
    ABLESERVE PUBLIC LIMITED COMPANY15 giu 198915 giu 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di PROSALT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per PROSALT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    24 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 ago 2022

    18 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 ago 2021

    18 pagineLIQ03

    Dichiarazione delle attività

    9 pagineLIQ02

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    5 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    5 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    5 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    5 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    5 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    5 pagineNDISC

    Indirizzo della sede legale modificato da Chapter House 33 London Road Reigate Surrey RH2 9HZ England a Montague Place, Quayside Chatham Maritime Chatham Kent ME4 4QU in data 08 set 2020

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 07 ago 2020

    LRESEX

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name01 apr 2020

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 01 apr 2020

    RES15

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 023953620017

    1 pagineMR05

    Iscrizione dell'ipoteca 023953620017, creata il 27 gen 2020

    59 pagineMR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr James Andrew Derrik Low il 23 dic 2019

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Hrfc Limited come persona con controllo significativo il 23 ago 2019

    3 paginePSC05

    Iscrizione dell'ipoteca 023953620016, creata il 14 ott 2019

    34 pagineMR01

    Bilancio redatto al 30 dic 2018

    36 pagineAA

    Nomina di Ms Lorraine Olga Mills come segretario in data 23 ago 2019

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Simon Nicholas D'cruz come amministratore in data 23 ago 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Thomas Edward Crowley come amministratore in data 23 ago 2019

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 1st Floor (North), Chancery House 53-64 Chancery Lane London WC2A 1QS England a Chapter House 33 London Road Reigate Surrey RH2 9HZ in data 06 set 2019

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di PROSALT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MILLS, Lorraine Olga
    Chatham Maritime
    ME4 4QU Chatham
    Montague Place, Quayside
    Kent
    Segretario
    Chatham Maritime
    ME4 4QU Chatham
    Montague Place, Quayside
    Kent
    262142460001
    LOW, James Andrew Derrik
    Chatham Maritime
    ME4 4QU Chatham
    Montague Place, Quayside
    Kent
    Amministratore
    Chatham Maritime
    ME4 4QU Chatham
    Montague Place, Quayside
    Kent
    EnglandBritish96486570001
    DAVIES, Jonathan Owen
    The Heights, Brooklands
    Weybridge
    KT13 0NY Surrey
    1
    United Kingdom
    Segretario
    The Heights, Brooklands
    Weybridge
    KT13 0NY Surrey
    1
    United Kingdom
    British105387490001
    MASON, Timothy Charles
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Segretario
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    British12314170002
    PALMER, Christopher Stephen
    5-9 Quality Court
    Chancery Lane
    WC2A 1HP London
    Quality House
    England
    Segretario
    5-9 Quality Court
    Chancery Lane
    WC2A 1HP London
    Quality House
    England
    204859550001
    TAYLOR, Richard Mann
    Underwood Grange
    Underwood Drive
    LS19 6LA Rawdon
    Leeds
    Segretario
    Underwood Grange
    Underwood Drive
    LS19 6LA Rawdon
    Leeds
    British11951620004
    TEIXEIRA, Joaquim Rocha
    Quality Court
    Quality Court
    WC2A 1HP London
    5-9
    United Kingdom
    Segretario
    Quality Court
    Quality Court
    WC2A 1HP London
    5-9
    United Kingdom
    Portuguese163068240001
    BARNES, Michael John
    28 Old Lane
    Bramhope
    LS16 9AZ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    28 Old Lane
    Bramhope
    LS16 9AZ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish11951630001
    BISS, Adele
    7 Elsworthy Road
    NW3 3DS London
    Amministratore
    7 Elsworthy Road
    NW3 3DS London
    EnglandBritish4429990001
    BRITTON, Barry Reginald
    115 Barkham Ride
    RG11 4EP Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    115 Barkham Ride
    RG11 4EP Wokingham
    Berkshire
    British11951640001
    BROOK, Joel David
    The Heights, Brooklands
    Weybridge
    KT13 0NY Surrey
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    The Heights, Brooklands
    Weybridge
    KT13 0NY Surrey
    1
    United Kingdom
    Great BritainBritish106107520001
    BUCKLEY, Peter Richard
    21 Larch Way
    GU14 0QN Farnborough
    Hampshire
    Amministratore
    21 Larch Way
    GU14 0QN Farnborough
    Hampshire
    British11951650001
    COLLINS, Miles Eric
    The Heights, Brooklands
    Weybridge
    KT13 0NY Surrey
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    The Heights, Brooklands
    Weybridge
    KT13 0NY Surrey
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish64044840005
    COPNER, Christopher Charles James
    Brackenwood
    Monks Walk
    SL5 9AZ Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Brackenwood
    Monks Walk
    SL5 9AZ Ascot
    Berkshire
    EnglandBritish33192300001
    COPNER, Christopher Charles James
    Brackenwood
    Monks Walk
    SL5 9AZ Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Brackenwood
    Monks Walk
    SL5 9AZ Ascot
    Berkshire
    EnglandBritish33192300001
    CRITOPH, Stephen Mark Anthony
    183 Gleneldon Road
    Streatham
    SW16 2BX London
    Amministratore
    183 Gleneldon Road
    Streatham
    SW16 2BX London
    British34372930002
    CROSS, Garry Anthony
    Bramber Cottage
    The Avenue
    SL6 8HG Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Bramber Cottage
    The Avenue
    SL6 8HG Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish44725730002
    CROWLEY, Thomas Edward
    33 London Road
    RH2 9HZ Reigate
    Chapter House
    Surrey
    England
    Amministratore
    33 London Road
    RH2 9HZ Reigate
    Chapter House
    Surrey
    England
    United KingdomBritish221043750001
    D'CRUZ, Simon Nicholas
    33 London Road
    RH2 9HZ Reigate
    Chapter House
    Surrey
    England
    Amministratore
    33 London Road
    RH2 9HZ Reigate
    Chapter House
    Surrey
    England
    United KingdomBritish242723610001
    DAVIES, Jonathan Owen
    The Heights, Brooklands
    Weybridge
    KT13 0NY Surrey
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    The Heights, Brooklands
    Weybridge
    KT13 0NY Surrey
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish105387490001
    EDWARDS, Graham
    53-64 Chancery Lane
    WC2A 1QS London
    1st Floor (North), Chancery House
    England
    Amministratore
    53-64 Chancery Lane
    WC2A 1QS London
    1st Floor (North), Chancery House
    England
    EnglandBritish168112440001
    FRANKLIN, William James
    53-64 Chancery Lane
    WC2A 1QS London
    1st Floor (North), Chancery House
    England
    Amministratore
    53-64 Chancery Lane
    WC2A 1QS London
    1st Floor (North), Chancery House
    England
    United KingdomBritish221044010001
    GAMMELL, Maurice
    68 Bell Lane
    Brookmans Park
    AL9 7AY Hatfield
    Hertfordshire
    Amministratore
    68 Bell Lane
    Brookmans Park
    AL9 7AY Hatfield
    Hertfordshire
    United KingdomBritish59425140002
    GLANCY, Michael John
    5-9 Quality Court
    Chancery Lane
    WC2A 1HP London
    Quality House
    England
    Amministratore
    5-9 Quality Court
    Chancery Lane
    WC2A 1HP London
    Quality House
    England
    EnglandBritish76479300001
    GREENALL, John Desmond Thomas
    Lagg House
    Dunure
    KA7 4LE Ayrshire
    Amministratore
    Lagg House
    Dunure
    KA7 4LE Ayrshire
    United KingdomBritish32756950001
    JONES, Nigel Richard Ifor
    123 Windingbrook Lane
    Collingtree Park
    NN4 0XN Northampton
    Amministratore
    123 Windingbrook Lane
    Collingtree Park
    NN4 0XN Northampton
    EnglandBritish69526300002
    KEATING, Anthony John
    The Heights, Brooklands
    Weybridge
    KT13 0NY Surrey
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    The Heights, Brooklands
    Weybridge
    KT13 0NY Surrey
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish114037820001
    KEEGANS, Peter
    8 Midhurst Avenue
    Muswell Hill
    N10 3EN London
    Amministratore
    8 Midhurst Avenue
    Muswell Hill
    N10 3EN London
    EnglandBritish90793120002
    KINLOCH, David Oliphant, Sir
    29 Walpole Street
    SW3 4QS London
    Amministratore
    29 Walpole Street
    SW3 4QS London
    British806370001
    KLAUBER, Peter Arthur
    Quality Court
    Quality Court
    WC2A 1HP London
    5-9
    United Kingdom
    Amministratore
    Quality Court
    Quality Court
    WC2A 1HP London
    5-9
    United Kingdom
    United KingdomBritish133070060001
    MACLEOD, Duncan James
    Monkredding House
    KA13 7QN Kilwinning
    Ayrshire
    Amministratore
    Monkredding House
    KA13 7QN Kilwinning
    Ayrshire
    ScotlandBritish291270001
    MERRYWEATHER, Carol Kathleen
    Quennells
    Old Lane Hatchford End
    KT11 1NE Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Quennells
    Old Lane Hatchford End
    KT11 1NE Cobham
    Surrey
    British11460660001
    MOSS, Timothy Charles
    5 Trowley Heights
    AL3 8DE Flamstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    5 Trowley Heights
    AL3 8DE Flamstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish47152260002
    PARR, Graham Thomas
    Bemersyde Holmefield Avenue
    Thornton
    FY5 2QR Cleveleys
    Lancashire
    Amministratore
    Bemersyde Holmefield Avenue
    Thornton
    FY5 2QR Cleveleys
    Lancashire
    British2262200001
    PRYNN, Robert James
    14 Tuffnells Way
    AL5 3HQ Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    14 Tuffnells Way
    AL5 3HQ Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish46311970003

    Chi sono le persone con controllo significativo di PROSALT LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    33 London Road
    RH2 9HZ Reigate
    Chapter House
    Surrey
    England
    06 apr 2016
    33 London Road
    RH2 9HZ Reigate
    Chapter House
    Surrey
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England & Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione07106656
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    PROSALT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 27 gen 2020
    Consegnato il 03 feb 2020
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 feb 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 01 apr 2020Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    A registered charge
    Creato il 14 ott 2019
    Consegnato il 14 ott 2019
    In corso
    Breve descrizione
    The quaterdeck complex. East beach. Bornemouth. Title number: DT228067.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Legal charge
    Creato il 05 feb 2013
    Consegnato il 09 feb 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The quarterdeck complex east beach bournemouth t/n DT228067 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable from any lease, all goodwill, the proceeds of any insurance, all fixtures and fittings not forming part of the property, all plant and machinery, all furniture equipment tools and other goods kept at the property.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 feb 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 30 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 05 feb 2013
    Consegnato il 09 feb 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 feb 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 30 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 18 lug 2011
    Consegnato il 27 lug 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £63,750.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The account and deposit fund.
    Persone aventi diritto
    • Stratford City Developments Limited as Trustee for and on Behalf of Stratford City Shopping Centre (No.1) Limited Partnership
    Transazioni
    • 27 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 apr 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Trust deed
    Creato il 23 lug 2010
    Consegnato il 04 ago 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all the interest in the deposit account and all money from time to time standing to the credit of or accruing to the deposit account see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Henderson UK Om (LP2) (Gp) Limited, Henderson UK Om (LP2) Limited
    Transazioni
    • 04 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 20 gen 2010
    Consegnato il 23 gen 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, the insurances and all proceeds of the insurances, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Boparan Ventures Limited
    Transazioni
    • 23 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 17 dic 2009
    Consegnato il 23 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mizuho Corporate Bank, LTD.
    Transazioni
    • 23 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 22 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession and charge to a principal deed
    Creato il 13 ott 2006
    Consegnato il 30 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on ant account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital and buildings. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mizuho Corporation Bank, LTD (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 30 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 17 giu 2002
    Consegnato il 03 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    10-12 marine parade,great yarmouth,norfolk; nk 82107; floating charge over. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Treasure World Limited
    Transazioni
    • 03 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 ago 1993
    Consegnato il 19 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property at white cross, guiseley, leeds, west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 11 ago 1993
    Consegnato il 13 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a or being land and buildings on the north east side of bradford road guiseley near leeds west yorkshire t/n wyk 458650.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 27 mar 1992
    Consegnato il 04 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 03 nov 1989
    Consegnato il 14 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under a loan agreement dated 3RD november 1989 and this charge
    Brevi particolari
    (See doc M183 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Chemical Bank
    Transazioni
    • 14 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 03 nov 1989
    Consegnato il 14 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from theco. And/or all or any of the other companies named therein to the chargee on anyaccount whatsoever under a loan agreement dated 3/1/89 and this charge.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. (See doc M183 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Chemical Bank
    Transazioni
    • 14 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 03 nov 1989
    Consegnato il 14 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under a loan agreement dated 3RD november 1989 and this charge
    Brevi particolari
    (See doc M192 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Chemical Bank
    Transazioni
    • 14 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 03 nov 1989
    Consegnato il 11 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of this charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery (see doc M363C for full details).
    Persone aventi diritto
    • Associated Fisheries PLC
    Transazioni
    • 11 nov 1989Registrazione di un'ipoteca

    PROSALT LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    07 ago 2020Inizio della liquidazione
    26 nov 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    James Hopkirk
    Montague Place Quayside
    ME4 4QU Chatham Maritime
    Kent
    Praticante
    Montague Place Quayside
    ME4 4QU Chatham Maritime
    Kent
    Andrew John Tate
    Montague Place Quayside
    ME4 4QU Chatham Maritime
    Kent
    Praticante
    Montague Place Quayside
    ME4 4QU Chatham Maritime
    Kent

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0