EX HAMPS DEAC LIMITED

EX HAMPS DEAC LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEX HAMPS DEAC LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02396152
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EX HAMPS DEAC LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova EX HAMPS DEAC LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Portland
    25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    West Sussex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EX HAMPS DEAC LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DEACON INSURANCE SERVICES LIMITED16 giu 198916 giu 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di EX HAMPS DEAC LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per EX HAMPS DEAC LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per EX HAMPS DEAC LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    17 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 nov 2014

    12 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Cessazione della carica di Ian Sutherland come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Third Floor Sunley House Bedford Park Croydon CR0 2AP* in data 14 nov 2013

    2 pagineAD01

    Nomina di Ian Ronald Sutherland come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ian Sutherland come amministratore

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2012 al 30 dic 2012

    2 pagineAA01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 dic 2013 al 30 dic 2013

    3 pagineAA01

    Cessazione della carica di Michael Ramsey come amministratore

    1 pagineTM01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed deacon insurance services LIMITED\certificate issued on 03/06/13
    2 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name03 giu 2013

    Risoluzione di cambio di nome della società il 01 mag 2013

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Nomina di Kevin Michael Withington come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 11 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital31 mag 2013

    Stato del capitale al 31 mag 2013

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di David Oliver come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Michael Francis Ramsey come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 11 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Ian Ronald Sutherland il 21 nov 2011

    2 pagineCH01

    Nomina di Ian Ronald Sutherland come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di EX HAMPS DEAC LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    YE, Christina Hong
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    Segretario
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    British133681410001
    WITHINGTON, Kevin Michael
    25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    Portland
    West Sussex
    Amministratore
    25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    Portland
    West Sussex
    EnglandEnglish178721390001
    ATHERTON, Andrew James
    Beauchamp
    Westover Road Milford On Sea
    SO41 0PW Lymington
    Hampshire
    Segretario
    Beauchamp
    Westover Road Milford On Sea
    SO41 0PW Lymington
    Hampshire
    British148270340001
    BALDWIN, Nicholas Charles
    80 Pilford Heath Road
    BH21 2ND Wimborne
    Dorset
    Segretario
    80 Pilford Heath Road
    BH21 2ND Wimborne
    Dorset
    British57752860001
    BELLIS, Juliet Mary Susan
    4 Grange Hill
    SE25 6SX London
    Segretario
    4 Grange Hill
    SE25 6SX London
    British69991160002
    DAVIS, Nigel Peter
    66 Redway Drive
    TW2 7NW Twickenham
    Middlesex
    Segretario
    66 Redway Drive
    TW2 7NW Twickenham
    Middlesex
    British93673010001
    DUCKER, Elaine
    9 Whincroft Drive
    Ferndown
    BH22 9LH Bournemouth
    Dorset
    Segretario
    9 Whincroft Drive
    Ferndown
    BH22 9LH Bournemouth
    Dorset
    British12261980001
    JOHNSON, Robin Simon
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    Segretario
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    British11498320001
    PALMER, Jeffrey Edward
    22 Catalina Close
    BH23 4JG Christchurch
    Dorset
    Segretario
    22 Catalina Close
    BH23 4JG Christchurch
    Dorset
    British82018950001
    ZEALE, Nadine Catherine
    12 The Brewery The Maltings
    Church Street
    TW18 4XH Staines
    Middlesex
    Segretario
    12 The Brewery The Maltings
    Church Street
    TW18 4XH Staines
    Middlesex
    British58435360001
    ZEALE, Richard John Alexander
    The Clive
    Croft Road,Neacroft
    BH23 8JS Christchurch
    Dorset
    Segretario
    The Clive
    Croft Road,Neacroft
    BH23 8JS Christchurch
    Dorset
    British22396670002
    ATHERTON, Andrew James
    Beauchamp
    Westover Road Milford On Sea
    SO41 0PW Lymington
    Hampshire
    Amministratore
    Beauchamp
    Westover Road Milford On Sea
    SO41 0PW Lymington
    Hampshire
    United KingdomBritish148270340001
    BALDWIN, Nicholas Charles
    80 Pilford Heath Road
    BH21 2ND Wimborne
    Dorset
    Amministratore
    80 Pilford Heath Road
    BH21 2ND Wimborne
    Dorset
    EnglandBritish57752860001
    BOYD, Iain Grant
    1 Highland View Close
    BH21 2QX Wimborne
    Dorset
    Amministratore
    1 Highland View Close
    BH21 2QX Wimborne
    Dorset
    British51260620002
    CRAN, John Andrew George
    19 Countess Gardens
    BH7 7RR Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    19 Countess Gardens
    BH7 7RR Bournemouth
    Dorset
    United KingdomBritish61456650002
    DAVIS, Nigel Peter
    6 Boundary Park
    KT13 9RR Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    6 Boundary Park
    KT13 9RR Weybridge
    Surrey
    EnglandBritish93673010002
    DAVIS, Paul Malcolm
    3 Church Close
    WD7 8BJ Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    3 Church Close
    WD7 8BJ Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish30526830004
    DUCKER, David George Bartholomew
    43 Groenhof Wezembeek
    Oppen
    FOREIGN 1970 Brussels
    Belgium
    Amministratore
    43 Groenhof Wezembeek
    Oppen
    FOREIGN 1970 Brussels
    Belgium
    British45548190004
    DUCKER, David George Bartholomew
    9 Whincroft Drive
    BH22 9LH Ferndon
    Bournemouth
    Amministratore
    9 Whincroft Drive
    BH22 9LH Ferndon
    Bournemouth
    British45548190002
    GOODING, Jonathan Michael
    13 Albany Street
    NW1 4DX London
    Amministratore
    13 Albany Street
    NW1 4DX London
    United KingdomBritish16684130002
    JENKINSON, Andrew Timothy
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    Amministratore
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    United KingdomBritish74069620002
    LIPMAN, Larry Glenn
    12 Park St James
    Prince Albert Road
    NW8 7LE St Johns Wood
    Amministratore
    12 Park St James
    Prince Albert Road
    NW8 7LE St Johns Wood
    EnglandBritish62622410007
    OLIVER, David Martin
    13 Kirklee Circus
    G12 0TW Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    13 Kirklee Circus
    G12 0TW Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish115764650001
    PALMER, Jeffrey Edward
    22 Catalina Close
    BH23 4JG Christchurch
    Dorset
    Amministratore
    22 Catalina Close
    BH23 4JG Christchurch
    Dorset
    EnglandBritish82018950001
    PEJNOVIC, Tomislav
    18 B Winchester Road
    GU32 3BL Petersfield
    Hampshire
    Amministratore
    18 B Winchester Road
    GU32 3BL Petersfield
    Hampshire
    United KingdomBritish204966490001
    PLUMB, Robert Henry Charles
    Uplands Cottage
    Whitchurch On Thames
    RG8 7HH Reading
    Amministratore
    Uplands Cottage
    Whitchurch On Thames
    RG8 7HH Reading
    EnglandBritish20686100001
    PURKISS, Julie
    1 Headinglea
    5 The Avenue
    BH13 6AA Poole
    Dorset
    Amministratore
    1 Headinglea
    5 The Avenue
    BH13 6AA Poole
    Dorset
    British99182850001
    RAMSEY, Michael Francis
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    Amministratore
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United KingdomBritish80310620002
    SMITH, James Robert Drummond
    11 Wellesley Road
    CR0 2NW Croydon
    Caley Limited Phoenix House
    Surrey
    Amministratore
    11 Wellesley Road
    CR0 2NW Croydon
    Caley Limited Phoenix House
    Surrey
    SpainBritish130443150001
    SUTHERLAND, Ian Ronald
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    Amministratore
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    United KingdomBritish163582690001
    SUTHERLAND, Ian Ronald
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    Amministratore
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    United KingdomBritish189660790001
    WILLIAMS, Neil Vaughan
    1 Richmond Place
    TN2 5JZ Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    1 Richmond Place
    TN2 5JZ Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish71561050001
    ZEALE, Richard John Alexander
    The Whittle
    24 Chewton Farm Road
    BH23 5QN Highcliffe
    Dorset
    Amministratore
    The Whittle
    24 Chewton Farm Road
    BH23 5QN Highcliffe
    Dorset
    British22396670003

    EX HAMPS DEAC LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental charge
    Creato il 02 gen 2008
    Consegnato il 08 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fifth floor offices, oxford house, oxford road, bournemouth t/no. DT64769.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (Formerly Known as the Governor and Company of the Bank of Scotland)(the Security Trustee)
    Transazioni
    • 08 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Group debenture
    Creato il 26 lug 2006
    Consegnato il 03 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Finance Parties(The Security Trustee)
    Transazioni
    • 03 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 mar 2002
    Consegnato il 14 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC, as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 14 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession relating to a composite guarantee and debenture dated 9TH november 1999 issued by the company
    Creato il 08 dic 1999
    Consegnato il 18 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness, liabilities and obligations due or to become due to the chargee in any manner whatsoever by any group company pursuant to the guarantee or otherwise
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 22 dic 1998
    Consegnato il 05 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities owing or incurred from the company to the chargee under or pursuant to the facilities agreement of even date and/or the debenture
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bhf-Bank Ag
    Transazioni
    • 05 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 12 set 1994
    Consegnato il 20 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC,
    Transazioni
    • 20 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    EX HAMPS DEAC LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    2
    DataTipo
    04 feb 2016Data di scioglimento
    06 nov 2013Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John Ariel
    Portland 25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    West Sussex
    Praticante
    Portland 25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    West Sussex
    Matthew Richard Meadley Wild
    3rd Floor One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Praticante
    3rd Floor One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0