MH VOKES AIR UK LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MH VOKES AIR UK LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02400211 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MH VOKES AIR UK LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova MH VOKES AIR UK LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Vokes Air Limited Farrington Road BB11 5SY Burnley Lancashire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MH VOKES AIR UK LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| VOKES AIR UK LIMITED | 26 ago 2008 | 26 ago 2008 |
| SPX VOKES LIMITED | 13 gen 2006 | 13 gen 2006 |
| MCLEOD RUSSEL INTERNATIONAL LIMITED | 03 ago 1998 | 03 ago 1998 |
| WHEWAY INTERNATIONAL LIMITED | 15 ago 1989 | 15 ago 1989 |
| VOWDIN LIMITED | 03 lug 1989 | 03 lug 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MH VOKES AIR UK LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2013 |
Quali sono le ultime deposizioni per MH VOKES AIR UK LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di George Henry Black come amministratore in data 23 feb 2017 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Varie Statemenbt of fact - name correction - mh vokes air uk LIMITED LIMITED - mh vokes air uk LIMITED | 1 pagine | MISC | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Ripristino per ordine del tribunale | 4 pagine | AC92 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed mann + hummel vokes air uk\certificate issued on 04/11/16 | pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Secondo deposito di AR01 precedentemente inviato alla Camera di Commercio aggiornato al 12 ott 2014 | 16 pagine | RP04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 ott 2014 con elenco completo degli azionisti | 15 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed vokes air uk LIMITED\certificate issued on 28/03/14 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Nomina di Steffen Schneider come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Thomas Blomqvist come segretario | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Thomas Blomqvist come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per George Henry Black il 19 ott 2013 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 ott 2013 con elenco completo degli azionisti | 14 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per George Henry Black il 19 ott 2012 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 ott 2012 con elenco completo degli azionisti | 14 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MH VOKES AIR UK LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHNEIDER, Steffen | Amministratore | C/O Vokes Air Limited Farrington Road BB11 5SY Burnley Lancashire | Germany | German | 185882550001 | |||||
| BLOMQVIST, Thomas | Segretario | Stureparken 11 4th Floor Stockholm 114 26 Sweden | Swedish | 132005410001 | ||||||
| SOHAL, Balkar | Segretario | 5 North Park NG18 4PA Mansfield Nottinghamshire | British | 122186580001 | ||||||
| M.R. SERVICES LIMITED | Segretario | C/O Vokes-Air Limited Farrington Road BB11 5SY Burnley Lancashire | 55567600012 | |||||||
| MR SERVICES LIMITED | Segretario | Suite 2, Hitching Court, Blacklands Way Abingdon Business Park OX14 1RG Abingdon Oxfordshire | 55567600003 | |||||||
| WHEWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | Suite Two Hitching Court Blacklands Way Abingdon Business Par OX14 1RG Abingdon Oxfordshire | 39955810002 | |||||||
| BLACK, George Henry | Amministratore | C/O Vokes Air Limited Farrington Road BB11 5SY Burnley Lancashire | Uk | British | 151256750002 | |||||
| BLOMQVIST, Thomas | Amministratore | Stureparken 11 4th Floor Stockholm 114 26 Sweden | Swedish | 132005410001 | ||||||
| BOSWELL, Brian Peter | Amministratore | Garden Cottage Hawford House Hawford WR3 7SQ Worcester Worcestershire | British | 52804120001 | ||||||
| BRICKER, Ross Benjamin | Amministratore | 2401 Pioneer Road JI 60201 Evanston Illinios Ji 60201 Usa | Canadian | 105172080001 | ||||||
| COLE, Ian Robert | Amministratore | 4 Knarsdale Close Lakeside DY5 3RF Brierley Hill West Midlands | British | 42980510001 | ||||||
| COTTON, Richard John | Amministratore | 148 Myton Road CV34 6PR Warwick | England | British | 45397090001 | |||||
| DOHERTY, James Patrick | Amministratore | 950 S E 82nd Street Road Ocala Florida 34480 | Irish | 105328280001 | ||||||
| FERRARI, Fabio | Amministratore | Lot Chirouzanches 05240 La Salle Les Alps France | French | 132005120001 | ||||||
| FITCHFORD, Andrew Michael John | Amministratore | The Old House The Green B94 5AJ Tanworth In Arden Warwickshire | British | 99141670001 | ||||||
| FROY, Robert Anthony Douglas | Amministratore | 171 Defoe House Barbican EC2Y 8ND London | British | 35373020004 | ||||||
| GOPSILL, Michael Clement | Amministratore | Wood Cottage Norton Road Iverley Stourbridge West Midlands | British | 32481900001 | ||||||
| HAZLEHURST, Ian James | Amministratore | Malvern Park Farm Widney Manor Road B91 3JG Solihull West Midlands | British | 43476760001 | ||||||
| HODGSON, Geoffrey Phillip | Amministratore | Canterbury Cottage Fox Pond Lane LE2 4RY Great Glen Leicestershire | British | 107483910001 | ||||||
| HUMPHREYS, Paul Justin | Amministratore | The Wendy House 3 Elf Meadow Poulton GL7 5HQ Cirencester Gloucestershire | British | 33223550001 | ||||||
| JONES, Alan Martin | Amministratore | 5 Firsway Wightwick WV6 8BJ Wolverhampton West Midlands | British | 47891670001 | ||||||
| KEARNEY, Christopher James | Amministratore | 14675 Rudolph Dadey Drive Charlotte Nc2827749456 Usa | American | 85114770001 | ||||||
| LADENBERGER, Daniel Timothy | Amministratore | 24 Portland Place Saint Louis Missouri 63108 Usa | American | 110032170001 | ||||||
| LEEK, James Anthony | Amministratore | 8 Atherton Drive Wimbledon SW19 5LB London | British | 11293430001 | ||||||
| LILLY, Kevin Lucius | Amministratore | 13515 Ballantyne Corporate Place NC 28277 Charlotte North Carolina Nc 28277 Usa | United States | American | 110636870001 | |||||
| MCGOWAN, John Peter | Amministratore | Lantern House Abbotswood WR11 4NS Evesham Worcestershire | British | 62509010002 | ||||||
| O'LEARY, Patrick Joseph | Amministratore | 6524 Chipstead Lane 28277 Charlotte North Carolina Nc 28277 Usa | United States | American | 61807850002 | |||||
| PETERSON, Andris | Amministratore | Redlands Lower Town WR3 7RY Claines Worcestershire | American | 31642760001 | ||||||
| RADISCH, Klaus Ingo | Amministratore | Weidendstrasse 36 Sonsbeck 47665 Germany | Germany | German | 121578410001 | |||||
| REILLY, Michael Andrew | Amministratore | 2007 Channelstone Way NC 28104 Matthews Nc 28104 Usa | United States | American | 103500870001 | |||||
| RENZI, Anthony Andrew | Amministratore | 5101 Sw 60th Street Road Ocala Florida 34474 Usa | American | 121578380001 | ||||||
| WALKER, Craig Allen | Amministratore | Bruhnstrasse 2a FOREIGN 40225 Dusseldorf Germany | Usa | 109340980001 | ||||||
| WINOWIECKI, Ronald Lee | Amministratore | 8707 Calumet Farms Drive Wexham Nc 28173 Usa | American | 95572300001 |
MH VOKES AIR UK LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental deed | Creato il 22 feb 1993 Consegnato il 09 mar 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the company and/or any other obligors named therein to the chargee under the security trust deed,the financing agreement and the security documents as defined in this deed | |
Brevi particolari All moneys,dividends and interest in respect of the shares. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Share pledge agreement | Creato il 18 gen 1993 Consegnato il 02 feb 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or wheway secretarial services limited to the chargee under the terms of the pledge agreement (the "secured liabilities as defined) | |
Brevi particolari By way of pledge 599 shares in appareils electriques et electoniques belges N.V. (see form 395 ref M93). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage of shares | Creato il 18 gen 1993 Consegnato il 02 feb 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the beneficiaries (as defined), under the facilities documents and/or the security documents (as defined) or any of them | |
Brevi particolari All the companys right title and interest in and to and under the presentshares the acquired shares and the new rights the deposited shares (see form 395REF M95). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Pledge agreement | Creato il 18 gen 1993 Consegnato il 02 feb 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee dated 22/12/92 | |
Brevi particolari The pledged shares divends cash instruments chattel paper and other rights property or proceeds.see form 395 for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Pledge agreement | Creato il 18 gen 1993 Consegnato il 02 feb 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a security trust deed dated 22/12/92 | |
Brevi particolari 25,994 shares in climavent-cadi S.a and any other shares or seurities.see form 395 for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 22 dic 1992 Consegnato il 07 gen 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the beneficiaries (as defined) under the financing agreement dated 22ND december 1992 and/or the security documents(as defined) or any of them | |
Brevi particolari See doc ref M79 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0