MH VOKES AIR UK LIMITED

MH VOKES AIR UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMH VOKES AIR UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02400211
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MH VOKES AIR UK LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MH VOKES AIR UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Vokes Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MH VOKES AIR UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    VOKES AIR UK LIMITED26 ago 200826 ago 2008
    SPX VOKES LIMITED13 gen 200613 gen 2006
    MCLEOD RUSSEL INTERNATIONAL LIMITED03 ago 199803 ago 1998
    WHEWAY INTERNATIONAL LIMITED15 ago 198915 ago 1989
    VOWDIN LIMITED03 lug 198903 lug 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di MH VOKES AIR UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per MH VOKES AIR UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di George Henry Black come amministratore in data 23 feb 2017

    2 pagineTM01

    Varie

    Statemenbt of fact - name correction - mh vokes air uk LIMITED LIMITED - mh vokes air uk LIMITED
    1 pagineMISC

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 10 ago 2016

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Ripristino per ordine del tribunale

    4 pagineAC92

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed mann + hummel vokes air uk\certificate issued on 04/11/16
    pagineCERTNM
    Note
    DataNota
    09 nov 2016Clarification changed its name on 04/11/2016 to MH VOKES AIR UK LIMITED and not the name MH VOKES AIR UK LIMITED LIMITED as incorrectly shown on the face of the certificate of change of name issued on that date.

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Secondo deposito di AR01 precedentemente inviato alla Camera di Commercio aggiornato al 12 ott 2014

    16 pagineRP04

    Bilancio annuale redatto al 12 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 ott 2014

    Stato del capitale al 21 ott 2014

    • Capitale: GBP 10,000,001
    SH01
    Note
    DataNota
    11 nov 2014Clarification A second filed AR01 was registered on 11/11/2014

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    16 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed vokes air uk LIMITED\certificate issued on 28/03/14
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name28 mar 2014

    Risoluzione di cambio di nome della società il 04 mar 2014

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Nomina di Steffen Schneider come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Thomas Blomqvist come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Thomas Blomqvist come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    16 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per George Henry Black il 19 ott 2013

    3 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 12 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 ott 2013

    Stato del capitale al 18 ott 2013

    • Capitale: GBP 10,000,001
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per George Henry Black il 19 ott 2012

    3 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 12 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di MH VOKES AIR UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SCHNEIDER, Steffen
    C/O Vokes Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    Amministratore
    C/O Vokes Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    GermanyGerman185882550001
    BLOMQVIST, Thomas
    Stureparken 11 4th Floor
    Stockholm 114 26
    Sweden
    Segretario
    Stureparken 11 4th Floor
    Stockholm 114 26
    Sweden
    Swedish132005410001
    SOHAL, Balkar
    5 North Park
    NG18 4PA Mansfield
    Nottinghamshire
    Segretario
    5 North Park
    NG18 4PA Mansfield
    Nottinghamshire
    British122186580001
    M.R. SERVICES LIMITED
    C/O Vokes-Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    Segretario
    C/O Vokes-Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    55567600012
    MR SERVICES LIMITED
    Suite 2, Hitching Court, Blacklands Way
    Abingdon Business Park
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    Segretario
    Suite 2, Hitching Court, Blacklands Way
    Abingdon Business Park
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    55567600003
    WHEWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Suite Two Hitching Court
    Blacklands Way Abingdon Business Par
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    Segretario
    Suite Two Hitching Court
    Blacklands Way Abingdon Business Par
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    39955810002
    BLACK, George Henry
    C/O Vokes Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    Amministratore
    C/O Vokes Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    UkBritish151256750002
    BLOMQVIST, Thomas
    Stureparken 11 4th Floor
    Stockholm 114 26
    Sweden
    Amministratore
    Stureparken 11 4th Floor
    Stockholm 114 26
    Sweden
    Swedish132005410001
    BOSWELL, Brian Peter
    Garden Cottage Hawford House
    Hawford
    WR3 7SQ Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Garden Cottage Hawford House
    Hawford
    WR3 7SQ Worcester
    Worcestershire
    British52804120001
    BRICKER, Ross Benjamin
    2401 Pioneer Road
    JI 60201 Evanston
    Illinios Ji 60201
    Usa
    Amministratore
    2401 Pioneer Road
    JI 60201 Evanston
    Illinios Ji 60201
    Usa
    Canadian105172080001
    COLE, Ian Robert
    4 Knarsdale Close
    Lakeside
    DY5 3RF Brierley Hill
    West Midlands
    Amministratore
    4 Knarsdale Close
    Lakeside
    DY5 3RF Brierley Hill
    West Midlands
    British42980510001
    COTTON, Richard John
    148 Myton Road
    CV34 6PR Warwick
    Amministratore
    148 Myton Road
    CV34 6PR Warwick
    EnglandBritish45397090001
    DOHERTY, James Patrick
    950 S E 82nd Street Road
    Ocala
    Florida 34480
    Amministratore
    950 S E 82nd Street Road
    Ocala
    Florida 34480
    Irish105328280001
    FERRARI, Fabio
    Lot Chirouzanches 05240
    La Salle Les Alps
    France
    Amministratore
    Lot Chirouzanches 05240
    La Salle Les Alps
    France
    French132005120001
    FITCHFORD, Andrew Michael John
    The Old House
    The Green
    B94 5AJ Tanworth In Arden
    Warwickshire
    Amministratore
    The Old House
    The Green
    B94 5AJ Tanworth In Arden
    Warwickshire
    British99141670001
    FROY, Robert Anthony Douglas
    171 Defoe House
    Barbican
    EC2Y 8ND London
    Amministratore
    171 Defoe House
    Barbican
    EC2Y 8ND London
    British35373020004
    GOPSILL, Michael Clement
    Wood Cottage
    Norton Road Iverley
    Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    Wood Cottage
    Norton Road Iverley
    Stourbridge
    West Midlands
    British32481900001
    HAZLEHURST, Ian James
    Malvern Park Farm
    Widney Manor Road
    B91 3JG Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Malvern Park Farm
    Widney Manor Road
    B91 3JG Solihull
    West Midlands
    British43476760001
    HODGSON, Geoffrey Phillip
    Canterbury Cottage
    Fox Pond Lane
    LE2 4RY Great Glen
    Leicestershire
    Amministratore
    Canterbury Cottage
    Fox Pond Lane
    LE2 4RY Great Glen
    Leicestershire
    British107483910001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    The Wendy House 3 Elf Meadow
    Poulton
    GL7 5HQ Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    The Wendy House 3 Elf Meadow
    Poulton
    GL7 5HQ Cirencester
    Gloucestershire
    British33223550001
    JONES, Alan Martin
    5 Firsway
    Wightwick
    WV6 8BJ Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    5 Firsway
    Wightwick
    WV6 8BJ Wolverhampton
    West Midlands
    British47891670001
    KEARNEY, Christopher James
    14675 Rudolph Dadey Drive
    Charlotte
    Nc2827749456
    Usa
    Amministratore
    14675 Rudolph Dadey Drive
    Charlotte
    Nc2827749456
    Usa
    American85114770001
    LADENBERGER, Daniel Timothy
    24 Portland Place
    Saint Louis
    Missouri 63108
    Usa
    Amministratore
    24 Portland Place
    Saint Louis
    Missouri 63108
    Usa
    American110032170001
    LEEK, James Anthony
    8 Atherton Drive
    Wimbledon
    SW19 5LB London
    Amministratore
    8 Atherton Drive
    Wimbledon
    SW19 5LB London
    British11293430001
    LILLY, Kevin Lucius
    13515 Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    Amministratore
    13515 Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    United StatesAmerican110636870001
    MCGOWAN, John Peter
    Lantern House
    Abbotswood
    WR11 4NS Evesham
    Worcestershire
    Amministratore
    Lantern House
    Abbotswood
    WR11 4NS Evesham
    Worcestershire
    British62509010002
    O'LEARY, Patrick Joseph
    6524 Chipstead Lane
    28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    Amministratore
    6524 Chipstead Lane
    28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    United StatesAmerican61807850002
    PETERSON, Andris
    Redlands
    Lower Town
    WR3 7RY Claines
    Worcestershire
    Amministratore
    Redlands
    Lower Town
    WR3 7RY Claines
    Worcestershire
    American31642760001
    RADISCH, Klaus Ingo
    Weidendstrasse 36
    Sonsbeck 47665
    Germany
    Amministratore
    Weidendstrasse 36
    Sonsbeck 47665
    Germany
    GermanyGerman121578410001
    REILLY, Michael Andrew
    2007 Channelstone Way
    NC 28104 Matthews
    Nc 28104
    Usa
    Amministratore
    2007 Channelstone Way
    NC 28104 Matthews
    Nc 28104
    Usa
    United StatesAmerican103500870001
    RENZI, Anthony Andrew
    5101 Sw 60th Street Road
    Ocala
    Florida 34474
    Usa
    Amministratore
    5101 Sw 60th Street Road
    Ocala
    Florida 34474
    Usa
    American121578380001
    WALKER, Craig Allen
    Bruhnstrasse 2a
    FOREIGN 40225 Dusseldorf
    Germany
    Amministratore
    Bruhnstrasse 2a
    FOREIGN 40225 Dusseldorf
    Germany
    Usa109340980001
    WINOWIECKI, Ronald Lee
    8707 Calumet Farms Drive
    Wexham
    Nc 28173
    Usa
    Amministratore
    8707 Calumet Farms Drive
    Wexham
    Nc 28173
    Usa
    American95572300001

    MH VOKES AIR UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental deed
    Creato il 22 feb 1993
    Consegnato il 09 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company and/or any other obligors named therein to the chargee under the security trust deed,the financing agreement and the security documents as defined in this deed
    Brevi particolari
    All moneys,dividends and interest in respect of the shares.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Plcas Security Trustee
    Transazioni
    • 09 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share pledge agreement
    Creato il 18 gen 1993
    Consegnato il 02 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or wheway secretarial services limited to the chargee under the terms of the pledge agreement (the "secured liabilities as defined)
    Brevi particolari
    By way of pledge 599 shares in appareils electriques et electoniques belges N.V. (see form 395 ref M93).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Plcthe "Pledgees" (As Defined)
    Transazioni
    • 02 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of shares
    Creato il 18 gen 1993
    Consegnato il 02 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the beneficiaries (as defined), under the facilities documents and/or the security documents (as defined) or any of them
    Brevi particolari
    All the companys right title and interest in and to and under the presentshares the acquired shares and the new rights the deposited shares (see form 395REF M95).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 02 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Pledge agreement
    Creato il 18 gen 1993
    Consegnato il 02 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee dated 22/12/92
    Brevi particolari
    The pledged shares divends cash instruments chattel paper and other rights property or proceeds.see form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Plcas Security Trustee
    Transazioni
    • 02 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Pledge agreement
    Creato il 18 gen 1993
    Consegnato il 02 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a security trust deed dated 22/12/92
    Brevi particolari
    25,994 shares in climavent-cadi S.a and any other shares or seurities.see form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Plcas Security Trustee
    Transazioni
    • 02 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 22 dic 1992
    Consegnato il 07 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the beneficiaries (as defined) under the financing agreement dated 22ND december 1992 and/or the security documents(as defined) or any of them
    Brevi particolari
    See doc ref M79 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Plcas "Security Trustee" for the Beneficiaries (Asdefined)
    Transazioni
    • 07 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0