EMPIRE REALISATIONS (8) LIMITED

EMPIRE REALISATIONS (8) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEMPIRE REALISATIONS (8) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02402775
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EMPIRE REALISATIONS (8) LIMITED?

    • (6420) /

    Dove si trova EMPIRE REALISATIONS (8) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EMPIRE REALISATIONS (8) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EUROTEL CORPORATE SERVICES LIMITED27 gen 200327 gen 2003
    DIGITAL EXCHANGE COMMUNICATIONS LIMITED03 ago 198903 ago 1989
    STEEPLE-LITE LIMITED10 lug 198910 lug 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di EMPIRE REALISATIONS (8) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per EMPIRE REALISATIONS (8) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 02 feb 2011

    24 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 02 ago 2010

    17 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 02 feb 2010

    23 pagine2.24B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    69 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    6 pagine2.16B

    legacy

    1 pagine287

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed eurotel corporate services LIMITED\certificate issued on 06/08/09
    2 pagineCERTNM

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    6 pagineAA

    legacy

    12 pagine395

    legacy

    7 pagine395

    legacy

    12 pagine155(6)a

    legacy

    13 pagine155(6)a

    Chi sono gli amministratori di EMPIRE REALISATIONS (8) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILLIAMS, Nicholas John
    South Parade
    YO23 1BF York
    7
    North Yorkshire
    Segretario
    South Parade
    YO23 1BF York
    7
    North Yorkshire
    British130606790001
    WILLIAMS, Nicholas John
    South Parade
    YO23 1BF York
    7
    North Yorkshire
    Amministratore
    South Parade
    YO23 1BF York
    7
    North Yorkshire
    EnglandBritish130606790001
    EDWARDS, Peter Gerald
    Hafod Abley Farm
    Ffrith
    LL11 5HY Wrexham
    Flintshire
    Segretario
    Hafod Abley Farm
    Ffrith
    LL11 5HY Wrexham
    Flintshire
    British100704790001
    HUDSON, Paul Andrew
    12 The Beeches
    LS22 6ST Wetherby
    West Yorkshire
    Segretario
    12 The Beeches
    LS22 6ST Wetherby
    West Yorkshire
    British63303690001
    REX, Anthony Peter
    33 The Hawthorns
    Outwood
    WF1 3TL Wakefield
    West Yorkshire
    Segretario
    33 The Hawthorns
    Outwood
    WF1 3TL Wakefield
    West Yorkshire
    British16766990002
    ALLINGAN, Philip Hugh
    4 Thornley Lane
    Grotton
    OL4 5RP Oldham
    Amministratore
    4 Thornley Lane
    Grotton
    OL4 5RP Oldham
    United KingdomBritish40011560001
    BROWN, Stuart Thomas
    4 Cawdor Street
    Stockton Heath
    WA4 6LU Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    4 Cawdor Street
    Stockton Heath
    WA4 6LU Warrington
    Cheshire
    British27929390001
    EDWARDS, Peter Gerald
    Hafod Abley Farm
    Ffrith
    LL11 5HY Wrexham
    Flintshire
    Amministratore
    Hafod Abley Farm
    Ffrith
    LL11 5HY Wrexham
    Flintshire
    British100704790001
    HUDSON, Paul Andrew
    12 The Beeches
    LS22 6ST Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    12 The Beeches
    LS22 6ST Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish63303690001
    HULSE, Roy Oswald
    Beech Cotage Wrexham Road
    Pulford
    CH4 9DG Chester
    Cheshire
    Amministratore
    Beech Cotage Wrexham Road
    Pulford
    CH4 9DG Chester
    Cheshire
    British19897900001
    JAGUSZ, Christopher
    16 Hampden Hill
    HP9 1BP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    16 Hampden Hill
    HP9 1BP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish116115660001
    LUTENER, Keith Douglas
    Crawstone Laithe
    Dog Lane,Greetland
    HX4 8PW Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    Crawstone Laithe
    Dog Lane,Greetland
    HX4 8PW Halifax
    West Yorkshire
    British25040190003
    LUTENER, Robert Stephen
    Cobblestones
    Bar Lane Ripponden
    HX6 4EX Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    Cobblestones
    Bar Lane Ripponden
    HX6 4EX Halifax
    West Yorkshire
    British19921500001
    MACKAREL, Peter Phillip
    9 Elizabeth Crescent
    Queens Park
    CH4 7AY Chester
    Cheshire
    Amministratore
    9 Elizabeth Crescent
    Queens Park
    CH4 7AY Chester
    Cheshire
    British31510220001
    OWEN, David Gwynn
    Field House
    Awre
    GL14 1EH Newnham On Severn
    Gloucestershire
    Amministratore
    Field House
    Awre
    GL14 1EH Newnham On Severn
    Gloucestershire
    EnglandBritish78109850006
    REX, Anthony Peter
    33 The Hawthorns
    Outwood
    WF1 3TL Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    33 The Hawthorns
    Outwood
    WF1 3TL Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish16766990002
    RODMELL, Jonathan Hudson
    Halifax Old Road
    Hipperholme
    HX3 8PJ Halifax
    Woodlands
    West Yorkshire
    Amministratore
    Halifax Old Road
    Hipperholme
    HX3 8PJ Halifax
    Woodlands
    West Yorkshire
    EnglandBritish130914930001
    RUSSELL, Nigel Peter
    The Wold Lynch Hill Park
    RG28 7NF Whitchurch
    Hampshire
    Amministratore
    The Wold Lynch Hill Park
    RG28 7NF Whitchurch
    Hampshire
    United KingdomBritish20892640001

    EMPIRE REALISATIONS (8) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Master guarantee and security agreement
    Creato il 20 nov 2007
    Consegnato il 29 nov 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become from belle bidco limited and/or each guarantor to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Inflexion Private Equity Partners LLP (Security Trustee)
    Transazioni
    • 29 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    All monies debenture
    Creato il 20 nov 2007
    Consegnato il 28 nov 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 28 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 08 ott 2001
    Consegnato il 26 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the agreement of even date or this charge
    Brevi particolari
    F/H land and buildings k/a vale house whitehouse vale development park runcorn cheshire t/no: CH427632. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nec Infrontia UK Limited
    Transazioni
    • 26 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 01 lug 1998
    Consegnato il 09 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a vale house aston lane north white house vale runcorn cheshire t/n CH268480. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 28 ago 1997
    Consegnato il 01 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 28 ago 1997
    Consegnato il 01 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a aston house (now known as vale house) whitehouse vale development park runcorn cheshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 mag 1997
    Consegnato il 30 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Trustees of Digital Exchange Communications Limited Pension Scheme
    Transazioni
    • 30 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Book debts debenture
    Creato il 04 ago 1995
    Consegnato il 04 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book debts and other debts of the company both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 04 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 23 mag 1995
    Consegnato il 27 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease dated 23RD may 1995
    Brevi particolari
    The sum of £15,000 in an interest bearing account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bass Developments Limited
    Transazioni
    • 27 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 28 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 10 nov 1989
    Consegnato il 14 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a lease of even date and this deed
    Brevi particolari
    The interest of the company in all money from time to time standing to the credit of a deposit account in the joint names of frank nominees limited and digital exchange communications limited with national westminster bank PLC (see form 395 for details).
    Persone aventi diritto
    • Frank Nominees Limited
    Transazioni
    • 14 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 03 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 set 1989
    Consegnato il 18 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 18 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 13 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 ago 1989
    Consegnato il 30 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Peter Gerald Edwards
    Transazioni
    • 30 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 02 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 ago 1989
    Consegnato il 30 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Peter Philip Mackarel
    Transazioni
    • 30 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 02 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    EMPIRE REALISATIONS (8) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    03 ago 2009Inizio dell'amministrazione
    02 feb 2011Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Daniel Francis Butters
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Ian Brown
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Praticante
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0