ADVANCED ELECTRONIC TECHNOLOGIES LTD.

ADVANCED ELECTRONIC TECHNOLOGIES LTD.

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàADVANCED ELECTRONIC TECHNOLOGIES LTD.
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02405910
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ADVANCED ELECTRONIC TECHNOLOGIES LTD.?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ADVANCED ELECTRONIC TECHNOLOGIES LTD.?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Elektron Technology Plc Broers Building
    21 J J Thomson Avenue
    CB3 0FA Cambridge
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di ADVANCED ELECTRONIC TECHNOLOGIES LTD.?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per ADVANCED ELECTRONIC TECHNOLOGIES LTD.?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 26 ott 2012

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium reduced 24/10/2012
    RES13

    Cessazione della carica di Noah Felix Kalman Franklin come amministratore in data 23 ott 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 03 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 gen 2011

    11 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Elektron Plc, Melville Court Spilsby Road Harold Hill Romford RM3 8SB in data 01 nov 2011

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Noah Felix Kalman Franklin come amministratore in data 31 ago 2011

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Geoffrey Spink come amministratore in data 31 ago 2011

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Geoffrey Spink come amministratore in data 31 ago 2011

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 03 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    3 pagineAUD

    Nomina di Mr Martin Leslie Reeves come segretario

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Geoffrey Spink come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Christopher Leigh come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christopher Leigh come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 gen 2010

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Chi sono gli amministratori di ADVANCED ELECTRONIC TECHNOLOGIES LTD.?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    REEVES, Martin Leslie
    Gryfe Road
    PA11 3AL Bridge Of Weir
    Glendale
    Renfrewshire
    Scotland
    Segretario
    Gryfe Road
    PA11 3AL Bridge Of Weir
    Glendale
    Renfrewshire
    Scotland
    155657690001
    DALEY, Keith Anthony
    76 Stapleton Hall Road
    N4 4QA London
    Amministratore
    76 Stapleton Hall Road
    N4 4QA London
    United KingdomBritish1693740001
    ADAMS, Leslie Richard
    11 Farthing Drive
    SG6 2TR Letchworth
    Hertfordshire
    Segretario
    11 Farthing Drive
    SG6 2TR Letchworth
    Hertfordshire
    British10707280001
    ALLY, Bibi Rahima
    68 Ruskin Road
    SM5 3DH Carshalton
    Surrey
    Segretario
    68 Ruskin Road
    SM5 3DH Carshalton
    Surrey
    British38963210001
    HUGHES, David Roy
    Amberley 27 Barnfield Road
    Livermead
    TQ2 6TA Torquay
    Devon
    Segretario
    Amberley 27 Barnfield Road
    Livermead
    TQ2 6TA Torquay
    Devon
    British22082760001
    LEIGH, Christopher Michael
    Arranmoor 11 Hillwood Close
    Hutton Mount
    CM13 2PE Brentwood
    Essex
    Segretario
    Arranmoor 11 Hillwood Close
    Hutton Mount
    CM13 2PE Brentwood
    Essex
    British24955980002
    SIMS, Patrick Robert
    Barleycombe House
    Avonwick
    TQ10 9EX South Brent
    Devon
    Segretario
    Barleycombe House
    Avonwick
    TQ10 9EX South Brent
    Devon
    British67888670001
    SUTTON, Robin Ashley
    37 Larksmead Way
    TQ12 6FE Ogwell
    Devon
    Segretario
    37 Larksmead Way
    TQ12 6FE Ogwell
    Devon
    British55438020003
    ADAMS, Leslie Richard
    11 Farthing Drive
    SG6 2TR Letchworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    11 Farthing Drive
    SG6 2TR Letchworth
    Hertfordshire
    British10707280001
    BYE, George Ian
    Robins Gate
    Lymington Road Milford On Sea
    SO41 0QL Lymington
    Hampshire
    Amministratore
    Robins Gate
    Lymington Road Milford On Sea
    SO41 0QL Lymington
    Hampshire
    British67426570004
    CHERRY, John Stanley
    3 Thirlmere Close
    CM77 7UL Braintree
    Essex
    Amministratore
    3 Thirlmere Close
    CM77 7UL Braintree
    Essex
    British87560020001
    FRANKLIN, Noah Felix Kalman
    Broers Building
    21 J J Thomson Avenue
    CB3 0FA Cambridge
    C/O Elektron Technology Plc
    United Kingdom
    Amministratore
    Broers Building
    21 J J Thomson Avenue
    CB3 0FA Cambridge
    C/O Elektron Technology Plc
    United Kingdom
    EnglandBritish53608960001
    GIRLING, Adrian Charles Nigel
    Greentiles Ewehurst Lane
    Speldhurst
    TN3 0JX Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    Greentiles Ewehurst Lane
    Speldhurst
    TN3 0JX Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish25932750001
    HUGHES, David Roy
    Amberley 27 Barnfield Road
    Livermead
    TQ2 6TA Torquay
    Devon
    Amministratore
    Amberley 27 Barnfield Road
    Livermead
    TQ2 6TA Torquay
    Devon
    British22082760001
    JOHNSON, Martin Kenneth
    49 Rous Road
    IG9 6BW Buckhurst Hill
    Essex
    Amministratore
    49 Rous Road
    IG9 6BW Buckhurst Hill
    Essex
    British62065450001
    LEE, Robert George
    4 Long Croft
    CM24 8JD Stansted
    Essex
    Amministratore
    4 Long Croft
    CM24 8JD Stansted
    Essex
    EnglandBritish50795100001
    LEIGH, Christopher Michael
    Arranmoor 11 Hillwood Close
    Hutton Mount
    CM13 2PE Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Arranmoor 11 Hillwood Close
    Hutton Mount
    CM13 2PE Brentwood
    Essex
    EnglandBritish24955980002
    MEARS, William Thomas
    Murphys Lane
    Print Road
    IRISH Dundalk
    Co Louth
    Ireland
    Amministratore
    Murphys Lane
    Print Road
    IRISH Dundalk
    Co Louth
    Ireland
    British10707300001
    POINTER, Halina Sylvestra
    Cherrymead Frogshall Lane
    Haultwick
    SG11 1JH Ware
    Hertfordshire
    Amministratore
    Cherrymead Frogshall Lane
    Haultwick
    SG11 1JH Ware
    Hertfordshire
    British42954490001
    POINTER, Ian Roger
    Cherrymead
    Frogs Hall Lane Haultwick
    SG11 1JH Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Cherrymead
    Frogs Hall Lane Haultwick
    SG11 1JH Hertford
    Hertfordshire
    British10707290001
    SIMS, Patrick Robert
    Barleycombe House
    Avonwick
    TQ10 9EX South Brent
    Devon
    Amministratore
    Barleycombe House
    Avonwick
    TQ10 9EX South Brent
    Devon
    British67888670001
    SPINK, Geoffrey
    Lakeside Business Park
    Swan Lane
    GU47 9DN Sandhurst
    5
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lakeside Business Park
    Swan Lane
    GU47 9DN Sandhurst
    5
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish84940730001
    SUTTON, Robin Ashley
    37 Larksmead Way
    TQ12 6FE Ogwell
    Devon
    Amministratore
    37 Larksmead Way
    TQ12 6FE Ogwell
    Devon
    British55438020003
    TINSON, John
    29 Leyland Avenue
    AL1 2BD St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    29 Leyland Avenue
    AL1 2BD St Albans
    Hertfordshire
    British44014540001
    VAUGHAN, Nigel Leslie Richard
    45 Oakenbrow
    Sway
    SO41 6BY Lymington
    Hants
    Amministratore
    45 Oakenbrow
    Sway
    SO41 6BY Lymington
    Hants
    British22082810001
    WINDLE, Paul Raymond
    3 Glevum Close
    AL3 4JN St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    3 Glevum Close
    AL3 4JN St Albans
    Hertfordshire
    British27969130001

    ADVANCED ELECTRONIC TECHNOLOGIES LTD. ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating charge
    Creato il 11 dic 1996
    Consegnato il 31 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 31 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 23 set 1991
    Consegnato il 14 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 16 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0