NITRIDING SERVICES LIMITED

NITRIDING SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNITRIDING SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02406009
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NITRIDING SERVICES LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova NITRIDING SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    39-43 Bilton Way
    Luton
    LU1 1UU Bedfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NITRIDING SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THERMO CHEMICAL TREATMENTS LIMITED07 nov 198907 nov 1989
    INGLEBY (429) LIMITED19 lug 198919 lug 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di NITRIDING SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per NITRIDING SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 08 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 gen 2011

    Stato del capitale al 24 gen 2011

    • Capitale: GBP 544,400.02
    SH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Miss Denise Osborn come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Nicholas Duncalf come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Nicholas Duncalf come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stephen Dell come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2008

    5 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a
    Note
    DataNota
    18 mar 2021Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 18/03/2021 under section 1088 of the Companies Act 2006

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2007

    12 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2006

    5 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2005

    5 pagineAA

    legacy

    8 pagine363s

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2004

    5 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2003

    5 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di NITRIDING SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OSBORN, Denise
    39-43 Bilton Way
    Luton
    LU1 1UU Bedfordshire
    Segretario
    39-43 Bilton Way
    Luton
    LU1 1UU Bedfordshire
    146124880001
    JAEGER, Oliver
    Mettmann
    Germany
    Amministratore
    Mettmann
    Germany
    GermanyGerman138189510001
    ASHTON, David John
    Oak Cottage
    27 Church Road, Lilleshall
    TF10 9HE Newport
    Salop
    Segretario
    Oak Cottage
    27 Church Road, Lilleshall
    TF10 9HE Newport
    Salop
    British24459630003
    DUNCALF, Nicholas John
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Segretario
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British148208420001
    KNIGHTS, John Ivan
    The Haven 4 Berberry Drive
    MK45 5ER Flitton
    Bedfordshire
    Segretario
    The Haven 4 Berberry Drive
    MK45 5ER Flitton
    Bedfordshire
    British126545670001
    POLLAK, David Arthur
    40 The Gardens
    WD17 3DW Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    40 The Gardens
    WD17 3DW Watford
    Hertfordshire
    British64234590001
    ASHTON, David John
    Oak Cottage
    27 Church Road, Lilleshall
    TF10 9HE Newport
    Salop
    Amministratore
    Oak Cottage
    27 Church Road, Lilleshall
    TF10 9HE Newport
    Salop
    EnglandBritish24459630003
    BACON, Nicholas Andrew William
    Shaftesbury House Clover Hill
    Old Warwick Road, Lapworth
    B94 6JY Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Shaftesbury House Clover Hill
    Old Warwick Road, Lapworth
    B94 6JY Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish159081540001
    BAUMANN, Christopher John
    31 Old Slade Lane
    SL0 9DY Richings Park
    Buckinghamshire
    Amministratore
    31 Old Slade Lane
    SL0 9DY Richings Park
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish102220130001
    BUSTER, Richard Geoffrey
    58 Mount Road
    Tettenhall Wood
    WV6 8HQ Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    58 Mount Road
    Tettenhall Wood
    WV6 8HQ Wolverhampton
    West Midlands
    EnglandBritish4325580001
    DELL, Stephen John
    55 Bucklow Gardens
    WA13 9RN Lymm
    Cheshire
    Amministratore
    55 Bucklow Gardens
    WA13 9RN Lymm
    Cheshire
    British124021740001
    DUNCALF, Nicholas John
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Amministratore
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishBritish148208420001
    EALES, Darryl Charles
    7 Sycamore Drive
    Hollywood
    B47 5QX Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    7 Sycamore Drive
    Hollywood
    B47 5QX Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritish2886080001
    HEAP, William John
    Alameda Keepers Lane
    Codsall
    WV8 2DP Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    Alameda Keepers Lane
    Codsall
    WV8 2DP Wolverhampton
    West Midlands
    British24459640001
    KNIGHTS, John Ivan
    The Haven 4 Berberry Drive
    MK45 5ER Flitton
    Bedfordshire
    Amministratore
    The Haven 4 Berberry Drive
    MK45 5ER Flitton
    Bedfordshire
    British126545670001
    LEEK, Peter William
    Tintagel 119 Broad Lane
    WV3 9BP Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    Tintagel 119 Broad Lane
    WV3 9BP Wolverhampton
    West Midlands
    British10939100001
    LEEKE, Graham Maurice
    The Grove
    Tachbrook Mallory
    CV33 9QE Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    The Grove
    Tachbrook Mallory
    CV33 9QE Leamington Spa
    Warwickshire
    British29510450001
    ROBINSON, Kevin
    34 Winster Avenue
    Dorridge
    B93 8ST Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    34 Winster Avenue
    Dorridge
    B93 8ST Solihull
    West Midlands
    British61267640001
    SHARP, Keith
    Harewood House
    4 Spa Crescent
    TF5 0DH Admaston
    Shropshire
    Amministratore
    Harewood House
    4 Spa Crescent
    TF5 0DH Admaston
    Shropshire
    EnglandBritish77395770001
    STAINES, Anthony Martin, Doctor
    10 Carmichael Close
    WS14 9YW Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    10 Carmichael Close
    WS14 9YW Lichfield
    Staffordshire
    British57218330001

    NITRIDING SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 24 feb 1999
    Consegnato il 27 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Transazioni
    • 27 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of rental deposit
    Creato il 06 nov 1997
    Consegnato il 08 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £40,000 together with interest thereon due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The deposit of £40,000.
    Persone aventi diritto
    • Lilden Properties Limited
    Transazioni
    • 08 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 26 set 1995
    Consegnato il 17 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 15 february 1994 or under the chattel mortgage
    Brevi particolari
    Nitrex gas nitriding system with serial no.be-5078 including various constituant parts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 17 gen 1991
    Consegnato il 30 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Factory and land at hortonwood 40 telford shropshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Development Capital Limited
    Transazioni
    • 30 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 28 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 06 dic 1990
    Consegnato il 12 dic 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The items as set out on the attached schedule (see form 395 for full details) the mortgage contains a covenant not to sell, transfer demise, let on hire or otherwise part with possession of the goods comprised in the mortgage charge, pledge lien or other encumbrance to arise in said goods.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 12 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 19 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 dic 1990
    Consegnato il 12 dic 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H land and buildings comprising three acres on thereabouts at hortonwood, telford shropshire. The legal charge contains a covenant by the company not to sell encumber or otherwise deal with the equity of redemption in the property without the previous consent in writing of the chargee.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 12 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 21 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 22 nov 1990
    Consegnato il 29 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the f/h property known as factory and land at hortonwood 40, telford shropshire goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 29 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 30 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 mar 1990
    Consegnato il 04 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    78400 all monies due or to become due from the company to the chargees under the terms of the chargee.
    Brevi particolari
    See form 395 document M539 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • John Townleyas Trustees for the Tct Pension Fund
    • Ann Douglas
    • Richard Geoffrey Buster
    • David John Ashton
    Transazioni
    • 04 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 28 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 19 mar 1990
    Consegnato il 27 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rights benefits, title and interest in and to a contract dated 19/3/90 and an agreement dated 19/3/90 in the works to be carried out at hortonwood 40 telford shropshire the company's rights, title and interest (if any) in hortonwood 40 telford shropshire described in an agreement dated 19/3/90. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 30 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 19 mar 1990
    Consegnato il 23 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 23 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 30 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 19 mar 1990
    Consegnato il 23 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Development Capital Limited
    Transazioni
    • 23 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 28 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0