G & G TRAVEL LIMITED

G & G TRAVEL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàG & G TRAVEL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02406571
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di G & G TRAVEL LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova G & G TRAVEL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Stagecoach Services Limited One Stockport Exchange
    20 Railway Road
    SK1 3SW Stockport
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di G & G TRAVEL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SCOOPGLEN LIMITED20 lug 198920 lug 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di G & G TRAVEL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al02 mag 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per G & G TRAVEL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 02 mag 2020

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2019

    4 pagineAA

    Nomina di Karen Rosaleen Robbins come amministratore in data 31 mag 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Colin Brown come amministratore in data 31 mag 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Bruce Dingwall come amministratore in data 31 mag 2019

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2018

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2017

    4 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Daw Bank Stockport Cheshire SK3 0DU a C/O Stagecoach Services Limited One Stockport Exchange 20 Railway Road Stockport SK1 3SW in data 16 nov 2017

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2016

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 mag 2016

    Stato del capitale al 04 mag 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2015

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 mag 2015

    Stato del capitale al 05 mag 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2014

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 mag 2014

    Stato del capitale al 06 mag 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael John Vaux il 20 mar 2014

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Michael John Vaux come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2013

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di G & G TRAVEL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VAUX, Michael John
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Segretario
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    British137383880001
    DINGWALL, Bruce Maxwell
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish185252790001
    ROBBINS, Karen Rosaleen
    Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    8
    Derbyshire
    England
    Amministratore
    Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    8
    Derbyshire
    England
    EnglandBritish73518280001
    VAUX, Michael John
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish137383880003
    DAVISON, Jeremy Robert
    34 Trendlewood Park
    BS16 1TE Bristol
    Segretario
    34 Trendlewood Park
    BS16 1TE Bristol
    British65096740001
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Segretario
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    British70283550001
    HEMMING, Christopher Thomas
    Bankura Stoke Road
    Bishops Cleeve
    GL52 7RT Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    Bankura Stoke Road
    Bishops Cleeve
    GL52 7RT Cheltenham
    Gloucestershire
    British17902220001
    STAITE, John Frederick
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    Segretario
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    British45931770001
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Segretario
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    British54184420002
    BROWN, Colin
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish85970020003
    CARTER, Alex Paul
    The Hayes
    Stubbs Road Everdon
    NN11 3BN Daventry
    Northamptonshire
    Amministratore
    The Hayes
    Stubbs Road Everdon
    NN11 3BN Daventry
    Northamptonshire
    British41601830001
    COCHRANE, Keith Robertson
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    Amministratore
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    British47574960002
    COX, Anthony Geoffrey
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    British70180950001
    COX, Brian John
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    Amministratore
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    EnglandBritish1436830002
    DAVISON, Jeremy Robert
    34 Trendlewood Park
    BS16 1TE Bristol
    Amministratore
    34 Trendlewood Park
    BS16 1TE Bristol
    British65096740001
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Amministratore
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    EnglandBritish70283550001
    GLOAG, Ann Heron
    Kinfauns Castle
    PH2 7JZ Perth
    Perthshire
    Amministratore
    Kinfauns Castle
    PH2 7JZ Perth
    Perthshire
    ScotlandBritish141120003
    GRIFFITHS, Martin Andrew
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Amministratore
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    ScotlandBritish61722690002
    HILDITCH, Christopher Graham
    51 Hildene Ampleforth Drive
    The Meadows
    ST17 4TE Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    51 Hildene Ampleforth Drive
    The Meadows
    ST17 4TE Stafford
    Staffordshire
    British10417870001
    HINKLEY, William Barry
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    Amministratore
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    EnglandBritish2268190002
    HODGKINS, John Christopher
    10 Piers Close
    CV34 5HS Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    10 Piers Close
    CV34 5HS Warwick
    Warwickshire
    British15371120001
    KINSKI, Michael John
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    United KingdomBritish58643710001
    LYON, Inglis
    102 Lewis Road
    Radford Semele
    CV31 1UP Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    102 Lewis Road
    Radford Semele
    CV31 1UP Leamington Spa
    Warwickshire
    British72280120001
    RHYS-DAVIES, Mark Iorwedd
    10 Evesham Road
    GL52 2AB Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    10 Evesham Road
    GL52 2AB Cheltenham
    Gloucestershire
    British5652350001
    ROBBINS, Karen Rosaleen
    8 Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    Derbyshire
    Amministratore
    8 Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    Derbyshire
    EnglandBritish73518280001
    SOUTER, Brian
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    Amministratore
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    British1436810001
    STAITE, John Frederick
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    Amministratore
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    United KingdomBritish45931770001
    THOMAS, Mark Richard
    The Quarry House
    Upper Lynch Road France Lynch
    GL6 8LZ Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    The Quarry House
    Upper Lynch Road France Lynch
    GL6 8LZ Stroud
    Gloucestershire
    British28914510001
    THOMAS, Norrie Russell
    Catherine Cottage Silver Street
    Chalford Hill
    GL6 8ES Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    Catherine Cottage Silver Street
    Chalford Hill
    GL6 8ES Stroud
    Gloucestershire
    EnglandBritish1447710001
    WARNEFORD, Leslie Brian
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish49771140004

    Chi sono le persone con controllo significativo di G & G TRAVEL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleUnited Kingdom (Scotland)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazioneSc176671
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    G & G TRAVEL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 28 apr 1992
    Consegnato il 11 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 feb 1991
    Consegnato il 07 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facility letter 1ST february 1991, this debenture or any other finance document (as defined).
    Brevi particolari
    (See form 395. ref M224 for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited.
    Transazioni
    • 07 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 21 dic 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0