MIDLAND NEWS LIMITED

MIDLAND NEWS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMIDLAND NEWS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02406962
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MIDLAND NEWS LIMITED?

    • Leasing finanziario (64910) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova MIDLAND NEWS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    51/53 Queen Street
    Wolverhampton
    WV1 1ES West Midlands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MIDLAND NEWS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PIPMAY LIMITED21 lug 198921 lug 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di MIDLAND NEWS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al02 gen 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per MIDLAND NEWS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 02 gen 2016

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 mag 2016

    Stato del capitale al 17 mag 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Edward Alexander Graham il 06 mag 2016

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Stephen James Brown come segretario in data 06 mag 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Thomas William Graham come amministratore in data 06 mag 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Edward Alexander Graham come amministratore in data 06 mag 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Thomas William Graham come amministratore in data 06 mag 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Thomas William Graham come amministratore in data 06 mag 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Phillip Antony Inman come amministratore in data 06 mag 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David James Hughes come segretario in data 30 apr 2016

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di David James Hughes come amministratore in data 30 apr 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 27 dic 2014

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 mag 2015

    Stato del capitale al 19 mag 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Cessazione della carica di Malcolm Gray Douglas Graham come amministratore in data 23 mar 2015

    2 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 dic 2013

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 mag 2014

    Stato del capitale al 19 mag 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 29 dic 2012

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Approval of documents 02/07/2012
    RES13

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    14 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di MIDLAND NEWS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BROWN, Stephen James
    51-53 Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    Express & Star Ltd
    England
    Segretario
    51-53 Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    Express & Star Ltd
    England
    207939560001
    EVERS, Graham William
    51/53 Queen Street
    Wolverhampton
    WV1 1ES West Midlands
    Amministratore
    51/53 Queen Street
    Wolverhampton
    WV1 1ES West Midlands
    EnglandBritish1518570006
    GRAHAM, Edward Alexander
    51 - 53 Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    Express & Star Ltd
    England
    Amministratore
    51 - 53 Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    Express & Star Ltd
    England
    EnglandBritish174816060001
    GRAHAM, Eric Alan
    51/53 Queen Street
    Wolverhampton
    WV1 1ES West Midlands
    Amministratore
    51/53 Queen Street
    Wolverhampton
    WV1 1ES West Midlands
    FranceBritish1625250001
    GRAHAM, Thomas William
    51 - 53 Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    Express & Star Ltd
    England
    Amministratore
    51 - 53 Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    Express & Star Ltd
    England
    EnglandBritish198341640001
    INMAN, Phillip Anthony
    51 - 53 Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    Express & Star Ltd
    England
    Amministratore
    51 - 53 Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    Express & Star Ltd
    England
    EnglandBritish245426860001
    EVERS, Graham William
    Green Leys
    Stourbridge Road
    WV5 9BN Wombourne
    South Staffs
    Segretario
    Green Leys
    Stourbridge Road
    WV5 9BN Wombourne
    South Staffs
    British1518570002
    EVERS, Graham William
    Green Leys
    Stourbridge Road
    WV5 9BN Wombourne
    South Staffs
    Segretario
    Green Leys
    Stourbridge Road
    WV5 9BN Wombourne
    South Staffs
    British1518570002
    HUGHES, David James
    51/53 Queen Street
    Wolverhampton
    WV1 1ES West Midlands
    Segretario
    51/53 Queen Street
    Wolverhampton
    WV1 1ES West Midlands
    British35966530003
    MILLARD, Andrew Clive
    44 Cranmere Avenue
    WV6 8TS Wolverhampton
    Segretario
    44 Cranmere Avenue
    WV6 8TS Wolverhampton
    British63339300001
    ALLATT, John David
    Lerida
    Haughton Lane
    TF11 8HW Shifnal
    Shropshire
    Amministratore
    Lerida
    Haughton Lane
    TF11 8HW Shifnal
    Shropshire
    British1518610001
    GRAHAM, Malcolm Gray Douglas
    51/53 Queen Street
    Wolverhampton
    WV1 1ES West Midlands
    Amministratore
    51/53 Queen Street
    Wolverhampton
    WV1 1ES West Midlands
    United KingdomBritish1518600001
    GRAHAM, Thomas William
    51 - 53 Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    Express & Star Ltd
    England
    Amministratore
    51 - 53 Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    Express & Star Ltd
    England
    EnglandBritish207897700001
    HUGHES, David James
    51/53 Queen Street
    Wolverhampton
    WV1 1ES West Midlands
    Amministratore
    51/53 Queen Street
    Wolverhampton
    WV1 1ES West Midlands
    EnglandBritish35966530003
    JACKSON, Brian Albert
    Tangalooma Caernarvon Lane
    Withington
    SY4 4PX Shrewsbury
    Salop
    Amministratore
    Tangalooma Caernarvon Lane
    Withington
    SY4 4PX Shrewsbury
    Salop
    British13597090001
    LIGGINS, Paul Warren
    8 Butt Lane
    Allesley
    CV5 9EU Coventry
    West Midlands
    Amministratore
    8 Butt Lane
    Allesley
    CV5 9EU Coventry
    West Midlands
    British1622280001
    PARKER, John
    2 Vale Street
    Upper Gornal
    DY3 3XD Dudley
    West Midlands
    Amministratore
    2 Vale Street
    Upper Gornal
    DY3 3XD Dudley
    West Midlands
    British125618570001
    PARKER, Keith John
    94 Wrottesley Road
    Tettenhall
    WV6 8SJ Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    94 Wrottesley Road
    Tettenhall
    WV6 8SJ Wolverhampton
    West Midlands
    British56986510001
    WARD, Michael Arnold Charles
    18 Queens Road
    WS5 3NF Walsall
    West Midlands
    Amministratore
    18 Queens Road
    WS5 3NF Walsall
    West Midlands
    British32360190001
    WITTS, Anthony Martin
    Apartment 4 Sandringham Court
    Pengwern Road
    SY3 8LL Shrewsbury
    Shropshire
    Amministratore
    Apartment 4 Sandringham Court
    Pengwern Road
    SY3 8LL Shrewsbury
    Shropshire
    British37615340002

    Chi sono le persone con controllo significativo di MIDLAND NEWS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Claverley Group Limited
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    England
    06 apr 2016
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUk Companies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House Register Of Companies For England & Wales
    Numero di registrazione05213110
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    MIDLAND NEWS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 23 dic 2009
    Consegnato il 04 gen 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Limited debenture
    Creato il 31 ago 2007
    Consegnato il 12 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Trustees of the Star Executive Pension Scheme and Includes the Trustees Thereof for Thetime Being
    Transazioni
    • 12 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Limited debenture
    Creato il 31 ago 2007
    Consegnato il 12 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Trustees of the Star Group Pension Scheme and Includes the Trustee Thereof for the Timebeing
    Transazioni
    • 12 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 ago 2007
    Consegnato il 06 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0