KENWOOD MARKS LIMITED

KENWOOD MARKS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKENWOOD MARKS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02407362
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KENWOOD MARKS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova KENWOOD MARKS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KENWOOD MARKS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SCOOPMARK LIMITED24 lug 198924 lug 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di KENWOOD MARKS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per KENWOOD MARKS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 1 Kenwood Business Park New Lane Havant Hampshire PO9 2NH in data 25 ott 2012

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 12 ott 2012

    LRESSP

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 lug 2012

    Stato del capitale al 24 lug 2012

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 20 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Nomina di Mr Richard Kevin Kirk come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Ian Fry come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 20 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Thierry Hubert il 20 lug 2010

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    6 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Ian Richard Fry il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    Risoluzioni

    Resolutions
    7 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di KENWOOD MARKS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KIRK, Richard Kevin
    Snow Hill
    EC1A 2AY London
    6
    Segretario
    Snow Hill
    EC1A 2AY London
    6
    153464160001
    HUBERT, Thierry
    Avenue Des Dames Blanches
    Brussels
    135
    1150
    Belgium
    Amministratore
    Avenue Des Dames Blanches
    Brussels
    135
    1150
    Belgium
    BelgiumBelgian134423120001
    EASTWOOD, Martin
    27 Broadbent Close
    Rownhams
    SO16 8LQ Southampton
    Hampshire
    Segretario
    27 Broadbent Close
    Rownhams
    SO16 8LQ Southampton
    Hampshire
    British7620670002
    FRY, Ian Richard
    Unit 1 Kenwood Business Park
    New Lane
    PO9 2NH Havant
    Hampshire
    Segretario
    Unit 1 Kenwood Business Park
    New Lane
    PO9 2NH Havant
    Hampshire
    British80540100002
    HATTON, Thomas David Michael
    65 Crossbush Road
    PO22 7LY Felpham
    West Sussex
    Segretario
    65 Crossbush Road
    PO22 7LY Felpham
    West Sussex
    British728380004
    YOUNG, Mark Osborne
    2 Oyster Quay
    Port Solent
    PO6 4TE Portsmouth
    Hampshire
    Segretario
    2 Oyster Quay
    Port Solent
    PO6 4TE Portsmouth
    Hampshire
    British71930040003
    BEECH, Timothy Paul
    Bramble Copse
    Crow Hill
    BH24 3DE Ringwood
    Hampshire
    Amministratore
    Bramble Copse
    Crow Hill
    BH24 3DE Ringwood
    Hampshire
    British67101230002
    BERALDO, Stefano
    Via N Sauro 41 Preganzial
    Treviso
    31032
    Italy
    Amministratore
    Via N Sauro 41 Preganzial
    Treviso
    31032
    Italy
    British102137840001
    CREVOISIER, Philippe Henri Leon
    Via Di Montalbano
    FOREIGN 50136 Florence
    Italy
    Amministratore
    Via Di Montalbano
    FOREIGN 50136 Florence
    Italy
    French78153300001
    DE' LONGHI, Fabio
    20 Via Chiesa
    Lughignano Di Casale Sul Sile
    Tv
    Italy
    Amministratore
    20 Via Chiesa
    Lughignano Di Casale Sul Sile
    Tv
    Italy
    ItalyItalian76342830002
    DOUGLAS, Antony John
    26 Leydene Park Hyden Farm Lane
    East Meon
    GU32 1HF Petersfield
    Hampshire
    Amministratore
    26 Leydene Park Hyden Farm Lane
    East Meon
    GU32 1HF Petersfield
    Hampshire
    British49116420003
    FORMELA, Adam Jonathan
    102 Braywick Road
    SL6 1DJ Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    102 Braywick Road
    SL6 1DJ Maidenhead
    Berkshire
    British55564910001
    FRIDLINGTON, George Edward
    Bramblefields Martins Lane
    Birdham
    PO20 7AU Chichester
    West Sussex
    Amministratore
    Bramblefields Martins Lane
    Birdham
    PO20 7AU Chichester
    West Sussex
    British5508410001
    GORDON, Colin James
    The Clock House
    St Margarets
    SG12 8EQ Ware
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Clock House
    St Margarets
    SG12 8EQ Ware
    Hertfordshire
    EnglandBritish122332620001
    HOTSTON, Peter
    Denns Farm
    East Harting
    GU31 5NA Petersfield
    Hampshire
    Amministratore
    Denns Farm
    East Harting
    GU31 5NA Petersfield
    Hampshire
    British5508420005
    LAPHAM, Michael John
    5 Carmarthen Avenue
    PO6 2AG Portsmouth
    Hampshire
    Amministratore
    5 Carmarthen Avenue
    PO6 2AG Portsmouth
    Hampshire
    British87745630001
    MELO, Dario
    Via Orsoni 18
    FOREIGN Bologna
    40135
    Italy
    Amministratore
    Via Orsoni 18
    FOREIGN Bologna
    40135
    Italy
    Italian101168790001
    MOLONEY, Kieran Joseph
    15 The Mount
    Caversham
    RG4 7RU Reading
    Berkshire
    Amministratore
    15 The Mount
    Caversham
    RG4 7RU Reading
    Berkshire
    British8616170001
    PARKER, Timothy Charles
    The Old Vicarage Vicarage Lane
    Hambledon
    PO7 4RP Waterlooville
    Hampshire
    Amministratore
    The Old Vicarage Vicarage Lane
    Hambledon
    PO7 4RP Waterlooville
    Hampshire
    British47724620001
    TAYLOR, Peter Robert
    34 Bowes Hill
    PO9 6BP Rowlands Castle
    Hampshire
    Amministratore
    34 Bowes Hill
    PO9 6BP Rowlands Castle
    Hampshire
    British5508440001
    WICKENDEN, Graham Roland
    Oerley Hall
    Llanforda
    SY10 7HH Oswestry
    Shropshire
    Amministratore
    Oerley Hall
    Llanforda
    SY10 7HH Oswestry
    Shropshire
    United KingdomBritish23906480002
    YOUNG, Mark Osborne
    2 Oyster Quay
    Port Solent
    PO6 4TE Portsmouth
    Hampshire
    Amministratore
    2 Oyster Quay
    Port Solent
    PO6 4TE Portsmouth
    Hampshire
    British71930040003

    KENWOOD MARKS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 27 giu 1997
    Consegnato il 03 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from kenwood appliances PLC, kenwood international limited, kenwood marks limited, kenwood limited, kenwood appliances (hk) limited and tricom industrial company limited to the chargee under the terms of this debenture
    Brevi particolari
    Fixed charge over book debts and goodwill, floating charge over all the undertaking and assets whatsoever and wheresoever both present and future, f/h land and buildings lying to the east of heathfield road freshwater isle of wight t/n-HP43215; f/h land lying to the east of new lane, havant hampshire t/n-HP495824; f/h land and buildings on the north side of eastern road havant hampshire t/n-HP2677 (for the other property charged see form 395).. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC (As Security Agent for Itself and 9 Banks as Set Out in the Debenture)
    Transazioni
    • 03 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Senior grarantee and debenture
    Creato il 07 set 1989
    Consegnato il 25 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee agent and security trustee for the securied parnets under the terms of the chargee the senior loan agreement of even date and the security documents
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 05 giu 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mezzanine guarantee and debenture
    Creato il 07 set 1989
    Consegnato il 25 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee a s agent and security trustee for the secured parkes under the terms of the charge the magzanine loan agreement of even date and the security documents.
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 05 giu 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    KENWOOD MARKS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    05 lug 2013Data di scioglimento
    12 ott 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Michael David Rollings
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Praticante
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Vivienne Elizabeth Oliver
    6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Praticante
    6 Snow Hill
    EC1A 2AY London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0