WINDELECTRIC LIMITED
Panoramica
| Nome della società | WINDELECTRIC LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02407377 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di WINDELECTRIC LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova WINDELECTRIC LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Monkton Reach Monkton Hill SN15 1EE Chippenham Wiltshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di WINDELECTRIC LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per WINDELECTRIC LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Juliet Sarah Loveday Davenport il 17 lug 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mr Nigel Tranah come segretario in data 16 apr 2012 | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Angela Newman come segretario in data 16 apr 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mar 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di John Sellers come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 3 pagine | SH20 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mar 2011 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Miss Angela Newman come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Hopkins come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2009 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mar 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Jonathan George Fairchild il 11 mar 2010 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter Dixon Edwards il 01 gen 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Juliet Sarah Loveday Davenport il 01 gen 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mr Mark Hopkins come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan Fairchild come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2008 | 22 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2007 | 17 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di WINDELECTRIC LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANAH, Nigel | Segretario | Monkton Reach Monkton Hill SN15 1EE Chippenham Wiltshire | 168397380001 | |||||||
| DAVENPORT, Juliet Sarah Lovedy | Amministratore | Monkton Reach Monkton Hill SN15 1EE Chippenham Wiltshire | United Kingdom | British | 70686370003 | |||||
| EDWARDS, Martin John | Amministratore | The Bungalow Deli PL33 9BZ Delabole Cornwall | England | British | 81829090001 | |||||
| EDWARDS, Peter Dixon | Amministratore | Deli PL33 9BZ Delabole N Cornwall | United Kingdom | British | 6723810001 | |||||
| EDWARDS, Jeremy Paul | Segretario | Kempson House PO BOX 570,Camomile Street EC3A 7AN London | British | 27850190002 | ||||||
| FAIRCHILD, Jonathan George | Segretario | Monkton Reach Monkton Hill SN15 1EE Chippenham Wiltshire | British | 91228100003 | ||||||
| HOPKINS, Mark | Segretario | Monkton Reach Monkton Hill SN15 1EE Chippenham Wiltshire | 149634170001 | |||||||
| NEWMAN, Angela | Segretario | Monkton Reach Monkton Hill SN15 1EE Chippenham Wiltshire | 155558130001 | |||||||
| OVALSEC LIMITED | Segretario nominato | 2 Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol | 900002570001 | |||||||
| FISK, Nicholas John Spencer | Amministratore | 10 Edwards Meadow SN8 1UD Marlborough Wiltshire | British | 36028930001 | ||||||
| LOPEZ-CACICEDO, Carlos, Dr | Amministratore | 362 Marlborough Road SN3 1NP Swindon | Spanish | 14105600002 | ||||||
| MASOOD, Tariq | Amministratore | 22 Ashgrove Avenue Ashley Down BS7 9LJ Bristol | United Kingdom | British | 46049660002 | |||||
| MASOOD, Tariq | Amministratore | 46 Sherbourne Avenue Bradley Stoke BS12 8BB Bristol Avon | British | 46049660001 | ||||||
| MASTERMAN, Richard Thomas | Amministratore | Thuborough House Sutcombe EX22 7QE Holsworthy Devon | British | 3437250001 | ||||||
| SEED, John Junior | Amministratore | Highfield House North Road BA2 6HW Bath Bath & North East Somerset | British | 8670120001 | ||||||
| SELLERS, John Ernest | Amministratore | Rodway Hill Manor Manor Road Mangotsfield BS16 9LG Bristol | United Kingdom | British | 47428650001 | |||||
| SWARBRICK, Gerard Joseph | Amministratore | 39 Upper Cranbrook Road Westbury Park BS6 7UR Bristol | England | British | 27850210001 | |||||
| SWINDELLS, Brian James | Amministratore | 7 Hollymead Lane Stoke Bishop BS9 1LN Bristol | British | 32426200002 | ||||||
| SAXON FINANCE CORPORATION LIMITED | Amministratore | Thuborough House Sutcombe EX22 7QE Holsworthy Devon | 59178080001 |
WINDELECTRIC LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Performance guarantee and warranty guarantee assignment | Creato il 14 nov 1991 Consegnato il 22 nov 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 4/11/91 and security documents issued pursuant thereto | |
Brevi particolari All the companys rights title and interest in and to a performance guarantee dated 12/11/91. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Contract consultant's appointment and warranty and maintenance agreement charge | Creato il 04 nov 1991 Consegnato il 20 nov 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from thecompany to the chargee under the terms of the facility letter dated 4TH NOVEMBER1991 and this deed | |
Brevi particolari All the benefit of the contract agreement,the agreement,andthe warranty and maintenance agreement all dated 19TH july 1991 see form 395 ref M792C for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Contract charge | Creato il 04 nov 1991 Consegnato il 15 nov 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter of even date and the charge | |
Brevi particolari All the benefit of an agreement dated 9/8/91. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over deposit account | Creato il 04 nov 1991 Consegnato il 13 nov 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All the company's right, title and interest-bearing deposit account number 66457901 at natwest investment bank limited designated cnw re: windelectric limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over power purchase agreement | Creato il 04 nov 1991 Consegnato il 13 nov 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to natwest investment bank limited or to any receiver appointed by the bank under the terms of the facility letter and/or mortgage debenture, both of even date, and/or this charge | |
Brevi particolari All sums payable by non-fossil purchasing agency limited to the company under the power purchase agreement dated 12TH september 1990 and made beyween the company (1) non-fossil purchasing agency limited (2) and south western electricity PLC (3). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 04 nov 1991 Consegnato il 13 nov 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of legal mortgage all those areas of leasehold land and premises at deli farm development delabole cornwall and/or the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0