WINDELECTRIC LIMITED

WINDELECTRIC LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWINDELECTRIC LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02407377
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WINDELECTRIC LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova WINDELECTRIC LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di WINDELECTRIC LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per WINDELECTRIC LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Juliet Sarah Loveday Davenport il 17 lug 2012

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Nigel Tranah come segretario in data 16 apr 2012

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Angela Newman come segretario in data 16 apr 2012

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 mar 2012

    Stato del capitale al 05 mar 2012

    • Capitale: GBP 14,875
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    23 pagineAA

    Cessazione della carica di John Sellers come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    3 pagineCAP-SS

    legacy

    3 pagineSH20

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Miss Angela Newman come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Mark Hopkins come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    23 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Jonathan George Fairchild il 11 mar 2010

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter Dixon Edwards il 01 gen 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Juliet Sarah Loveday Davenport il 01 gen 2010

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Mark Hopkins come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jonathan Fairchild come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    22 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    17 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di WINDELECTRIC LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TRANAH, Nigel
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    Segretario
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    168397380001
    DAVENPORT, Juliet Sarah Lovedy
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    United KingdomBritish70686370003
    EDWARDS, Martin John
    The Bungalow
    Deli
    PL33 9BZ Delabole
    Cornwall
    Amministratore
    The Bungalow
    Deli
    PL33 9BZ Delabole
    Cornwall
    EnglandBritish81829090001
    EDWARDS, Peter Dixon
    Deli
    PL33 9BZ Delabole
    N Cornwall
    Amministratore
    Deli
    PL33 9BZ Delabole
    N Cornwall
    United KingdomBritish6723810001
    EDWARDS, Jeremy Paul
    Kempson House
    PO BOX 570,Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Segretario
    Kempson House
    PO BOX 570,Camomile Street
    EC3A 7AN London
    British27850190002
    FAIRCHILD, Jonathan George
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    Segretario
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    British91228100003
    HOPKINS, Mark
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    Segretario
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    149634170001
    NEWMAN, Angela
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    Segretario
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    155558130001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Segretario nominato
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001
    FISK, Nicholas John Spencer
    10 Edwards Meadow
    SN8 1UD Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    10 Edwards Meadow
    SN8 1UD Marlborough
    Wiltshire
    British36028930001
    LOPEZ-CACICEDO, Carlos, Dr
    362 Marlborough Road
    SN3 1NP Swindon
    Amministratore
    362 Marlborough Road
    SN3 1NP Swindon
    Spanish14105600002
    MASOOD, Tariq
    22 Ashgrove Avenue
    Ashley Down
    BS7 9LJ Bristol
    Amministratore
    22 Ashgrove Avenue
    Ashley Down
    BS7 9LJ Bristol
    United KingdomBritish46049660002
    MASOOD, Tariq
    46 Sherbourne Avenue
    Bradley Stoke
    BS12 8BB Bristol
    Avon
    Amministratore
    46 Sherbourne Avenue
    Bradley Stoke
    BS12 8BB Bristol
    Avon
    British46049660001
    MASTERMAN, Richard Thomas
    Thuborough House
    Sutcombe
    EX22 7QE Holsworthy
    Devon
    Amministratore
    Thuborough House
    Sutcombe
    EX22 7QE Holsworthy
    Devon
    British3437250001
    SEED, John Junior
    Highfield House North Road
    BA2 6HW Bath
    Bath & North East Somerset
    Amministratore
    Highfield House North Road
    BA2 6HW Bath
    Bath & North East Somerset
    British8670120001
    SELLERS, John Ernest
    Rodway Hill Manor
    Manor Road Mangotsfield
    BS16 9LG Bristol
    Amministratore
    Rodway Hill Manor
    Manor Road Mangotsfield
    BS16 9LG Bristol
    United KingdomBritish47428650001
    SWARBRICK, Gerard Joseph
    39 Upper Cranbrook Road
    Westbury Park
    BS6 7UR Bristol
    Amministratore
    39 Upper Cranbrook Road
    Westbury Park
    BS6 7UR Bristol
    EnglandBritish27850210001
    SWINDELLS, Brian James
    7 Hollymead Lane
    Stoke Bishop
    BS9 1LN Bristol
    Amministratore
    7 Hollymead Lane
    Stoke Bishop
    BS9 1LN Bristol
    British32426200002
    SAXON FINANCE CORPORATION LIMITED
    Thuborough House
    Sutcombe
    EX22 7QE Holsworthy
    Devon
    Amministratore
    Thuborough House
    Sutcombe
    EX22 7QE Holsworthy
    Devon
    59178080001

    WINDELECTRIC LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Performance guarantee and warranty guarantee assignment
    Creato il 14 nov 1991
    Consegnato il 22 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 4/11/91 and security documents issued pursuant thereto
    Brevi particolari
    All the companys rights title and interest in and to a performance guarantee dated 12/11/91.
    Persone aventi diritto
    • Natwest Investment Bank Limited
    Transazioni
    • 22 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Contract consultant's appointment and warranty and maintenance agreement charge
    Creato il 04 nov 1991
    Consegnato il 20 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from thecompany to the chargee under the terms of the facility letter dated 4TH NOVEMBER1991 and this deed
    Brevi particolari
    All the benefit of the contract agreement,the agreement,andthe warranty and maintenance agreement all dated 19TH july 1991 see form 395 ref M792C for full details.
    Persone aventi diritto
    • Natwest Investment Bank Limited
    Transazioni
    • 20 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Contract charge
    Creato il 04 nov 1991
    Consegnato il 15 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter of even date and the charge
    Brevi particolari
    All the benefit of an agreement dated 9/8/91.
    Persone aventi diritto
    • Natwest Investment Banl Limited
    Transazioni
    • 15 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over deposit account
    Creato il 04 nov 1991
    Consegnato il 13 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the company's right, title and interest-bearing deposit account number 66457901 at natwest investment bank limited designated cnw re: windelectric limited. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Natwest Investment Bank Limited
    Transazioni
    • 13 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over power purchase agreement
    Creato il 04 nov 1991
    Consegnato il 13 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to natwest investment bank limited or to any receiver appointed by the bank under the terms of the facility letter and/or mortgage debenture, both of even date, and/or this charge
    Brevi particolari
    All sums payable by non-fossil purchasing agency limited to the company under the power purchase agreement dated 12TH september 1990 and made beyween the company (1) non-fossil purchasing agency limited (2) and south western electricity PLC (3).
    Persone aventi diritto
    • Natwest Investment Bank Limited
    Transazioni
    • 13 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 04 nov 1991
    Consegnato il 13 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage all those areas of leasehold land and premises at deli farm development delabole cornwall and/or the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Natwest Investment Bank Limited
    Transazioni
    • 13 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0