OAKDENE CARE LIMITED
Panoramica
Nome della società | OAKDENE CARE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02407876 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di OAKDENE CARE LIMITED?
- Strutture residenziali di assistenza infermieristica (87100) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
Dove si trova OAKDENE CARE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 6th Floor One London Wall EC2Y 5EB London United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di OAKDENE CARE LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per OAKDENE CARE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Stephen Welch come amministratore in data 28 feb 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Paul Ray Womble come amministratore in data 28 feb 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 ott 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Stephen Welch il 03 ago 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 2 Temple Back East Temple Quay Bristol BS1 6EG | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 2 Temple Back East Temple Quay Bristol BS1 6EG | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sanne Group Secretaries (Uk) Limited come segretario in data 30 giu 2021 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 6th Floor 125 London Wall London EC2Y 5AS England a 6th Floor One London Wall London EC2Y 5EB in data 07 lug 2021 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 ott 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Sanne Group Secretaries (Uk) Limited il 10 ago 2020 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Asticus Building 2nd Floor 21 Palmer Street London SW1H 0AD a 6th Floor 125 London Wall London EC2Y 5AS in data 17 ago 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 ott 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan David Farkas come amministratore in data 07 giu 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Richard Stephen Welch come amministratore in data 07 giu 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 ott 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 ott 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di OAKDENE CARE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOMBLE, Paul Ray | Amministratore | E. John Carpenter Freeway Suite 1400 75062 Irving 545 Texas United States | United States | American | Cfo | 293942010001 | ||||||||
JEFFERY, Paul Anthony Keith | Segretario | Stable House Cockaynes Lane Alresford CO7 8BZ Colchester Essex | British | Company Director | 65609290003 | |||||||||
MATTHEWS, Adrienne Lindsay | Segretario | The Gleanings St Margarets Street ME1 1UF Rochester Kent | British | 19788060002 | ||||||||||
SCHOFIELD, Nigel Bennett | Segretario | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | British | 52338530002 | ||||||||||
SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED | Segretario | London Wall EC2Y 5AS London 6th Floor, 125 England |
| 175738460001 | ||||||||||
CORMACK, Derek George | Amministratore | Pillars Grantley Avenue, Wonersh GU5 0QN Guildford Surrey | England | Irish | Accountant | 67400530015 | ||||||||
FARKAS, Jonathan David | Amministratore | 2nd Floor 21 Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building | Luxembourg | American | Managing Director | 193539990001 | ||||||||
GOTTS, Anthony Keith | Amministratore | Beech House Montreal Road TN13 2EP Sevenoaks Kent | British | Company Director | 19788070002 | |||||||||
GOTTS, Yasmine | Amministratore | Beech House Montreal Road Riverhead TN13 2EP Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | Secretary | 91489150001 | ||||||||
GRIFFIN, Craig | Amministratore | Halebourne House Halebourne Lane GU24 8SL Chobham Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 154122490001 | ||||||||
HILL, Peter Martin | Amministratore | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | England | British | Accountant | 130983750002 | ||||||||
JEFFERY, Helena | Amministratore | Orchards Frating Road CO7 7JW Great Bromley Essex | British | Company Director | 71215830002 | |||||||||
JEFFERY, Paul Anthony Keith | Amministratore | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | United Kingdom | British | Accountant | 65609290003 | ||||||||
MATTHEWS, Adrienne Lindsay | Amministratore | The Gleanings St Margarets Street ME1 1UF Rochester Kent | British | State Registered Nurse | 19788060002 | |||||||||
MATTHEWS, Stephen Roy | Amministratore | 58 St Margarets Street ME1 1UF Rochester Kent | British | Care Home Developer | 19788090002 | |||||||||
SCHOFIELD, Nigel Bennett | Amministratore | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | United Kingdom | British | Solicitor | 148139420001 | ||||||||
STREIFF, Mathieu Bernard | Amministratore | Pollen House 10 Cork Street W1S 3NP London 2nd Floor | United States | American | Attorney | 200529310001 | ||||||||
WELCH, Richard Stephen | Amministratore | South Flower Street 44th Floor 90071 Los Angeles 515 California United States | United States | American | Company Director | 249076190001 | ||||||||
WHITE, Ian James | Amministratore | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | England | British | Accountant | 133383410003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di OAKDENE CARE LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ga Hc Reit Ch Uk Senior Housing Portfolio Limited | 06 apr 2016 | 21 Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building, 2nd Floor England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
OAKDENE CARE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 28 lug 2010 Consegnato il 06 ago 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each chargor to the chargee and to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. For details of property charged please refer to form MG01. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 16 nov 2007 Consegnato il 27 nov 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors to the chargee for the secured finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Ascot house 28 wingrove road fenham,34 and 36 wingrove road newcastle upon tynet/no's TY221509 and TY52154,bradbury house bradbury house new street braintree t/no ESX647090, cheshire house 22 st mary's road ashton on mersey t/no GM54543 (for details of further properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 28 ott 2005 Consegnato il 03 nov 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All land in england and wales now vested in the chargor, all interests and rights in or relating to land or the proceeds of sale, all plant and machinery, all rental and other income. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 24 apr 2003 Consegnato il 29 apr 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The f/h property k/a kippington grange road sevenoaks kent t/n K714055. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 24 apr 2003 Consegnato il 29 apr 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 12 mar 1992 Consegnato il 24 mar 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Kippington grange nursing home grange rd sevenoaks kent t/no K496417. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 17 feb 1992 Consegnato il 21 feb 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (Please see doc 395 tc ref M281C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0