OAKDENE CARE LIMITED

OAKDENE CARE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOAKDENE CARE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02407876
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OAKDENE CARE LIMITED?

    • Strutture residenziali di assistenza infermieristica (87100) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova OAKDENE CARE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    6th Floor One London Wall
    EC2Y 5EB London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di OAKDENE CARE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per OAKDENE CARE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di Richard Stephen Welch come amministratore in data 28 feb 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di Paul Ray Womble come amministratore in data 28 feb 2022

    2 pagineAP01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 ott 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    2 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Stephen Welch il 03 ago 2021

    2 pagineCH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 2 Temple Back East Temple Quay Bristol BS1 6EG

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 2 Temple Back East Temple Quay Bristol BS1 6EG

    1 pagineAD02

    Cessazione della carica di Sanne Group Secretaries (Uk) Limited come segretario in data 30 giu 2021

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da 6th Floor 125 London Wall London EC2Y 5AS England a 6th Floor One London Wall London EC2Y 5EB in data 07 lug 2021

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    2 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Financial statements for the 31/12/2019 is aprroved/director authorised to sign the balance sheet 22/12/2020
    RES13

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 ott 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del segretario cambiati per Sanne Group Secretaries (Uk) Limited il 10 ago 2020

    1 pagineCH04

    Indirizzo della sede legale modificato da Asticus Building 2nd Floor 21 Palmer Street London SW1H 0AD a 6th Floor 125 London Wall London EC2Y 5AS in data 17 ago 2020

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 ott 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    2 pagineAA

    Cessazione della carica di Jonathan David Farkas come amministratore in data 07 giu 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Richard Stephen Welch come amministratore in data 07 giu 2019

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 ott 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 ott 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    2 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di OAKDENE CARE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WOMBLE, Paul Ray
    E. John Carpenter Freeway
    Suite 1400
    75062 Irving
    545
    Texas
    United States
    Amministratore
    E. John Carpenter Freeway
    Suite 1400
    75062 Irving
    545
    Texas
    United States
    United StatesAmericanCfo293942010001
    JEFFERY, Paul Anthony Keith
    Stable House
    Cockaynes Lane Alresford
    CO7 8BZ Colchester
    Essex
    Segretario
    Stable House
    Cockaynes Lane Alresford
    CO7 8BZ Colchester
    Essex
    BritishCompany Director65609290003
    MATTHEWS, Adrienne Lindsay
    The Gleanings St Margarets Street
    ME1 1UF Rochester
    Kent
    Segretario
    The Gleanings St Margarets Street
    ME1 1UF Rochester
    Kent
    British19788060002
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Segretario
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    British52338530002
    SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED
    London Wall
    EC2Y 5AS London
    6th Floor, 125
    England
    Segretario
    London Wall
    EC2Y 5AS London
    6th Floor, 125
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione8334728
    175738460001
    CORMACK, Derek George
    Pillars
    Grantley Avenue, Wonersh
    GU5 0QN Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Pillars
    Grantley Avenue, Wonersh
    GU5 0QN Guildford
    Surrey
    EnglandIrishAccountant67400530015
    FARKAS, Jonathan David
    2nd Floor
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building
    Amministratore
    2nd Floor
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building
    LuxembourgAmericanManaging Director193539990001
    GOTTS, Anthony Keith
    Beech House Montreal Road
    TN13 2EP Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Beech House Montreal Road
    TN13 2EP Sevenoaks
    Kent
    BritishCompany Director19788070002
    GOTTS, Yasmine
    Beech House
    Montreal Road Riverhead
    TN13 2EP Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Beech House
    Montreal Road Riverhead
    TN13 2EP Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishSecretary91489150001
    GRIFFIN, Craig
    Halebourne House
    Halebourne Lane
    GU24 8SL Chobham
    Surrey
    Amministratore
    Halebourne House
    Halebourne Lane
    GU24 8SL Chobham
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director154122490001
    HILL, Peter Martin
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Amministratore
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandBritishAccountant130983750002
    JEFFERY, Helena
    Orchards
    Frating Road
    CO7 7JW Great Bromley
    Essex
    Amministratore
    Orchards
    Frating Road
    CO7 7JW Great Bromley
    Essex
    BritishCompany Director71215830002
    JEFFERY, Paul Anthony Keith
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Amministratore
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    United KingdomBritishAccountant65609290003
    MATTHEWS, Adrienne Lindsay
    The Gleanings St Margarets Street
    ME1 1UF Rochester
    Kent
    Amministratore
    The Gleanings St Margarets Street
    ME1 1UF Rochester
    Kent
    BritishState Registered Nurse19788060002
    MATTHEWS, Stephen Roy
    58 St Margarets Street
    ME1 1UF Rochester
    Kent
    Amministratore
    58 St Margarets Street
    ME1 1UF Rochester
    Kent
    BritishCare Home Developer19788090002
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Amministratore
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    United KingdomBritishSolicitor148139420001
    STREIFF, Mathieu Bernard
    Pollen House
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    2nd Floor
    Amministratore
    Pollen House
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    2nd Floor
    United StatesAmericanAttorney200529310001
    WELCH, Richard Stephen
    South Flower Street
    44th Floor
    90071 Los Angeles
    515
    California
    United States
    Amministratore
    South Flower Street
    44th Floor
    90071 Los Angeles
    515
    California
    United States
    United StatesAmericanCompany Director249076190001
    WHITE, Ian James
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Amministratore
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandBritishAccountant133383410003

    Chi sono le persone con controllo significativo di OAKDENE CARE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building, 2nd Floor
    England
    06 apr 2016
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building, 2nd Floor
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleThe Companies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04258255
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    OAKDENE CARE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 28 lug 2010
    Consegnato il 06 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee and to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. For details of property charged please refer to form MG01.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 06 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 16 nov 2007
    Consegnato il 27 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee for the secured finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Ascot house 28 wingrove road fenham,34 and 36 wingrove road newcastle upon tynet/no's TY221509 and TY52154,bradbury house bradbury house new street braintree t/no ESX647090, cheshire house 22 st mary's road ashton on mersey t/no GM54543 (for details of further properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 28 ott 2005
    Consegnato il 03 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All land in england and wales now vested in the chargor, all interests and rights in or relating to land or the proceeds of sale, all plant and machinery, all rental and other income. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transazioni
    • 03 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 24 apr 2003
    Consegnato il 29 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a kippington grange road sevenoaks kent t/n K714055. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 24 apr 2003
    Consegnato il 29 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 12 mar 1992
    Consegnato il 24 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Kippington grange nursing home grange rd sevenoaks kent t/no K496417.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 feb 1992
    Consegnato il 21 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Please see doc 395 tc ref M281C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0