MALDENCREST LIMITED
Panoramica
Nome della società | MALDENCREST LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02408776 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MALDENCREST LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova MALDENCREST LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di MALDENCREST LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per MALDENCREST LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 8 pagine | 4.71 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1 Admiral Way Doxford Int Business Park Sunderland Tyne and Wear SR3 3XP in data 14 set 2012 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Philip Martin Stone come amministratore in data 28 ago 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Anthony Bowler come amministratore in data 28 ago 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 26 mag 2012 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 feb 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Kenneth Mcintyre Carlaw come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Turner come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 feb 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 feb 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Philip Martin Stone il 22 feb 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Richard Anthony Bowler il 22 feb 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David Paul Turner il 22 feb 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 22 feb 2010 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2008 | 6 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2007 | 6 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a |
Chi sono gli amministratori di MALDENCREST LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVIES, Elizabeth Anne | Segretario | 1 Admiral Way Doxford Int Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne And Wear | British | 102907000002 | ||||||
CARLAW, Kenneth Mcintyre | Amministratore | Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York 11 | England | British | Company Secretary | 161250030001 | ||||
DONHUE, Stephen Mark | Segretario | 6 Bridgewater Street SY13 1QB Whitchurch Shropshire | British | 18652090001 | ||||||
STONE, Philip Martin | Segretario | 73 Stanfield Lane Farington PR5 2QL Preston Lancashire | British | Finance Director | 69200640001 | |||||
THORPE, Elizabeth Anne | Segretario | 2 Oakwood DH7 0NP Lanchester County Durham | British | 102907000001 | ||||||
TURNER, David Paul | Segretario | 139 Eastern Way Darras Hall Ponteland NE20 9RH Newcastle Upon Tyne | British | 48937720001 | ||||||
VIRTUE, John | Segretario | 91 Hollywood Avenue Gosforth NE3 5BU Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 102404840001 | ||||||
BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED | Segretario | 54 Endless Street SP1 3UH Salisbury Wiltshire | 42985760001 | |||||||
BAYFIELD, Stephen | Amministratore | Windy Ridge Riverside Close Stoford SP2 0PX Salisbury Wiltshire | British | Company Director | 42058550001 | |||||
BOWLER, Richard Anthony | Amministratore | 1 Admiral Way Doxford Int Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne And Wear | United Kingdom | British | Company Director | 35116070001 | ||||
DONHUE, Stephen Mark | Amministratore | 6 Bridgewater Street SY13 1QB Whitchurch Shropshire | British | Bus Operator | 18652090001 | |||||
GREGORY, Robert William | Amministratore | 2 Clyffes Farm Close Scarisbrick L40 9SB Ormskirk Lancashire | British | Managing Director | 23703810001 | |||||
HALE, John | Amministratore | 126 Aintree Lane Aintree L10 8LE Liverpool Merseyside | British | Bus Operator | 97943020001 | |||||
HIND, Robert Andrew | Amministratore | 18 Maplewell Road Woodhouse Eaves LE12 8QZ Loughborough Leicestershire | United Kingdom | British | Managing Director | 21961900002 | ||||
JONES, Michael Adrian | Amministratore | 3 Old Shaftesbury Drive Old Blandford Road Harnham SP2 8QH Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | Company Director | 77984700001 | ||||
LONSDALE, Stephen Philip | Amministratore | 5 Lintfort Picktree Farm Picktree NE38 9HX Chester Le Street County Durham | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 4971910001 | ||||
MARTIN, David Robert | Amministratore | Bondwood Barn Repton Shrubs Bretby DE15 0RJ Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | Director | 6874440001 | ||||
RAY, John Alfred | Amministratore | 50 The Gables Sedgefield TS21 3EU Stockton On Tees Cleveland | British | Company Director | 58415290001 | |||||
REID, Michael John | Amministratore | 3 Varlian Close Westhead L40 6HJ Ormskirk Lancashire England | British | Engineering Director | 43913680001 | |||||
STONE, Philip Martin | Amministratore | 1 Admiral Way Doxford Int Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne And Wear | England | British | Director | 69200640003 | ||||
STONE, Philip Martin | Amministratore | 21 Beechfield Road Mayfield PR25 3BG Leyland Lancashire | England | British | Finance Director | 69200640003 | ||||
TURNER, David Paul | Amministratore | 1 Admiral Way Doxford Int Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne And Wear | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 48937720001 | ||||
WATT, Gordon George | Amministratore | Alderbury Holt Southampton Road,Clarendon SP5 3DG Salisbury Wiltshire | England | British | Company Director | 67622780002 | ||||
WILLIAMS, Dawson Thomas | Amministratore | Chately Wood House Rockford BH24 3LZ Ringwood Hampshire | British | Company Director | 2719600006 |
MALDENCREST LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Letter of charge and set-off over credit balances | Creato il 15 ago 1994 Consegnato il 31 ago 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the working capital facility letter dated 15TH august 1994 | |
Brevi particolari All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating charge | Creato il 04 mag 1994 Consegnato il 17 mag 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined in the charge) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 12 gen 1994 Consegnato il 19 gen 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 16 lug 1990 Consegnato il 20 lug 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
MALDENCREST LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0