SWITCH2 ENERGY LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SWITCH2 ENERGY LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02409803 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SWITCH2 ENERGY LIMITED?
- Installazione idraulica, termica e di climatizzazione (43220) / Costruzioni
- Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi
Dove si trova SWITCH2 ENERGY LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | The Waterfront Salts Mill Road BD17 7EZ Shipley West Yorkshire United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SWITCH2 ENERGY LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ENER-G SWITCH2 LIMITED | 28 mag 2010 | 28 mag 2010 |
| SWITCH2 ENERGY SOLUTIONS LIMITED | 11 feb 2004 | 11 feb 2004 |
| VITERRA ENERGY SERVICES LIMITED | 20 set 1999 | 20 set 1999 |
| RAAB KARCHER ENERGY SERVICES LIMITED | 13 dic 1994 | 13 dic 1994 |
| ISS CLORIUS LIMITED | 01 gen 1993 | 01 gen 1993 |
| ISS CLORIUS METERING LIMITED | 17 gen 1990 | 17 gen 1990 |
| NISPUN LIMITED | 31 lug 1989 | 31 lug 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SWITCH2 ENERGY LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 mar 2026 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 dic 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per SWITCH2 ENERGY LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 16 mar 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 30 mar 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 16 mar 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per SWITCH2 ENERGY LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilancio redatto al 31 mar 2025 | 38 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Dean Eddleston il 07 apr 2025 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher John Hull il 31 mar 2025 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Kirsty Jane Lambert il 07 apr 2025 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard John Harrison il 07 apr 2025 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy Hays Scott il 16 mar 2025 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 mar 2025 con aggiornamenti | 7 pagine | CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Mr Nikolaus Wilhelm come persona con controllo significativo il 28 mar 2025 | 2 pagine | PSC04 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Alexandra Oberhuber-Wilhelm come persona con controllo significativo il 28 mar 2025 | 2 pagine | PSC04 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Mr Timothy Hays Scott come persona con controllo significativo il 16 mar 2025 | 2 pagine | PSC04 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher John Hull il 16 mar 2025 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony Peter Roy Ward il 16 mar 2025 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2024 | 38 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Paul Ramsden come amministratore in data 26 nov 2024 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Notifica di Alexandra Oberhuber-Wilhelm come persona con controllo significativo il 01 ago 2024 | 2 pagine | PSC01 | ||||||||||
Cessazione di Thomas Martin Joseph Wilhelm come persona con controllo significativo il 15 giu 2024 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Martin Goodman come amministratore in data 02 ago 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 mar 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2023 | 27 pagine | AA | ||||||||||
Stato del capitale al 26 mag 2023
| 6 pagine | SH19 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 024098030006 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 mar 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SWITCH2 ENERGY LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDDLESTON, Simon Dean | Amministratore | Salts Mill Road BD17 7EZ Shipley The Waterfront West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 278103710001 | |||||
| HARRISON, Richard John | Amministratore | Salts Mill Road BD17 7EZ Shipley The Waterfront West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 200173880002 | |||||
| HULL, Christopher John | Amministratore | Salts Mill Road BD17 7EZ Shipley The Waterfront West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 165040000001 | |||||
| LAMBERT, Kirsty Jane | Amministratore | Salts Mill Road BD17 7EZ Shipley The Waterfront West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 188166780001 | |||||
| RAMSDEN, Paul | Amministratore | Salts Mill Road BD17 7EZ Shipley The Waterfront West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 329759740001 | |||||
| SCOTT, Timothy Hays | Amministratore | Salts Mill Road BD17 7EZ Shipley The Waterfront West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 45684220006 | |||||
| WARD, Anthony Peter Roy | Amministratore | Salts Mill Road BD17 7EZ Shipley The Waterfront West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 213963120002 | |||||
| BRIERLEY, Andrew Kenneth | Segretario | 2 Redshots Close SL7 3LW Marlow Buckinghamshire | British | 20932650001 | ||||||
| EVANS, Andrew John | Segretario | 36 Highfield Avenue Newbold S41 7AX Chesterfield Derbyshire | British | 77728860001 | ||||||
| FORTES, Christopher | Segretario | 9 Rush Croft Cote Farm BD10 8WN Bradford West Yorkshire | British | 43013230002 | ||||||
| GIBSON, Laura | Segretario | 17 Greenhill Drive Micklethwaite BD16 3HT Bingley West Yorkshire | British | 99272660002 | ||||||
| WARDNER, Richard | Segretario | Daniel Adamson Road M50 1DT Salford Edison House Manchester United Kingdom | 166217200001 | |||||||
| AMTRUP, Morten | Amministratore | Vilvordevej 52 52 Dk-2920 DK-2920 Charlottenlund Dk-2920 Denmark | Danish | 64992610001 | ||||||
| ARMITAGE, Christopher Herbert | Amministratore | 19 Southwell Gardens OL6 8XS Ashton Under Lyne Lancashire | British | 21317090001 | ||||||
| BRIERLEY, Andrew Kenneth | Amministratore | 2 Redshots Close SL7 3LW Marlow Buckinghamshire | British | 20932650001 | ||||||
| CAROE, Harold Preben | Amministratore | Drosselvaengeu 5 Ballerup Dk 2750 FOREIGN Denmark | Danish | 20932660001 | ||||||
| CLARE, Carolyn Jayne | Amministratore | c/o Ener-G Switch2 Limited Salts Mill Road BD17 7EZ Shipley The Waterfront West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 94856580001 | |||||
| DEBENHAM, Alistair Robert | Amministratore | Salts Mill Road BD17 7EZ Shipley The Waterfront West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 219575700001 | |||||
| DUFFILL, Derek John | Amministratore | Daniel Adamson Road Salford M50 1DT Manchester Ener-G House | United Kingdom | British | 83770930001 | |||||
| EVANS, Andrew John | Amministratore | Daniel Adamson Road M50 1DT Salford Edison House Manchester United Kingdom | United Kingdom | British | 77728860003 | |||||
| FORTES, Christopher | Amministratore | c/o Ener-G Switch2 Limited Salts Mill Road BD17 7EZ Shipley The Waterfront West Yorkshire United Kingdom | England | British | 43013230002 | |||||
| FROST, Jorgen | Amministratore | Jernbanevej 3 FOREIGN 4500 Nykqbing S Denmark Denmark | Danish | 38749320001 | ||||||
| GOODMAN, Peter Martin | Amministratore | Salts Mill Road BD17 7EZ Shipley The Waterfront West Yorkshire United Kingdom | England | British | 137634950001 | |||||
| GREAVES, Richard John | Amministratore | Daniel Adamson Road M50 1DT Salford Edison House Manchester United Kingdom | United Kingdom | British | 180918230001 | |||||
| HAYTON, Christopher James | Amministratore | Daniel Adamson Road M50 1DT Salford Ener-G House Manchester United Kingdom | United Kingdom | British | 99757040002 | |||||
| HEUVELDOP, Andreas | Amministratore | Winkelsfelder Strasse 26 FOREIGN Dusseldorf 40477 Germany | German | 86863370001 | ||||||
| KIRSCHBAUM, Christian | Amministratore | 28 The Mansion The Green BD16 4UF Bingley West Yorkshire | German | 66618780001 | ||||||
| OHALLORAN, Martin Francis | Amministratore | Burleigh Court Burleigh Road SL5 7LE Ascot Berkshire | British | 31025970001 | ||||||
| PEARCE, Michael William | Amministratore | Salts Mill Road BD17 7EZ Shipley The Waterfront West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 77521670011 | |||||
| PHILLIPS, David John | Amministratore | Primrose Cottage Skirethorn Lane Threshfield BD23 5PH Skipton | British | 94858390001 | ||||||
| RANBEK, Jorgen | Amministratore | Kogevej 144 Tostrop Dk 2630 FOREIGN Denmark | Danish | 20932670001 | ||||||
| REISGEN, Wilhelm Valentin | Amministratore | Durerstrasse 9 Neuss 41466 Germany | German | 64992490001 | ||||||
| SCOTT, Samantha Jane | Amministratore | Daniel Adamson Road M50 1DT Salford Edison House Manchester United Kingdom | Channel Islands | British | 213964380001 | |||||
| SLEE, Richard Peter | Amministratore | Salts Mill Road BD17 7EZ Shipley The Waterfront West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 257238480001 | |||||
| WAITE, Charles Francis Simon | Amministratore | Salts Mill Road BD17 7EZ Shipley The Waterfront West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 257238470002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SWITCH2 ENERGY LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra Maria Oberhuber-Wilhelm | 01 ago 2024 | PO BOX 1150 N/A 9490 Vaduz Lova-Center Liechtenstein | No | ||||||||||
Nazionalità: Liechtenstein Citizen Paese di residenza: Liechtenstein | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Dr Thomas Martin Joseph Wilhelm | 20 giu 2018 | PO BOX 1150 Vaduz Lova-Center Fl - 9490 Liechtenstein | Sì | ||||||||||
Nazionalità: Liechtenstein Citizen Paese di residenza: Liechtenstein | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Martin Lothar Ernst Hornig | 20 giu 2018 | PO BOX 1150 Vaduz Lova-Center Fl - 9490 Liechtenstein | Sì | ||||||||||
Nazionalità: Liechtenstein Citizen Paese di residenza: Liechtenstein | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Mr Timothy Hays Scott | 20 giu 2018 | Salts Mill Road BD17 7EZ Shipley The Waterfront West Yorkshire United Kingdom | No | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: Jersey | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Mr Nikolaus Thomas Wilhelm | 20 giu 2018 | PO BOX 1150 N/A 9490 Vaduz Lova-Center Liechtenstein | No | ||||||||||
Nazionalità: Liechtenstein Citizen Paese di residenza: Liechtenstein | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Switch2 Udh Limited | 13 apr 2018 | Salts Mill Road BD17 7EZ Shipley The Waterfront West Yorkshire United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Switch2 Holdings Limited | 06 apr 2016 | Daniel Adamson Road Salford Ener-G House Manchester United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0