NEDLLOYD GENOA LIMITED

NEDLLOYD GENOA LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNEDLLOYD GENOA LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02412292
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NEDLLOYD GENOA LIMITED?

    • Leasing finanziario (64910) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova NEDLLOYD GENOA LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NEDLLOYD GENOA LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    P & O NEDLLOYD GENOA LIMITED27 ott 200427 ott 2004
    A & L CF DECEMBER (4) LIMITED19 gen 200419 gen 2004
    SOVEREIGN FLEET SERVICES LIMITED30 mar 200030 mar 2000
    SOVEREIGN TOWER LIMITED09 ago 198909 ago 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di NEDLLOYD GENOA LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per NEDLLOYD GENOA LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 giu 2017

    8 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da 13th Floor, Aldgate Tower 2 Leman Street London E1 8FA United Kingdom a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU in data 08 lug 2016

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 giu 2016

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Indirizzo della sede legale modificato da Maersk House Braham Street London E1 8EP a 13th Floor, Aldgate Tower 2 Leman Street London E1 8FA in data 27 mag 2016

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    2 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 ago 2015

    Stato del capitale al 11 ago 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 ago 2014

    Stato del capitale al 14 ago 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Cessazione della carica di Terence Cornick come amministratore

    2 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di NEDLLOYD GENOA LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KILBY, John, Mr.
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Segretario
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    British76247880001
    KILBY, John, Mr.
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Amministratore
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    EnglandBritish76247880001
    LEHMANN-TAYLOR, Nigel Edmund
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Amministratore
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    EnglandBritish137861000001
    CHEESEMAN, Guy Robert
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    Segretario
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    British7865940001
    DUVAL, Michael John
    Greenfields
    Ponds Road
    CM2 8QP Chelmsford
    Essex
    Segretario
    Greenfields
    Ponds Road
    CM2 8QP Chelmsford
    Essex
    British72879690001
    SINCLAIR FORD, Ian Andrew
    Stainton 103 Menlove Avenue
    Calderstones
    L18 3HP Liverpool
    Segretario
    Stainton 103 Menlove Avenue
    Calderstones
    L18 3HP Liverpool
    British58189030001
    TAYLOR, Charles Stuart
    Balnacroft 8 Stonewalls
    Rosemary Lane Rossett
    LL12 0LG Wrexham
    Flintshire
    Segretario
    Balnacroft 8 Stonewalls
    Rosemary Lane Rossett
    LL12 0LG Wrexham
    Flintshire
    British27312630001
    ZIMMER, Kaarina Ann
    Riowstraat 43
    2585 Gs
    The Hague
    Netherlands
    Segretario
    Riowstraat 43
    2585 Gs
    The Hague
    Netherlands
    British104894830001
    ALLEN, Martyn Clive
    Maersk House
    Braham Street
    E1 8EP London
    Amministratore
    Maersk House
    Braham Street
    E1 8EP London
    United KingdomBritish117739980001
    ALLEN, Martyn Clive
    17 Inglis Road
    CO3 3HU Colchester
    Essex
    Amministratore
    17 Inglis Road
    CO3 3HU Colchester
    Essex
    United KingdomBritish117739980001
    BENFIELD, Gary John
    7 Broadoaks
    Darland Lane, Rossett
    LL12 0FA Wrexham
    Clwyd
    Amministratore
    7 Broadoaks
    Darland Lane, Rossett
    LL12 0FA Wrexham
    Clwyd
    British68702900001
    BILLINGHAM, David Christopher
    10 Campbell Close
    Kingsmead
    CW9 8NZ Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    10 Campbell Close
    Kingsmead
    CW9 8NZ Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish68546630003
    BRITTAIN, Frederick Humphrey
    C/O Sovereign Leasing Plc
    298 Deansgate
    M3 4HH Manchester
    Gtr Manchester
    Amministratore
    C/O Sovereign Leasing Plc
    298 Deansgate
    M3 4HH Manchester
    Gtr Manchester
    British23574940002
    BURRIDGE, James George Thomas
    Julien Road
    W5 4XA London
    5
    Amministratore
    Julien Road
    W5 4XA London
    5
    EnglandUnited Kingdom59355820001
    CHRISTENSEN, Sune Norup
    Maersk House
    Braham Street
    E1 8EP London
    Amministratore
    Maersk House
    Braham Street
    E1 8EP London
    United KingdomDanish161396040001
    CORNICK, Terence Eric
    Maersk House
    Braham Street
    E1 8EP London
    Amministratore
    Maersk House
    Braham Street
    E1 8EP London
    United KingdomBritish134551700001
    DUFFY, Anthony Paul
    7 Outram Road
    Alexandra Park
    N22 7AB London
    Amministratore
    7 Outram Road
    Alexandra Park
    N22 7AB London
    EnglandBritish72286750001
    EVANS, Martin William
    26 Moss Lane
    Bramhall
    SK7 1EH Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    26 Moss Lane
    Bramhall
    SK7 1EH Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish55210060002
    GREEN, Susan Linda
    4 Old Hall Park
    Guilden Sutton
    CH3 7ER Chester
    Cheshire
    Amministratore
    4 Old Hall Park
    Guilden Sutton
    CH3 7ER Chester
    Cheshire
    British68546700001
    GUGGLBERGER, Klaus
    Graf Starhembergasse 4
    1040 Vienna
    Austria
    Amministratore
    Graf Starhembergasse 4
    1040 Vienna
    Austria
    Austrian32780800002
    JARDINE, John
    The Old School Guilden Sutton Lane
    Guilden Sutton
    CH3 7EX Chester
    Amministratore
    The Old School Guilden Sutton Lane
    Guilden Sutton
    CH3 7EX Chester
    British31897840002
    LEE, Andrew Philip, Mr.
    29 Alder Lane
    Balsall Common
    CV7 7DZ Solihull
    Amministratore
    29 Alder Lane
    Balsall Common
    CV7 7DZ Solihull
    United KingdomBritish73882180001
    MARKS, Norman
    4 Old Hall Park
    Guilden Sutton
    CH3 7ER Chester
    Amministratore
    4 Old Hall Park
    Guilden Sutton
    CH3 7ER Chester
    British48820520002
    MONEY, Timothy John
    Riverdale
    148 Peperharow Road
    GU7 2PW Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Riverdale
    148 Peperharow Road
    GU7 2PW Godalming
    Surrey
    EnglandBritish71374890003
    MORLEY, Colin Richard
    Flat 1 Model Lodging House
    Bloom Street
    M3 6AJ Salford
    Lancashire
    Amministratore
    Flat 1 Model Lodging House
    Bloom Street
    M3 6AJ Salford
    Lancashire
    EnglandBritish89102840002
    O'BRIEN, Bernadette Mary
    10 Stormont Road
    Highgate
    N6 4NL London
    Amministratore
    10 Stormont Road
    Highgate
    N6 4NL London
    EnglandIrish95129740001
    PUSEY, Nigel Simon
    Roslyns
    Water Lane
    CB9 7AL Helions Bumpstead
    Suffolk
    Amministratore
    Roslyns
    Water Lane
    CB9 7AL Helions Bumpstead
    Suffolk
    British83149350005
    ROBBIE, David Andrew
    4 St Johns House 30 Smith Square
    SW1P 3HF London
    Amministratore
    4 St Johns House 30 Smith Square
    SW1P 3HF London
    United KingdomBritish108246820001
    SALVERDA, Arnold Ate
    Brugakker 6547
    3704 Rk Zeist
    Netherlands
    Amministratore
    Brugakker 6547
    3704 Rk Zeist
    Netherlands
    Dutch101663120001
    SCOTT, Ian Garden
    Riverbank House
    AB34 5JD Aboyne
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Riverbank House
    AB34 5JD Aboyne
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish79132120001
    SWANN, Andrew Blyth
    Nield House
    Beamond End
    HP7 0QT Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Nield House
    Beamond End
    HP7 0QT Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish60626890003
    TAYLOR, Charles Stuart
    Balnacroft 8 Stonewalls
    Rosemary Lane Rossett
    LL12 0LG Wrexham
    Flintshire
    Amministratore
    Balnacroft 8 Stonewalls
    Rosemary Lane Rossett
    LL12 0LG Wrexham
    Flintshire
    United KingdomBritish27312630001
    TOWERS, Robert Leslie
    27 Winwick Park Avenue
    Winwick
    WA2 8XB Warrington
    Amministratore
    27 Winwick Park Avenue
    Winwick
    WA2 8XB Warrington
    United KingdomBritish65275200002
    VAN SLOBBE, Rutger Paul Marie
    Oranje Nassaulaan 54b
    FOREIGN 1075 Ar Amsterdam
    Netherlands
    Amministratore
    Oranje Nassaulaan 54b
    FOREIGN 1075 Ar Amsterdam
    Netherlands
    Dutch97369340002
    WHITE, Charles Toby Fitzherbert
    Hopton Wafers
    DY14 0NA Cleobury Mortimer
    The Manor House
    Shropshire
    Amministratore
    Hopton Wafers
    DY14 0NA Cleobury Mortimer
    The Manor House
    Shropshire
    United KingdomUk129100360001

    NEDLLOYD GENOA LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    British statutory mortgage
    Creato il 22 ott 2004
    Consegnato il 09 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as a & l cf december (4) limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The vessel: the british flagged motor vessel p & o nedlloyd marseille official number 901564, and engines, machinery, boats, tackle, outfit, equipment, spare gear, fuel, consumable and other stores, belongings and appurtenances;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Granite Shipping Company Limited
    Transazioni
    • 09 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment
    Creato il 22 ott 2004
    Consegnato il 09 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as a & l cf december (4) limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The assigned property: the 2900 teu british flag container vessel M.V. p & o nedlloyd marseille, all of the company's present and future rights, title and interest in and to all benefits;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Granite Shipping Company Limited
    Transazioni
    • 09 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of covenants
    Creato il 22 ott 2004
    Consegnato il 09 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as a & l cf december (4) limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The mortgaged property: the container vessel M.V. p & o nedlloyd marseille official number 901564, and includes any share or interest therein and her engines, machinery, boats, tackle, outfit, equipment, spare gear, fuel, consumable and other stores, belongings and appurtenances;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Granite Shipping Company Limited
    Transazioni
    • 09 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment
    Creato il 22 ott 2004
    Consegnato il 08 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the companys rights, title and interest in and to all the benefits and interests from and under each assigned contract and the earnings an dby way of floating charge all the undertaking and assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nib Capital Bank N.V.
    Transazioni
    • 08 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of covenant
    Creato il 22 ott 2004
    Consegnato il 08 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The companys rights title and interest in and to the ship, the owners insurances and all of the companys benefits and interests present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nib Capital Bank N.V.
    Transazioni
    • 08 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Ship mortgage
    Creato il 22 ott 2004
    Consegnato il 08 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The container vessel M.V. "p&o nedlloyd genoa"registered under british flag under official number 901564 and includes any share or interest and her engines, machinery, boats, tackle, outfit, equipment, spare gear, fuel, consumable and other stores, belongings and appurtenances whether on board or ashore and whether owned on the date of the mortgage or thereafter acquired.
    Persone aventi diritto
    • Nib Capital Bank N.V.
    Transazioni
    • 08 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    First priority statutory mortgage
    Creato il 22 ott 2004
    Consegnato il 03 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    64/64TH shares in M.v "nedlloyd genoa" registered under the british flag under official number "901564" and its appurtenances.
    Persone aventi diritto
    • Kfw (Formerly K/a Kreditanstalt Fur Wiederaufbau)
    Transazioni
    • 03 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    First assignment
    Creato il 22 ott 2004
    Consegnato il 03 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the assigners undertaking and all its assets and rights, the assets, the excluded assets and any other assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kfw (Formerly K/a Kreditanstalt Fur Wiederaufbau)
    Transazioni
    • 03 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of covenant
    Creato il 22 ott 2004
    Consegnato il 03 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Right title and interest in the property= the ship being the container vessel M.v "p&o nedlloyd genoa" registered under the british flag under official number "901564" including any share or interest therein, the engine, machinery, boats, tackle, outfit, equipment, share gear, fuel consumable and other stores. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kfw (Formerly K/a Kreditanstalt Fur Wiederaufbau)
    Transazioni
    • 03 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of covenants
    Creato il 05 apr 2004
    Consegnato il 21 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Mortgaged property being (a) the vessel (b) the insurances and (c) any lessor's requisition compensation. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Granite Shipping Company Limited
    Transazioni
    • 21 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage of a ship
    Creato il 05 apr 2004
    Consegnato il 21 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All 64/64TH shares in the british flag "p&o nedlloyd genoa" official no. 901564.
    Persone aventi diritto
    • Granite Shipping Company Limited
    Transazioni
    • 21 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge
    Creato il 05 apr 2004
    Consegnato il 21 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The account balances and all other rights, titles and interests of the company in and to the account.
    Persone aventi diritto
    • Granite Shipping Company Limited
    Transazioni
    • 21 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    NEDLLOYD GENOA LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 giu 2016Inizio della liquidazione
    13 dic 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0