ORANGE HOLDINGS (UK) LIMITED

ORANGE HOLDINGS (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàORANGE HOLDINGS (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02412603
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ORANGE HOLDINGS (UK) LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ORANGE HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3 More London Riverside
    SE1 2AQ London
    England
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ORANGE HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS (UK) LIMITED29 ago 199029 ago 1990
    HUTCHISON COMMUNICATIONS (UK) LIMITED22 nov 198922 nov 1989
    HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS (UK) LIMITED05 set 198905 set 1989
    MASSTOP LIMITED10 ago 198910 ago 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di ORANGE HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ORANGE HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ORANGE HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 apr 2013

    Stato del capitale al 08 apr 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    14 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * Norose Company Secretarial Service Ltd 3 More London Riverside London SE1 2AQ England* in data 23 ago 2012

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da * St James Court Great Park Road Almondsbury Park Bradley Stoke Bristol BS32 4QJ* in data 10 ago 2012

    1 pagineAD01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Bilancio annuale redatto al 29 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Charles Mowat come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Colin Caldwell come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Ibiyemi Solanke come segretario

    1 pagineAP03

    Stato del capitale al 27 set 2011

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineSH20

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    15 pagineAA

    Cessazione della carica di Orange Limited come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Orange Limited come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 29 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Sian Williams il 28 mar 2011

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di ORANGE HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SOLANKE, Ibiyemi
    More London Riverside
    SE1 2AQ London
    3
    England
    England
    Segretario
    More London Riverside
    SE1 2AQ London
    3
    England
    England
    163415110001
    VAN DEN CRUIJCE, Johan
    1930 Zaventem
    Tomberg 10
    Belgium
    Amministratore
    1930 Zaventem
    Tomberg 10
    Belgium
    BelgiumBelgian150237100001
    WILLIAMS, Sian
    More London Riverside
    SE1 2AQ London
    3
    England
    England
    Amministratore
    More London Riverside
    SE1 2AQ London
    3
    England
    England
    United KingdomBritish150231120001
    CALDWELL, Colin
    St James Court
    Great Park Road Almondsbury Park
    BS32 4QJ Bradley Stoke Bristol
    Segretario
    St James Court
    Great Park Road Almondsbury Park
    BS32 4QJ Bradley Stoke Bristol
    British43007750002
    DOYLE, Amanda
    Cotswold House
    Horseshoe Lane
    BS37 6ES Chipping Sodbury
    Segretario
    Cotswold House
    Horseshoe Lane
    BS37 6ES Chipping Sodbury
    British77978950001
    DUBOIS DENIS, Isabelle
    17 Star Street
    W2 1QD London
    Segretario
    17 Star Street
    W2 1QD London
    British83784610001
    DUBOIS DENIS, Isabelle
    17 Star Street
    W2 1QD London
    Segretario
    17 Star Street
    W2 1QD London
    British83784610001
    EMERY, Clare
    The Old Meeting House The Green
    Olveston
    BS12 3EJ Bristol
    Segretario
    The Old Meeting House The Green
    Olveston
    BS12 3EJ Bristol
    British43051010001
    GUY, Estelle Una
    Flat 6 10 York Street
    W1U 6PW London
    Segretario
    Flat 6 10 York Street
    W1U 6PW London
    British65966530002
    GUY, Estelle Una
    36 Priory Avenue
    Chingford
    E4 8AB London
    Segretario
    36 Priory Avenue
    Chingford
    E4 8AB London
    British65966530001
    MOWAT, Charles
    Great Park Road
    Almondsbury Park
    BS32 4QJ Bradley Stoke
    St. James Court
    Bristol
    England
    Segretario
    Great Park Road
    Almondsbury Park
    BS32 4QJ Bradley Stoke
    St. James Court
    Bristol
    England
    British108098180003
    PATERSON, Mark Alexander
    6 Brackley Road
    W4 2HN London
    Segretario
    6 Brackley Road
    W4 2HN London
    British98795620001
    RICHARDSON, Anna
    49 Cyril Mansions
    Prince Of Wales Drive
    SW11 4HW London
    Segretario
    49 Cyril Mansions
    Prince Of Wales Drive
    SW11 4HW London
    British92706030002
    SHEDDEN, Robert Alan
    18c Hillfield Road
    West Hampstead
    NW6 1PZ London
    Segretario
    18c Hillfield Road
    West Hampstead
    NW6 1PZ London
    British76265950001
    ABOGADO CUSTODIANS LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Segretario nominato
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    900021140001
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Segretario nominato
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    900021150001
    ALLWOOD, Charles John
    Park Farm The Twist
    Wigginton
    HP23 6DU Tring
    Hertfordshire
    Amministratore
    Park Farm The Twist
    Wigginton
    HP23 6DU Tring
    Hertfordshire
    EnglandBritish35681240003
    BOTTING, Alvin Leslie
    7 Overford Close
    GU6 8BL Cranleigh
    Surrey
    Amministratore
    7 Overford Close
    GU6 8BL Cranleigh
    Surrey
    British36340880001
    BOWERMAN, Michael
    19 Whitwell Way
    Coton
    CB3 7PW Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    19 Whitwell Way
    Coton
    CB3 7PW Cambridge
    Cambridgeshire
    British40615680001
    BRADLEY, Keith Terence
    27 Love Lane
    GU31 4BP Petersfield
    Hampshire
    Amministratore
    27 Love Lane
    GU31 4BP Petersfield
    Hampshire
    British41968200001
    DERWENT, Robin Evelyn Leo, The Right Honourable Lord
    Flat 6 Sovereign Court
    29 Wrights Lane
    W8 5SH London
    Amministratore
    Flat 6 Sovereign Court
    29 Wrights Lane
    W8 5SH London
    British36163130004
    FOK, Canning Kin Ning
    House 4
    8 Deep Water Bay Road
    Hong Kong
    Hong Kong
    Amministratore
    House 4
    8 Deep Water Bay Road
    Hong Kong
    Hong Kong
    Australian24324420004
    FULLER, Robert
    Fenrother Grange Fenrother
    Longhorsley
    NE61 3DP Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    Fenrother Grange Fenrother
    Longhorsley
    NE61 3DP Morpeth
    Northumberland
    British36842350002
    GIBSON, Ian Charles
    Mendip Cottage
    Shrowle, East Harptree
    BS40 6BJ Bristol
    Avon
    Amministratore
    Mendip Cottage
    Shrowle, East Harptree
    BS40 6BJ Bristol
    Avon
    British141445820001
    HOWE, Graham Edward
    5 Rosebery Avenue
    AL5 2QT Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    5 Rosebery Avenue
    AL5 2QT Harpenden
    Hertfordshire
    British33771120003
    KHOO, Chek Ngee
    3108 Parkside
    88 Queensway
    Central
    Hong Kong
    Amministratore
    3108 Parkside
    88 Queensway
    Central
    Hong Kong
    Singaporean41959910002
    LAPTHORNE, Richard Douglas
    Mill Barn Mill Lane
    Weston Turville
    HP22 5RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Mill Barn Mill Lane
    Weston Turville
    HP22 5RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish13722740001
    MAGNUS, George Colin
    19/F Repulse Bay Garden
    32 Belleview Drive
    Repulse Bay
    Hong Kong
    Amministratore
    19/F Repulse Bay Garden
    32 Belleview Drive
    Repulse Bay
    Hong Kong
    British26614440001
    MCALLISTER, Philippe
    270 Rue De Vaugirard
    75015 Paris
    France
    Amministratore
    270 Rue De Vaugirard
    75015 Paris
    France
    French81014430001
    MURRAY, Simon
    Ground Floor Block B
    FOREIGN 39 Tung Tau Wan Road
    Hong Kong
    Hong Kong
    Amministratore
    Ground Floor Block B
    FOREIGN 39 Tung Tau Wan Road
    Hong Kong
    Hong Kong
    British71635370005
    NEWNHAM, Michael David
    The Coach House 103 Hartfield Road
    Wimbledon
    SW19 3TJ London
    Amministratore
    The Coach House 103 Hartfield Road
    Wimbledon
    SW19 3TJ London
    British77105370001
    PATERSON, Mark Alexander
    6 Brackley Road
    W4 2HN London
    Amministratore
    6 Brackley Road
    W4 2HN London
    EnglandBritish98795620001
    ROSE, George Wilfred
    Craven Fold
    Moorside Lane
    BB7 9DB Wiswell
    Lancashire
    Amministratore
    Craven Fold
    Moorside Lane
    BB7 9DB Wiswell
    Lancashire
    United KingdomBritish35078030001
    SHOTTON, Kenneth John
    Halisden Rockfield Road
    RH8 0EL Oxted
    Surrey
    Amministratore
    Halisden Rockfield Road
    RH8 0EL Oxted
    Surrey
    British26614450001
    SHURNIAK, William
    9f Woodland Heights
    2f Wongneichong Gap Road Happy Valle
    FOREIGN Hong Kong
    Hong Kong
    Amministratore
    9f Woodland Heights
    2f Wongneichong Gap Road Happy Valle
    FOREIGN Hong Kong
    Hong Kong
    Canadian14848200001

    ORANGE HOLDINGS (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite debenture
    Creato il 19 dic 1997
    Consegnato il 31 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under each finance document (as therein defined)
    Brevi particolari
    Block a st james court south great park road woodlands lane bradley stoke t/n AV206385 block b st james court south great park road woodlands lane bradley stoke t/n AV206535 and ground floor key point great park road bradley stoke (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited(As Security Trustee)
    Transazioni
    • 31 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed providing for cash deposit in respect of 4TH floor,25 st.james's street,london SW1
    Creato il 20 dic 1996
    Consegnato il 21 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the provisions of the lease or this deed
    Brevi particolari
    £79,165 deposited with the chargee with all interest thereon under the provisions of the said deed.
    Persone aventi diritto
    • Ryder Street Properties Limited
    Transazioni
    • 21 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed
    Creato il 20 dic 1996
    Consegnato il 21 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the provisions of the lease or the deed
    Brevi particolari
    The sum of £76,081 deposited with ryder street properties limited (the deposit) together with all interest thereon accruing to the company pursuant to the provisions of the said deed.
    Persone aventi diritto
    • Ryder Street Properties Limited
    Transazioni
    • 21 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental debenture
    Creato il 25 apr 1996
    Consegnato il 07 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors (as defined in the credit agreement dated 21ST december, 1995) to the chargee under the terms of each finance document (as defined) to which any obligor is a party
    Brevi particolari
    (I) office buiding k/a key point great park road bradley stoke. (Ii) all buildings and fixtures on the property above. (Iii) the proceeds of sale of all or any part of the property specified in paragraphs (I) and (ii) (inclusive) above in the event that such property has not been released in accordance with clause 18 (release) of the original composite debenture (see ch microfiche for full details).
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank, N.A. (As Agent and Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 07 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed for cash deposit deed
    Creato il 19 feb 1996
    Consegnato il 24 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a lease of even date
    Brevi particolari
    The sum of £76,081.00 deposited with ryder street properties limited. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ryder Street Properties Limited
    Transazioni
    • 24 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite debenture
    Creato il 21 dic 1995
    Consegnato il 04 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of the obligors to the chargee under each finance document to which any obligor is a party (the "secured liabilities")
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank, N.A.(The "Security Trustee") as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 04 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0