EPISODE (GB) LIMITED

EPISODE (GB) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEPISODE (GB) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02413656
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EPISODE (GB) LIMITED?

    • (5242) /

    Dove si trova EPISODE (GB) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    12 Gleneagles Court
    Brighton Road
    RH10 6AD Crawley
    West Sussex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EPISODE (GB) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TOPPY U.K. LIMITED19 ott 198919 ott 1989
    BROOMCO (334) LIMITED16 ago 198916 ago 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di EPISODE (GB) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2004

    Quali sono le ultime deposizioni per EPISODE (GB) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 set 2010

    6 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    7 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 26 lug 2010

    7 pagine4.68

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    10 pagineLIQ MISC OC

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 26 gen 2010

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 26 lug 2009

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 26 gen 2009

    8 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 26 lug 2008

    6 pagine4.68

    Varie

    Sec/state release of liquidator
    1 pagineMISC

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    8 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    8 pagine4.68

    Varie

    C/O replacement liquidator
    15 pagineMISC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    21 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    21 pagine2.34B

    Dimissioni di un amministratore

    10 pagine2.38B

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo/aggiuntivo

    1 pagine2.40B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    18 pagine2.24B

    Risultato della riunione dei creditori

    3 pagine2.23B

    Dichiarazione delle attività

    6 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    31 pagine2.17B

    Chi sono gli amministratori di EPISODE (GB) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Segretario nominato
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    900021150001
    FANG, Jeffrey Fang
    27th Floor Block A Regent Centre
    63 Wo Yip Hop Road
    Kwai Chling New Territories
    Honk Kong
    Amministratore
    27th Floor Block A Regent Centre
    63 Wo Yip Hop Road
    Kwai Chling New Territories
    Honk Kong
    ChinaIrishMerchant40581680004
    FOSTER, Paul Geoffrey
    4 Kenwood Rise
    Bramley
    S66 3YE Rotherham
    South Yorkshire
    Amministratore
    4 Kenwood Rise
    Bramley
    S66 3YE Rotherham
    South Yorkshire
    United KingdomBritishSystems Director94392530001
    MAN, Christine Fang Ma Sau
    27th Floor Block A Regent Centre
    63 Wo Yip Hop Road
    Kwai Chung New Territories
    Hong Kong
    Amministratore
    27th Floor Block A Regent Centre
    63 Wo Yip Hop Road
    Kwai Chung New Territories
    Hong Kong
    Hong KongerCreative Director40581720003
    FIELDHOUSE, Nicholas John Carpmael
    18 Furzefield Road
    RH2 7HG Reigate
    Surrey
    Segretario
    18 Furzefield Road
    RH2 7HG Reigate
    Surrey
    U.K.74928500001
    CHUTER, Michael David
    167 Mottingham Road
    SE9 4SS London
    Amministratore
    167 Mottingham Road
    SE9 4SS London
    BritishCompany Director106296490001
    MCKEON, Mark David
    New Forest Gate House
    Lyndhurst
    SO43 7GR Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    New Forest Gate House
    Lyndhurst
    SO43 7GR Southampton
    Hampshire
    BritishRetail Director75187920001

    EPISODE (GB) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 18 feb 2002
    Consegnato il 01 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £12,737.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The company's right title and interest in and to the account in its name with the royal bank of scotland PLC (or such other bank as the landlord shall in its sole discretion decide) into which the deposit is from time to time paid.
    Persone aventi diritto
    • The Berkeley Festival Waterfront Company Limited
    Transazioni
    • 01 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 11 feb 2000
    Consegnato il 23 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease
    Brevi particolari
    The deposit account in to which the initial deposit of £11,441.56 has been placed.
    Persone aventi diritto
    • Baa Mcarthur/Glen (Swindon) Limited
    Transazioni
    • 23 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 apr 1998
    Consegnato il 07 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 19 nov 1996
    Consegnato il 20 nov 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to christ's hospital under the provision of a lease of premises known as 21 church street kingston surrey dated 9TH may 1989 and the said rent deposit deed
    Brevi particolari
    £16,250 deposited as security for all monies due under this deed.
    Persone aventi diritto
    • The Governors of Christ's Hospital
    Transazioni
    • 20 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of deposit
    Creato il 27 mar 1995
    Consegnato il 29 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a lease of even date
    Brevi particolari
    The interest of the company in the deposit account being a high interest bearing account opened in the name of coutts and company (guernsey) limited and tipaza limited with a london clearing bank. The deposit balance at the date of deed is £5,625.00.. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Coutts and Company (Guernsey) Limited
    Transazioni
    • 29 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 03 mar 1995
    Consegnato il 18 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the lease of even date and this charge
    Brevi particolari
    The company's interest in the interest earning deposit account with the initial deposit of £49,200 and all monies withdrawn from the account in accordance with the deed.
    Persone aventi diritto
    • The Crown Estate Commissionerson Behalf of Her Majesty Acting in Exercise of the Powers of the Crown
    Transazioni
    • 18 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 02 feb 1995
    Consegnato il 08 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £30,000.00
    Brevi particolari
    First fixed charge the company's interest in the amount secured by the charge (including interest) as a continuing security for due and prompt performance of the covenants and the warranty on the part of the company contained in a lease dated 2 february 1995 relating to unit LG2 city plaza, birmingham.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burford Acquisitions Limited
    Transazioni
    • 08 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed
    Creato il 15 apr 1994
    Consegnato il 27 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease of even date
    Brevi particolari
    £ 55,313 together with interest credited to the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ropemaker Properties Limited
    Transazioni
    • 27 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security deposit deed
    Creato il 18 giu 1993
    Consegnato il 09 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 8TH august 1986
    Brevi particolari
    The sum of £3,000 (the "deposit").
    Persone aventi diritto
    • Fogal of Switzerland (UK) Limited
    Transazioni
    • 09 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent security deposit deed
    Creato il 12 mar 1993
    Consegnato il 30 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date
    Brevi particolari
    £8,825 together with any interest credited to the deposit account (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Ropemaker Properties Limited
    Transazioni
    • 30 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent security deposit deed
    Creato il 17 feb 1993
    Consegnato il 22 feb 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease
    Brevi particolari
    The deposit of £110,627 together with all interest earned thereon.
    Persone aventi diritto
    • Ropemaker Properties Limited
    Transazioni
    • 22 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)

    EPISODE (GB) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    29 lug 2005Inizio dell'amministrazione
    27 lug 2006Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew John Tate
    Baker Tilly
    12 Gleneagles Court
    RH10 6AD Brighton Road
    Crawley West Sussex
    Praticante
    Baker Tilly
    12 Gleneagles Court
    RH10 6AD Brighton Road
    Crawley West Sussex
    John Ariel
    Baker Tilly
    12 Gleneagles Court
    RH10 6AD Brighton Road
    Crawley
    Praticante
    Baker Tilly
    12 Gleneagles Court
    RH10 6AD Brighton Road
    Crawley
    Karl Christopher Holmes
    Baker Tilly
    12 Gleneagles Court
    RH10 6AD Brighton Road
    Crawley West Sussex
    Praticante
    Baker Tilly
    12 Gleneagles Court
    RH10 6AD Brighton Road
    Crawley West Sussex
    2
    DataTipo
    27 lug 2006Inizio della liquidazione
    07 gen 2011Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John Ariel
    Baker Tilly
    12 Gleneagles Court
    RH10 6AD Brighton Road
    Crawley
    Praticante
    Baker Tilly
    12 Gleneagles Court
    RH10 6AD Brighton Road
    Crawley
    Karl Christopher Holmes
    Baker Tilly
    12 Gleneagles Court
    RH10 6AD Brighton Road
    Crawley West Sussex
    Praticante
    Baker Tilly
    12 Gleneagles Court
    RH10 6AD Brighton Road
    Crawley West Sussex
    Andrew White
    Baker Tilly
    First Floor International House
    BN1 3XE Queens Road
    Brighton
    Praticante
    Baker Tilly
    First Floor International House
    BN1 3XE Queens Road
    Brighton
    Matthew Richard Meadley Wild
    Baker Tilly The Clock House
    140 London Road
    GU1 1UW Guildford
    Surrey
    Praticante
    Baker Tilly The Clock House
    140 London Road
    GU1 1UW Guildford
    Surrey

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0