SPICER MCCOLL EASTERN LIMITED
Panoramica
Nome della società | SPICER MCCOLL EASTERN LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02414830 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SPICER MCCOLL EASTERN LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova SPICER MCCOLL EASTERN LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Colwyn House Sheepen Place CO3 3LD Colchester Essex |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SPICER MCCOLL EASTERN LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
SERIALGRADE LIMITED | 02 ott 1995 | 02 ott 1995 |
SPICER MCCOLL LIMITED | 07 giu 1990 | 07 giu 1990 |
METROPOLITAN CROWN LIMITED | 18 ago 1989 | 18 ago 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SPICER MCCOLL EASTERN LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per SPICER MCCOLL EASTERN LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 dic 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 dic 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 dic 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 dic 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 dic 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lucian Frank Erich Pollington come segretario in data 25 mag 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 dic 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 dic 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 gen 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Alick Smith il 30 gen 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2014 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2013 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di SPICER MCCOLL EASTERN LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMITH, Paul Alick | Amministratore | Sheepen Place CO3 3LD Colchester Colwyn House Essex United Kingdom | England | British | Director | 130934510056 | ||||
POLLINGTON, Lucian Frank Erich | Segretario | Sheepen Place CO3 3LD Colchester Colwyn House Essex United Kingdom | British | 68633210001 | ||||||
SMITH, Walter Alick | Segretario | Wellington House Butt Road CO3 3DA Colchester Essex | British | 60958290005 | ||||||
BEALES, Anthony David | Amministratore | 7 Naber Furlong Thorpe Marriott NR8 6XW Norwich Norfolk | British | Director | 34772080002 | |||||
CUPIT, Valerie Rosemary | Amministratore | 12a Kingsland Road West Mersea CO5 8RB Colchester | British | Company Director | 34772070001 | |||||
PALMER, John | Amministratore | Twin Pines Chappel Lane West Bergholt CO6 1JR Colchester Essex | British | Director Estate Agent | 34637850001 | |||||
SHELLEY, Jackie Anne | Amministratore | 3 The Coverts West Mersea CO5 8AW Colchester Essex | British | Company Director | 34772060001 | |||||
SMITH, Walter Alick | Amministratore | Wellington House Butt Road CO3 3DA Colchester Essex | British | Director | 60958290005 | |||||
STEWART, Gavin William Nicol | Amministratore | Cherrytrees Harkstead Road Lower Holbrook IP9 2RJ Ipswich Suffolk | England | British | Solicitor | 36038410001 | ||||
WOODARD, Julie Suzanne | Amministratore | 37 High Street Needham Market IP6 8AL Ipswich Suffolk | United Kingdom | British | Accountant | 52699150001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SPICER MCCOLL EASTERN LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
---|---|---|---|
Mr Paul Alick Smith | 06 apr 2016 | Sheepen Lane CO3 3LD Colchester Colwyn House Essex England | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
|
SPICER MCCOLL EASTERN LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit deed | Creato il 10 ott 2002 Consegnato il 31 ott 2002 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All the company's interest in the interest-bearing account maintained at barclays bank PLC, 50 pall mall, london SW1A 1AA (in the deposit account designated 9009423) by the solicitors for the time being appointed by the landlord. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite guarantee and debenture between the chargor, tmx corporation limited, the subsidiaries and winterthur finance limited | Creato il 13 dic 2001 Consegnato il 19 dic 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All liabilities due or to become due from the company or any of the chargors to the chargee pursuant to or in connection with the documents or this debenture (all terms defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 27 giu 2000 Consegnato il 06 lug 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All liabilities due or to become due from the company or any of the chargors to the chargee pursuant to or in connection with the documents or this debenture | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 16 ago 1996 Consegnato il 21 ago 1996 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee reserved by the lease dated 29TH march 1993 | |
Brevi particolari The sum of £7,250.00 held in an account at national westminster bank PLC stratford place branch london W1 in the name of the chargee. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 16 set 1995 Consegnato il 29 set 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 28 gen 1991 Consegnato il 04 feb 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 06 dic 1990 Consegnato il 11 dic 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H property k/a 64 regent street cambridge and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0