J. ROSENTHAL AND SON LIMITED

J. ROSENTHAL AND SON LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJ. ROSENTHAL AND SON LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02415151
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di J. ROSENTHAL AND SON LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso di prodotti tessili (46410) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova J. ROSENTHAL AND SON LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5 Tabley Court
    Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    Cheshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di J. ROSENTHAL AND SON LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    OPTWISE LIMITED21 ago 198921 ago 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di J. ROSENTHAL AND SON LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per J. ROSENTHAL AND SON LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 ott 2021

    9 pagineLIQ03

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    7 pagineLIQ10

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 16 ott 2020

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da PO Box 54 158 Bury Road Radcliffe Manchester M26 2JR a 5 Tabley Court Victoria Street Altrincham Cheshire WA14 1EZ in data 21 ott 2020

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 mar 2019

    36 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 nov 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 nov 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 16 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 mar 2018

    36 pagineAA

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2017 al 31 mar 2018

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 nov 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2016

    34 pagineAA

    Cessazione della carica di Alan Jamieson come amministratore in data 24 mar 2017

    2 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 nov 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Nomina di Alan Jamieson come amministratore in data 25 apr 2016

    3 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di J. ROSENTHAL AND SON LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CROLLA, Gillian Denise
    Brandish
    Sandhurst Drive
    SK9 2GP Wilmslow
    Cheshire
    Segretario
    Brandish
    Sandhurst Drive
    SK9 2GP Wilmslow
    Cheshire
    British67844560002
    CROLLA, Gillian Denise
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    England
    Amministratore
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    England
    EnglandBritish67844560002
    MCLOUGHLIN, Jacqueline Anne
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    Amministratore
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    United KingdomBritish151736120001
    POTTER, John Steven
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    Amministratore
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    EnglandBritish168496110001
    ROSENTHAL, Harry Ralph
    10 The Beeches
    Heald Road, Bowdon
    WA14 2HZ Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    10 The Beeches
    Heald Road, Bowdon
    WA14 2HZ Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish46809940002
    ANDERSON, Neil
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    Amministratore
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    EnglandBritish174453210001
    BAILEY, Keith Andrew
    Treetop Main Road
    Little Haywood
    ST18 0TR Stafford
    Amministratore
    Treetop Main Road
    Little Haywood
    ST18 0TR Stafford
    EnglandBritish77732780002
    CRIBB, James
    Pendeen
    28 Caldy Road
    CH48 2HG West Kirby
    Merseyside
    Amministratore
    Pendeen
    28 Caldy Road
    CH48 2HG West Kirby
    Merseyside
    United KingdomBritish15119750004
    HAMILTON, John Peter
    Harden Road
    BB18 6TS Kelbrook
    The Old Co-Op 1
    Amministratore
    Harden Road
    BB18 6TS Kelbrook
    The Old Co-Op 1
    EnglandBritish129084320001
    HENDERSON, Francis
    22 Ellendale Grange
    Worsley
    M28 7UX Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    22 Ellendale Grange
    Worsley
    M28 7UX Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritish31481280001
    HILLIER, Paul Christopher
    57 Pewterspear Green Road
    Appleton
    WA4 5FE Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    57 Pewterspear Green Road
    Appleton
    WA4 5FE Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish66065810001
    HOYLE, Jacqueline Diane
    7 Christchurch Lane
    Harwood
    BL2 3QF Bolton
    Amministratore
    7 Christchurch Lane
    Harwood
    BL2 3QF Bolton
    United KingdomBritish77098160002
    JAMIESON, Alan
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    Lancashire
    Amministratore
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    Lancashire
    EnglandBritish209414830001
    KINGSLEY, Andrew Robert
    PO BOX 54
    158 Bury Road
    M26 2JR Radcliffe
    Manchester
    Amministratore
    PO BOX 54
    158 Bury Road
    M26 2JR Radcliffe
    Manchester
    United KingdomBritish3974060003
    WHITTLE, Simon Robert
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    Amministratore
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    EnglandBritish151744120001

    Chi sono le persone con controllo significativo di J. ROSENTHAL AND SON LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Andrew Peter Rigby
    Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    5 Tabley Court
    Cheshire
    England
    07 apr 2016
    Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    5 Tabley Court
    Cheshire
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr Harry Ralph Rosenthal
    Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    5 Tabley Court
    Cheshire
    England
    07 apr 2016
    Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    5 Tabley Court
    Cheshire
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    J. ROSENTHAL AND SON LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal assignment
    Creato il 30 nov 2011
    Consegnato il 01 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 01 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 nov 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 24 nov 2011
    Consegnato il 26 nov 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transazioni
    • 26 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 nov 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge (all assets)
    Creato il 21 nov 2011
    Consegnato il 24 nov 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (the Security Holder)
    Transazioni
    • 24 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 nov 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 07 nov 2011
    Consegnato il 10 nov 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Britannia house 158 bury road radcliffe manchester t/n GM115898 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 10 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 nov 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 07 nov 2011
    Consegnato il 10 nov 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    219 bury road radcliffe t/no GM906491 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 10 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 nov 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 08 ott 2007
    Consegnato il 17 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mr Harry Ralph Ross
    Transazioni
    • 17 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 nov 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 27 lug 2001
    Consegnato il 02 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Prospect mill walter street blackburn lancashire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 05 gen 2000
    Consegnato il 08 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property being units 82, 83, 84 and 85 bison place moss side industrial estate leyland lancashire.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 apr 1999
    Consegnato il 20 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,000,000 and all other sums due from the company to the chargee pursuant to an agreement of even date
    Brevi particolari
    Prospect mill walter st,blackburn lancashire; la 609520; all fixtures/fittings,fixed plant/machinery thereon. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Rexmore PLC
    Transazioni
    • 20 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 24 dic 1996
    Consegnato il 02 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 158 bury road radcliffe manchester t/no 115898 and the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 15 mar 1996
    Consegnato il 26 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 nov 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 25 ott 1995
    Consegnato il 01 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 01 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 mar 1995
    Consegnato il 04 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed charge on book debts
    Creato il 10 ago 1994
    Consegnato il 17 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A) by way of first fixed charge all book debts and other debts. B). by way of first floating charge the premises described in (a) above if and insofar as the charges thereon or any part thereof shall for any reason be in eneffective as fixed charges.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Invoice Discounting Limited
    Transazioni
    • 17 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 feb 1994
    Consegnato il 18 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Bank of Pakistan Limited
    Transazioni
    • 18 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 ott 1989
    Consegnato il 08 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 07 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    J. ROSENTHAL AND SON LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 dic 2022Data prevista di scioglimento
    16 ott 2020Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Michael Simister
    5 Tabley Court Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    Cheshire
    Praticante
    5 Tabley Court Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    Cheshire
    Neil Henry
    5 Tabley Court Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    Cheshire
    Praticante
    5 Tabley Court Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    Cheshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0