WHITE HOUSE LAND LIMITED
Panoramica
| Nome della società | WHITE HOUSE LAND LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02418248 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di WHITE HOUSE LAND LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova WHITE HOUSE LAND LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Two Snowhill Snow Hill Queensway B4 6GA Birmingham |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di WHITE HOUSE LAND LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MONTIJO LIMITED | 30 ago 1989 | 30 ago 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di WHITE HOUSE LAND LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per WHITE HOUSE LAND LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 14 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Gate House Turnpike Road High Wycombe Buckinghamshire HP12 3NR a Two Snowhill Snow Hill Queensway Birmingham B4 6GA in data 07 nov 2017 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 2 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Colin Richard Clapham come segretario in data 05 dic 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh come segretario in data 05 dic 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 nov 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 42-50 Hersham Road Walton-on-Thames Surrey KT12 1RZ | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Robert Andrew come amministratore in data 17 lug 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Colin Richard Clapham come amministratore in data 17 lug 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Thames House Portsmouth Road Esher Surrey KT10 9AD United Kingdom a 42-50 Hersham Road Walton-on-Thames Surrey KT12 1RZ | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 nov 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 nov 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 nov 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Colin Richard Clapham come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Karen Atterbury come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 nov 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di WHITE HOUSE LAND LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Segretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 219964550001 | |||||||
| CLAPHAM, Colin Richard | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 9684390001 | |||||
| LONNON, Michael Andrew, Mr. | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 34521340004 | |||||
| ATTERBURY, Karen Lorraine | Segretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | British | 175715660001 | ||||||
| CARR, Peter Anthony | Segretario | South Luffenham LE15 8NP Rutland Foxfoot House | British | 130306120001 | ||||||
| CLAPHAM, Colin Richard | Segretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 165966510001 | |||||||
| DE FEO, Caterina | Segretario | 42 The Crescent Hampton In Arden B92 0BP Solihull West Midlands | British | 58246930001 | ||||||
| GEORGE, David Stephen | Segretario | 20 Crail Close RG11 2PZ Wokingham Berkshire | British | 6192540001 | ||||||
| HASTINGS, Jonathan Philip | Segretario | 7 Hanger Court Hanger Green W5 3ER London | British | 4733610001 | ||||||
| JORDAN, James John | Segretario | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | 120602100002 | ||||||
| O'NEILL, Derek Patrick | Segretario | Oakley House, Verley Close Woughton On The Green MK6 3ER Milton Keynes | British | 87909140001 | ||||||
| ANDREW, Peter Robert | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 113503830003 | |||||
| CARNEY, Christopher | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 125216670001 | |||||
| CRAY, Jonathan Malcolm | Amministratore | 60 Starbold Crescent Knowle B93 9JX Solihull West Midlands | England | British | 70470020001 | |||||
| DENNISON, John Patrick Edmund | Amministratore | 21 Linton Avenue B91 3NN Solihull West Midlands | British | 14008270001 | ||||||
| GABB, Colin | Amministratore | 23 Little Fryth RG40 3RN Wokingham Berkshire | England | British | 87309290001 | |||||
| GEORGE, David Stephen | Amministratore | 20 Crail Close RG11 2PZ Wokingham Berkshire | British | 6192540001 | ||||||
| HOLLIDAY, Peter David | Amministratore | 1 Tamdown Way CM7 2QL Braintree Essex | United Kingdom | British | 78225380001 | |||||
| MURRIN, Jonathan Charles | Amministratore | 10 Silhill Hall Road B91 1JU Solihull West Midlands | British | 115863170001 | ||||||
| PEACOCK, Raymond Anthony | Amministratore | 9 Grosvenor Road Finchley N3 1EY London | United Kingdom | British | 75750250002 | |||||
| POTTON, Geoffrey Frederick | Amministratore | Abbotswood Monkmead Lane RH20 2PF West Chiltington West Sussex | British | 60928380003 | ||||||
| SMITH, Nicholas Carey | Amministratore | 32 Chattock Avenue B91 2QX Solihull West Midlands | British | 38140140004 | ||||||
| WATTS, Christopher Philip | Amministratore | Halycon Lodge Field Close Ufton CV33 9PH Leamington Spa Warwickshire | British | 83391430001 | ||||||
| WESTHORPE, Peter Leslie | Amministratore | Wychbury Powntley Copse GU34 4DL Alton Hampshire | United Kingdom | British | 13405640001 | |||||
| WHITE, David Douglas Percival | Amministratore | Botley House Tanworth Lane B95 5QY Henley In Arden Warwickshire | British | 79564790001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di WHITE HOUSE LAND LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admiral Homes Limited | 06 apr 2016 | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
WHITE HOUSE LAND LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 26 gen 1994 Consegnato il 11 feb 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the company to national westminster bank PLC, as trustee for the finance parties (as defined) under or pursuant to the terms of the finance documents (as defined) and/or this charge, | |
Brevi particolari Please see doc for further details,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge. | Creato il 26 gen 1994 Consegnato il 11 feb 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to national westminster bank PLC, as agent and trustee for the finance parties (as defined) under or pursuant to the terms of the charge, | |
Brevi particolari Land on the south side of sandhills lane, virginia water ,land on the ethy copse,cove, land on the south side of drake road, chafford hundred,grays. Please see doc for further details,. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 16 giu 1992 Consegnato il 29 giu 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the finance documents (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed charge | Creato il 16 giu 1992 Consegnato il 25 giu 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the company to national westmisnter bank PLC (as agent for and on behalf of the finance parties -as defined) pursuant to the terms of the finance documents and/or this charge | |
Brevi particolari All that one metre strip of land at ethy copse on the north side of fleet road,cove farnborough .title no hp 433799. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed charge | Creato il 16 giu 1992 Consegnato il 25 giu 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the company to national westminster bank PLC (as agent for and on behalf of the finance parties (as defined) pursuant to the terms of the finance documents and/or this charge. | |
Brevi particolari All that strip of land on the south side of sandhills lane,virginia water,runneymede, title no sy 608175. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed charge | Creato il 16 giu 1992 Consegnato il 25 giu 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the company to national westminster bank PLC (as agent for and on behalf of the finance parties (as defined) under the terms of the finance documents (as defined) and /or this charge. | |
Brevi particolari All that strip of land within the former parcel 17 , chafford hundred ,thurrock. Title no ex 422193. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 09 apr 1990 Consegnato il 14 apr 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a credit agreement dated 17-7-89 and this charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
WHITE HOUSE LAND LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0