CLINICAL ENERGY LIMITED

CLINICAL ENERGY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCLINICAL ENERGY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02420459
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CLINICAL ENERGY LIMITED?

    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova CLINICAL ENERGY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Indigo House
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CLINICAL ENERGY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FLYCATCHERS INVESTMENTS LIMITED 06 set 198906 set 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di CLINICAL ENERGY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per CLINICAL ENERGY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 08 giu 2020

    • Capitale: GBP 0.000001
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    5 pagineAA

    Nomina di Mr Daniel Ginnetti come amministratore in data 08 feb 2019

    2 pagineAP01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    To be appointed as a dirtecor 07/02/2019
    RES13

    Cessazione della carica di Robert John Guice come amministratore in data 08 feb 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di John Paul Johnston come amministratore in data 01 ott 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Robert John Guice come amministratore in data 01 ott 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 set 2015

    Stato del capitale al 29 set 2015

    • Capitale: GBP 8,481,119
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Fransiscus Johannes Maria Ten Brink come amministratore in data 04 dic 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 19 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 ott 2014

    Stato del capitale al 07 ott 2014

    • Capitale: GBP 8,481,119
    SH01

    Chi sono gli amministratori di CLINICAL ENERGY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GINNETTI, Daniel V
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United StatesAmerican193541820001
    BLYDE, William David
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    British11292060003
    GRAVER, Neville
    70 Beechwood Lawns
    IRISH Rathcoole
    County Dublin
    Segretario
    70 Beechwood Lawns
    IRISH Rathcoole
    County Dublin
    Irish94189330001
    LLOYD, David Alan
    Floor, Apex House London Road
    DA11 9PD Northfleet
    2nd
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Floor, Apex House London Road
    DA11 9PD Northfleet
    2nd
    Kent
    United Kingdom
    British155636220001
    LLOYD, David Alan
    Apex House
    London Road
    DA11 9PD Northfleet
    2nd Floor
    Kent
    Uk
    Segretario
    Apex House
    London Road
    DA11 9PD Northfleet
    2nd Floor
    Kent
    Uk
    British156971630001
    TAYLOR, Richard
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    British106228180001
    BAIG, Mirza Nizam
    Highfield House
    Station Road, Norton
    DN6 9HF Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Highfield House
    Station Road, Norton
    DN6 9HF Doncaster
    South Yorkshire
    British53472630002
    BLYDE, William David
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    British11292060003
    BRANDEL, Elizabeth
    N. Sheridan Rd
    Lake Forest
    1020
    Illinois 60045
    Usa
    Amministratore
    N. Sheridan Rd
    Lake Forest
    1020
    Illinois 60045
    Usa
    UsaUsa115854300002
    GUICE, Robert John
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United KingdomBritish203379250001
    HANCOCK, John Reginald
    Early Spring
    London Road Allostock
    WA16 9LJ Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Early Spring
    London Road Allostock
    WA16 9LJ Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish109081260001
    HARRISON, George Michael
    10 Martineau Close
    KT10 9PW Esher
    Surrey
    Amministratore
    10 Martineau Close
    KT10 9PW Esher
    Surrey
    Australian1835160001
    JOHNSTON, John Paul
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    IrelandIrish162398480001
    LLOYD, David Alan
    Floor, Apex House London Road
    DA11 9PD Northfleet
    2nd
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor, Apex House London Road
    DA11 9PD Northfleet
    2nd
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish155636220001
    O'BRIEN, James Patrick
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    American106228260001
    ROBINSON, Malcolm George
    5 Shearers Close
    Grove Green
    ME14 5UQ Maidstone
    Kent
    Amministratore
    5 Shearers Close
    Grove Green
    ME14 5UQ Maidstone
    Kent
    British44360890001
    ROGERS, Desmond
    Eastham House
    Eastham Road
    IRISH Bettystown
    County Meath
    Ireland
    Amministratore
    Eastham House
    Eastham Road
    IRISH Bettystown
    County Meath
    Ireland
    Republic Of IrelandIrish144329600001
    SACRANIE, Shazeen Sattar
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    American98272430003
    SIMPSON, John Robert
    Rylagh Southview Road
    TN6 1HG Crowborough
    East Sussex
    Amministratore
    Rylagh Southview Road
    TN6 1HG Crowborough
    East Sussex
    British5199570001
    SIMPSON, Paul
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish113998010002
    TEN BRINK, Fransiscus Johannes Maria
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    UsaAmerican98751560001
    THOMAS, David Lloyd
    9 Williams Way
    Longwick
    HP27 9RP Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Amministratore
    9 Williams Way
    Longwick
    HP27 9RP Princes Risborough
    Buckinghamshire
    British73623570001
    WALL, Niall
    3 Dunboy
    Brighton Road
    IRISH Foxrock
    Dublin 18
    Ireland
    Amministratore
    3 Dunboy
    Brighton Road
    IRISH Foxrock
    Dublin 18
    Ireland
    Irish94189180002
    WARD, Ian Geoffrey, Dr
    10 Conifer Avenue
    Hartley
    DA3 8BX Longfield
    Kent
    Amministratore
    10 Conifer Avenue
    Hartley
    DA3 8BX Longfield
    Kent
    British11292070001
    WILKINS, Andrew David
    50 Green Street
    Chorleywood
    WD3 5QR Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    50 Green Street
    Chorleywood
    WD3 5QR Rickmansworth
    Hertfordshire
    British55199210001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CLINICAL ENERGY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    England
    06 apr 2016
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3487700
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    CLINICAL ENERGY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Subordination deed
    Creato il 30 apr 2004
    Consegnato il 18 mag 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any borrower (including the company) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    In consideration of the bank giving time or credit or banking facilities to the borrowers, each subordinated creditor agrees that the subordinated obligations shall in all respects be subordinated to the senior obligations. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 18 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Subordination deed
    Creato il 30 apr 2004
    Consegnato il 18 mag 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company will not unless otherwise agreed in writing by the bank secure all or part of the subordinated obligations. Pay, prepay redeem purchase or otherwise discharge or release any of the subordinated obligations in cash or otherwise. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 18 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 13 mar 1998
    Consegnato il 26 mar 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 26 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Debenture
    Creato il 13 mar 1998
    Consegnato il 20 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this debenture
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 20 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 ott 1993
    Consegnato il 18 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 13 september 1993
    Brevi particolari
    All f/h l/h or other immovable property and buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery and book debts and a floating charge over all undertaking property and assets of of the company.
    Persone aventi diritto
    • Blue Circle Industries PLC
    Transazioni
    • 18 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 ott 1993
    Consegnato il 18 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £3204 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Blue Circle Industries PLC
    Transazioni
    • 18 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0