CLINICAL ENERGY LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CLINICAL ENERGY LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02420459 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CLINICAL ENERGY LIMITED?
- Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi
Dove si trova CLINICAL ENERGY LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Indigo House Sussex Avenue LS10 2LF Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CLINICAL ENERGY LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| FLYCATCHERS INVESTMENTS LIMITED | 06 set 1989 | 06 set 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CLINICAL ENERGY LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per CLINICAL ENERGY LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 08 giu 2020
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Daniel Ginnetti come amministratore in data 08 feb 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Robert John Guice come amministratore in data 08 feb 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di John Paul Johnston come amministratore in data 01 ott 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Robert John Guice come amministratore in data 01 ott 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 set 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Fransiscus Johannes Maria Ten Brink come amministratore in data 04 dic 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 set 2014 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di CLINICAL ENERGY LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GINNETTI, Daniel V | Amministratore | Sussex Avenue LS10 2LF Leeds Indigo House West Yorkshire | United States | American | 193541820001 | |||||
| BLYDE, William David | Segretario | Pannell House 6 Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | British | 11292060003 | ||||||
| GRAVER, Neville | Segretario | 70 Beechwood Lawns IRISH Rathcoole County Dublin | Irish | 94189330001 | ||||||
| LLOYD, David Alan | Segretario | Floor, Apex House London Road DA11 9PD Northfleet 2nd Kent United Kingdom | British | 155636220001 | ||||||
| LLOYD, David Alan | Segretario | Apex House London Road DA11 9PD Northfleet 2nd Floor Kent Uk | British | 156971630001 | ||||||
| TAYLOR, Richard | Segretario | Pannell House 6 Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | British | 106228180001 | ||||||
| BAIG, Mirza Nizam | Amministratore | Highfield House Station Road, Norton DN6 9HF Doncaster South Yorkshire | British | 53472630002 | ||||||
| BLYDE, William David | Amministratore | Pannell House 6 Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | British | 11292060003 | ||||||
| BRANDEL, Elizabeth | Amministratore | N. Sheridan Rd Lake Forest 1020 Illinois 60045 Usa | Usa | Usa | 115854300002 | |||||
| GUICE, Robert John | Amministratore | Sussex Avenue LS10 2LF Leeds Indigo House West Yorkshire | United Kingdom | British | 203379250001 | |||||
| HANCOCK, John Reginald | Amministratore | Early Spring London Road Allostock WA16 9LJ Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | 109081260001 | |||||
| HARRISON, George Michael | Amministratore | 10 Martineau Close KT10 9PW Esher Surrey | Australian | 1835160001 | ||||||
| JOHNSTON, John Paul | Amministratore | Sussex Avenue LS10 2LF Leeds Indigo House West Yorkshire United Kingdom | Ireland | Irish | 162398480001 | |||||
| LLOYD, David Alan | Amministratore | Floor, Apex House London Road DA11 9PD Northfleet 2nd Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 155636220001 | |||||
| O'BRIEN, James Patrick | Amministratore | Pannell House 6 Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | American | 106228260001 | ||||||
| ROBINSON, Malcolm George | Amministratore | 5 Shearers Close Grove Green ME14 5UQ Maidstone Kent | British | 44360890001 | ||||||
| ROGERS, Desmond | Amministratore | Eastham House Eastham Road IRISH Bettystown County Meath Ireland | Republic Of Ireland | Irish | 144329600001 | |||||
| SACRANIE, Shazeen Sattar | Amministratore | Pannell House 6 Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | American | 98272430003 | ||||||
| SIMPSON, John Robert | Amministratore | Rylagh Southview Road TN6 1HG Crowborough East Sussex | British | 5199570001 | ||||||
| SIMPSON, Paul | Amministratore | Pannell House 6 Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 113998010002 | |||||
| TEN BRINK, Fransiscus Johannes Maria | Amministratore | Sussex Avenue LS10 2LF Leeds Indigo House West Yorkshire United Kingdom | Usa | American | 98751560001 | |||||
| THOMAS, David Lloyd | Amministratore | 9 Williams Way Longwick HP27 9RP Princes Risborough Buckinghamshire | British | 73623570001 | ||||||
| WALL, Niall | Amministratore | 3 Dunboy Brighton Road IRISH Foxrock Dublin 18 Ireland | Irish | 94189180002 | ||||||
| WARD, Ian Geoffrey, Dr | Amministratore | 10 Conifer Avenue Hartley DA3 8BX Longfield Kent | British | 11292070001 | ||||||
| WILKINS, Andrew David | Amministratore | 50 Green Street Chorleywood WD3 5QR Rickmansworth Hertfordshire | British | 55199210001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CLINICAL ENERGY LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bfh Group Ltd | 06 apr 2016 | Sussex Avenue LS10 2LF Leeds Indigo House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CLINICAL ENERGY LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Subordination deed | Creato il 30 apr 2004 Consegnato il 18 mag 2004 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from any borrower (including the company) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari In consideration of the bank giving time or credit or banking facilities to the borrowers, each subordinated creditor agrees that the subordinated obligations shall in all respects be subordinated to the senior obligations. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Subordination deed | Creato il 30 apr 2004 Consegnato il 18 mag 2004 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The company will not unless otherwise agreed in writing by the bank secure all or part of the subordinated obligations. Pay, prepay redeem purchase or otherwise discharge or release any of the subordinated obligations in cash or otherwise. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 13 mar 1998 Consegnato il 26 mar 1998 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 13 mar 1998 Consegnato il 20 mar 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this debenture | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 11 ott 1993 Consegnato il 18 ott 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 13 september 1993 | |
Brevi particolari All f/h l/h or other immovable property and buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery and book debts and a floating charge over all undertaking property and assets of of the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 11 ott 1993 Consegnato il 18 ott 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £3204 due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0