OHI WILLOWMEAD LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOHI WILLOWMEAD LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02423345
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OHI WILLOWMEAD LTD?

    • Strutture residenziali di assistenza infermieristica (87100) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova OHI WILLOWMEAD LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Tower 42 25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OHI WILLOWMEAD LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GCH (WILLOWMEAD) LIMITED20 giu 200520 giu 2005
    WICKHAM BISHOPS NURSING HOME LIMITED18 apr 199018 apr 1990
    CANTERCREST LIMITED18 set 198918 set 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di OHI WILLOWMEAD LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per OHI WILLOWMEAD LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2017

    20 pagineAA

    legacy

    45 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 22 nov 2018

    • Capitale: GBP 1.00
    5 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduction of share premium 22/11/2018
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 set 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 10 mag 2017

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 set 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name23 giu 2017

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 16 giu 2017

    RES15

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 10 mag 2018 al 31 dic 2017

    1 pagineAA01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Stephenson il 12 mag 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Ritz il 12 mag 2017

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Sukhvinder Singh Gidar come amministratore in data 11 mag 2017

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Daniel Booth il 12 mag 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Daniel Booth il 12 mag 2017

    1 pagineCH03

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mar 2017 al 10 mag 2017

    1 pagineAA01

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 024233450011 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di OHI WILLOWMEAD LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BOOTH, Daniel
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    Segretario
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    231352570001
    BOOTH, Daniel James
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    Amministratore
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    United StatesAmericanChief Operating Officer265749890001
    RITZ, Michael Daniel
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    Amministratore
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    United StatesAmericanChief Accounting Officer231342520001
    STEPHENSON, Robert
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    Amministratore
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    United StatesAmericanChief Financial Officer196594350001
    GIDAR, Sukhvinder Singh
    13 The Crossway
    UB10 0JH Uxbridge
    Gidar House
    Middx
    Segretario
    13 The Crossway
    UB10 0JH Uxbridge
    Gidar House
    Middx
    BritishPharmacist96428270001
    PURI, Ramesh Kumar, Dr
    12 Holt Drive
    Wickham Bishops
    CM8 3JR Witham
    Essex
    Segretario
    12 Holt Drive
    Wickham Bishops
    CM8 3JR Witham
    Essex
    Indian17115860001
    GIDAR, Jaskiran Kaur
    13 The Crossway
    UB10 0JH Uxbridge
    Gidar House
    Middx
    Amministratore
    13 The Crossway
    UB10 0JH Uxbridge
    Gidar House
    Middx
    EnglandBritishCompany Director96020490001
    GIDAR, Jaskiran Kaur
    Iver Garden
    Wood Lane
    SL0 0LA Iver
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Iver Garden
    Wood Lane
    SL0 0LA Iver
    Buckinghamshire
    EnglandBritishTeacher96020490001
    GIDAR, Ravinder Singh
    13 The Crossway
    UB10 0JH Uxbridge
    Gidar House
    Middx
    Amministratore
    13 The Crossway
    UB10 0JH Uxbridge
    Gidar House
    Middx
    United KingdomBritishPharmacist90832190001
    GIDAR, Sheetal Kaur
    13 The Crossway
    UB10 0JH Uxbridge
    Gidar House
    Middx
    Amministratore
    13 The Crossway
    UB10 0JH Uxbridge
    Gidar House
    Middx
    EnglandBritishCompany Director96322440001
    GIDAR, Sheetal Kaur
    Campden Cottage
    Billet Lane
    SL0 0LS Iver
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Campden Cottage
    Billet Lane
    SL0 0LS Iver
    Buckinghamshire
    EnglandBritishMidwife96322440001
    GIDAR, Sukhvinder Singh
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    England
    Amministratore
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    England
    United KingdomBritishPharmacist96428270001
    PURI, Geeta
    12 Holt Drive
    Wickham Bishops
    CM8 3JR Witham
    Essex
    Amministratore
    12 Holt Drive
    Wickham Bishops
    CM8 3JR Witham
    Essex
    Indian30751790001
    PURI, Ramesh Kumar, Dr
    12 Holt Drive
    Wickham Bishops
    CM8 3JR Witham
    Essex
    Amministratore
    12 Holt Drive
    Wickham Bishops
    CM8 3JR Witham
    Essex
    United KingdomIndianDoctor17115860001
    SHIRODARIA, Chamiak Vithaldas, Dr (Mr)
    Queens Crawley Beacon Hill
    Wickham Bishops
    CM8 3EA Witham
    Essex
    Amministratore
    Queens Crawley Beacon Hill
    Wickham Bishops
    CM8 3EA Witham
    Essex
    BritishMedical General Practitioner30751770001
    SHIRODARIA, Suuarna Champak, Doctor
    Queens Crawley Beacon Hill
    Wickham Bishops
    CM8 3EA Witham
    Essex
    Amministratore
    Queens Crawley Beacon Hill
    Wickham Bishops
    CM8 3EA Witham
    Essex
    BritishMedical General Practioner36812790001

    Chi sono le persone con controllo significativo di OHI WILLOWMEAD LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Crossway
    UB10 0JH Uxbridge
    13 Crossway
    United Kingdom
    England
    06 apr 2016
    The Crossway
    UB10 0JH Uxbridge
    13 Crossway
    United Kingdom
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione5162922
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    OHI WILLOWMEAD LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 30 ott 2015
    Consegnato il 06 nov 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 nov 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 17 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 21 ott 2015
    Consegnato il 23 ott 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    F/H cooperative villas the green hatfield peverel chelmsford t/no EX574681.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 17 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 05 feb 2009
    Consegnato il 17 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 07 mar 2006
    Consegnato il 09 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 1 cooperative villas maldon road hatfield peveral chelmsford essex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 09 feb 2004
    Consegnato il 20 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property being willowmead residential home wickham bishops hatfield peverel chelmsford essex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 02 feb 2004
    Consegnato il 06 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 31 gen 1995
    Consegnato il 06 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a pleyhill farm, wickham bishops road, hatfield peveral essex t/no: EX403019 and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 27 gen 1995
    Consegnato il 13 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 21 apr 1992
    Consegnato il 08 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Wickham bishops nursing home (formerly k/a pleyhill farm) wickham bishops rd,hatfield peverel,chelmsford,essex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 apr 1992
    Consegnato il 07 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £675,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H wickham bishops nursing home wickham bishops road,hatfield peverel chelmsfor,essex fixed charge over f/h property all buildings fixtures trade fixtures fixed plant and machinery goodwill of the business.
    Persone aventi diritto
    • Citibank Trust Limited
    Transazioni
    • 07 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 apr 1992
    Consegnato il 30 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Citibank Trust Limited
    Transazioni
    • 30 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0