COUNTY & SUBURBAN HOLDINGS LIMITED

COUNTY & SUBURBAN HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOUNTY & SUBURBAN HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02424283
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COUNTY & SUBURBAN HOLDINGS LIMITED?

    • (7020) /
    • (7415) /

    Dove si trova COUNTY & SUBURBAN HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o BEGBIES TRAYNOR (CENTRAL) LLP
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COUNTY & SUBURBAN HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ESTATES & GENERAL PROPERTIES LIMITED22 gen 199022 gen 1990
    FEASTLAND LIMITED19 set 198919 set 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di COUNTY & SUBURBAN HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per COUNTY & SUBURBAN HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    20 pagineLIQ14

    Cessazione della carica di Reit (Corporate Services) Limited come segretario in data 08 ago 2017

    2 pagineTM02

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 gen 2017

    19 pagine4.68

    Cessazione della carica di Christopher George White come amministratore in data 11 apr 2016

    2 pagineTM01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 gen 2016

    19 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 gen 2015

    18 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Begbies Traynor 32 Cornhill London EC3V 3BT England a C/O Begbies Traynor (Central) Llp 31St Floor 40 Bank Street London E14 5NR in data 26 set 2014

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 gen 2014

    18 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 gen 2013

    19 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 gen 2012

    17 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    6 pagine4.20

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da * 5 Wigmore Street London W1U 1PB United Kingdom* in data 17 gen 2011

    1 pagineAD01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 mar 2010 al 30 mar 2010

    3 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 09 lug 2010

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 ago 2010

    Stato del capitale al 17 ago 2010

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Christopher George White il 01 mag 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Maurice Moses Benady il 01 mag 2010

    3 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    14 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine287

    Chi sono gli amministratori di COUNTY & SUBURBAN HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BENADY, Maurice Moses
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Amministratore
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Amministratore
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    135316290001
    HOLLAND, Philip John
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    Segretario
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    British74688330002
    ROBERTS, Geoffrey Michael
    Brenchley 8 Hamilton Road
    DA15 7HB Sidcup
    Kent
    Segretario
    Brenchley 8 Hamilton Road
    DA15 7HB Sidcup
    Kent
    British29217560001
    WHITE, Christine
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    British74900200002
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Segretario
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    79571870001
    BLOOMFIELD, David William
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    Amministratore
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    British7927670001
    CLEGG, Barry Stuart
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish11296610002
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    DOSSETT, Roger John
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish116927100001
    HOLLAND, Philip John
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritish163838050001
    LONGMAN, Karen Sarah
    14b Alexandra Mansions
    West End Lane
    NW6 1LU London
    Amministratore
    14b Alexandra Mansions
    West End Lane
    NW6 1LU London
    British29163610001
    MALONE, Kenneth Daniel
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British60687110001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Amministratore
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Amministratore
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    COUNTY & SUBURBAN HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 15 set 2004
    Consegnato il 29 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all of the chargor's rights to and title and interest from time to time in the real properties specified in part iii of schedule 2. by way of floating charge (I) the whole of its assets, present and future and (ii) the whole of its assets situated in scotland.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hypo Real Estate Bank International (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 29 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Sixth supplemental trust deed
    Creato il 18 feb 2003
    Consegnato il 25 feb 2003
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Axa Insurance PLC
    Transazioni
    • 25 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Deed of release and substitution
    Creato il 01 set 2000
    Consegnato il 05 set 2000
    In corso
    Importo garantito
    The principal of and interest on the £3,000,000 12.4% first mortgage debenture stock 2008 and the £18,000,000 11.25% first mortgage debenture stock 2018 of estates & general PLC and all other monies intended to be secured by the deed and by the deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    F/H property k/a units a B1 and B2 foundry lane horsham t/n WSX46889 together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery and all imporovements and additions thereto subject to and with the benefit of all leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants and conditions affecting the same.
    Persone aventi diritto
    • Axa Insurance PLC
    Transazioni
    • 05 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Creato il 04 ago 1992
    Consegnato il 19 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the composite guarantee and mortgage debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    COUNTY & SUBURBAN HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    21 gen 2011Inizio della liquidazione
    21 mag 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Kirstie Jane Provan
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Praticante
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Mark Robert Fry
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Praticante
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0