ULTRASIS UK LIMITED
Panoramica
Nome della società | ULTRASIS UK LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02425966 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ULTRASIS UK LIMITED?
- Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
Dove si trova ULTRASIS UK LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Kpmg Llp 1 St Peters Square M2 3AE Manchester |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ULTRASIS UK LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ULTRAMIND LIMITED | 19 giu 1992 | 19 giu 1992 |
SUPERMIND LIMITED | 10 dic 1991 | 10 dic 1991 |
SUPERMINDS LIMITED | 20 ott 1989 | 20 ott 1989 |
RISEPHASE LIMITED | 25 set 1989 | 25 set 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ULTRASIS UK LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 lug 2014 |
Quali sono le ultime deposizioni per ULTRASIS UK LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione | 23 pagine | AM23 | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore | 23 pagine | AM10 | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore | 21 pagine | AM10 | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 16 mar 2017 | 20 pagine | 2.24B | ||||||||||
Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione | 1 pagine | 2.31B | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 ott 2016 | 21 pagine | 2.24B | ||||||||||
Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione | 8 pagine | 2.31B | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 apr 2016 | 23 pagine | 2.24B | ||||||||||
Notifica di approvazione tacita delle proposte | 1 pagine | F2.18 | ||||||||||
Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B/2.15B | 11 pagine | 2.16B | ||||||||||
Dichiarazione della proposta dell'amministratore | 51 pagine | 2.17B | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 23 York Road London SE1 7NJ a Kpmg Llp 1 st Peters Square Manchester M2 3AE in data 06 nov 2015 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un amministratore | 1 pagine | 2.12B | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 lug 2014 | 18 pagine | AA | ||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 ott 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di John Kingsley Martin come amministratore in data 31 mag 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Screenetics Unit 631 Hayley Court Linford Wood Milton Keynes MK14 6GD England a 23 York Road London SE1 7NJ in data 16 set 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mr Alan Mark Kershaw come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Penelope Tembra come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Alan Mark Kershaw come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 lug 2013 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Unit 600 Milton Keynes Business Centre Foxhunter Drive Linford Wood Milton Keynes MK14 6GD England* in data 30 gen 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ULTRASIS UK LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KERSHAW, Alan Mark | Segretario | 1 St Peters Square M2 3AE Manchester Kpmg Llp | 189061630001 | |||||||||||||||
KERSHAW, Alan Mark | Amministratore | 1 St Peters Square M2 3AE Manchester Kpmg Llp | United Kingdom | British | Company Director | 152734000001 | ||||||||||||
SMITH, John Frederick | Amministratore | 1 St Peters Square M2 3AE Manchester Kpmg Llp | United Kingdom | British | Director | 178918390001 | ||||||||||||
BOYLE, Stephen Laurence | Segretario | 57 Canfield Road IG8 8JJ Woodford Bridge Essex | British | 82138320001 | ||||||||||||||
BRISTOW, Gordon Francis | Segretario | 56 Manton Road SE2 0JB London | English | 4153600001 | ||||||||||||||
JOLLIFFE, Valerie Celia | Segretario | 13 Crediton Hill NW6 1HT London | British | Consultant | 50917990001 | |||||||||||||
MEHTA, Ashoni Kumar | Segretario | 40 Tangier Road TW10 5DW Richmond Surrey | British | Accountant | 66703220001 | |||||||||||||
MILLS, Michael John | Segretario | Maple Heath Parsonage Lane Farnham Common SL2 3NZ Slough Berkshire | British | 34628600001 | ||||||||||||||
ORBACH, Tuvi, Mr. | Segretario | 5 Ravenscroft Avenue Golders Green NW11 0SA London | British | 17074010001 | ||||||||||||||
PHILIPOSE, Roy Joseph | Segretario | 7 Hawkesfield Road Forest Hill SE23 2TN London | Indian | 52698290001 | ||||||||||||||
PORTER, Michael William | Segretario | 30 Winterdown Road KT10 8LJ Esher Surrey | British | 86626150001 | ||||||||||||||
TEMBRA, Penelope Julie | Segretario | c/o Screenetics Hayley Court Linford Wood MK14 6GD Milton Keynes Unit 631 England | 151882310001 | |||||||||||||||
MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Segretario | London Wall EC2Y 5AB London One United Kingdom |
| 116685100001 | ||||||||||||||
SECRETARIAL SOLUTIONS LIMITED | Segretario | One London Wall EC2Y 5AB London | 81435090009 | |||||||||||||||
ADAMS, David Howard | Amministratore | 6 Albion Street W2 2AS London | England | British | Management Consultant | 42816720003 | ||||||||||||
BRABBINS, Nigel | Amministratore | Beech House Overthorpe OX17 2AE Banbury Oxfordshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 49876000002 | ||||||||||||
GOLDMAN, Alan David | Amministratore | 13 Fernville Road Gosforth NE3 4HT Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | Company Chairman | 6042060001 | |||||||||||||
HARRIS, Ralph Stephen | Amministratore | Old Tiles Westwood Road GU20 6NB Windlesham Surrey | England | British | Company Director | 3131600002 | ||||||||||||
KORENMAN, Ernesto | Amministratore | 91 Thirlmere Road HA9 8BD Wembley Middlesex | British | Researcher | 17074020002 | |||||||||||||
LEWIS, Graham Robert | Amministratore | 32 Ernest Road Wivenhoe CO7 9LQ Colchester Essex | British | Company Director | 117396680001 | |||||||||||||
MARTIN, John Kingsley, Dr | Amministratore | 60 Perry Street HP22 6DJ Wendover Buckinghamshire | United Kingdom | British | Company Director | 97196330001 | ||||||||||||
MEHTA, Ashoni Kumar | Amministratore | 40 Tangier Road TW10 5DW Richmond Surrey | England | British | Accountant | 66703220001 | ||||||||||||
MORLEY, Harold | Amministratore | 43 Riverside One Albion Wharf Hester Road SW11 4AN London | British | Company Director | 23846940003 | |||||||||||||
NADIS, Daniel L | Amministratore | 30 Temple Grove NW11 7UA London | England | American | Executive | 106897980001 | ||||||||||||
ORBACH, Tuvi, Mr. | Amministratore | 5 Ravenscroft Avenue Golders Green NW11 0SA London | England | British | Company Director | 17074010001 | ||||||||||||
ORBACH, Tuvi, Mr. | Amministratore | 5 Ravenscroft Avenue Golders Green NW11 0SA London | England | British | Company Director | 17074010001 | ||||||||||||
WATSON, Bernard William, Professor | Amministratore | 60a Meadway AL5 1JL Harpenden Hertfordshire | British | Company Director | 4153620001 | |||||||||||||
WATSON, Bernard William, Professor | Amministratore | 60a Meadway AL5 1JL Harpenden Hertfordshire | British | Professor | 4153620001 | |||||||||||||
WAUCHOPE, Samuel Alan | Amministratore | Theydon Grove CM16 4QA Epping 90 Essex | United Kingdom | British | Company Director | 14283640001 |
ULTRASIS UK LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee and debenture | Creato il 28 gen 2013 Consegnato il 12 feb 2013 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 29 apr 1997 Consegnato il 09 mag 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 11 giu 1993 Consegnato il 15 giu 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date | |
Brevi particolari £5,000.00. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
ULTRASIS UK LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In amministrazione |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0